INBRAND UK LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | INBRAND UK LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02385367 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de INBRAND UK LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra INBRAND UK LIMITED?
| Dirección de la sede social | Building 9 Croxley Park Hatters Lane WD18 8WW Watford United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de INBRAND UK LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| HYGIEIA HEALTHCARE LIMITED | 29 dic 1989 | 29 dic 1989 |
| ADVANCED HYGIENE PRODUCTS LIMITED | 18 jul 1989 | 18 jul 1989 |
| TOLSTIR LIMITED | 17 may 1989 | 17 may 1989 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de INBRAND UK LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para INBRAND UK LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 4 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Estado de capital el 23 feb 2021
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 dic 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Mark Justin Elsey como director el 01 dic 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Davilynn Ann Erickson como director el 01 dic 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Joseph Power como director el 01 nov 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Jacqueline Fielding como director el 01 nov 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mrs Davilynn Ann Erickson el 14 jun 2019 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2019 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 8th Floor 20 Farringdon Street London EC4A 4AB United Kingdom a Building 9 Hatters Lane Watford WD18 8WW | 1 páginas | AD02 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 dic 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de C/O Tmf Corporate Administration Services Limited 5th Floor 6 st Andrew Street London EC4A 3AE United Kingdom a 8th Floor 20 Farringdon Street London EC4A 4AB | 1 páginas | AD02 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Justin Elsey como director el 01 abr 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2018 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||
Nombramiento de Mrs Davilynn Ann Erickson como director el 01 abr 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 dic 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2017 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 dic 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2016 con actualizaciones | 7 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada C/O Tmf Corporate Administration Services Limited 5th Floor 6 st Andrew Street London EC4A 3AE | 1 páginas | AD03 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de INBRAND UK LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELSEY, Mark Justin | Director | Croxley Park Hatters Lane WD18 8WW Watford Building 9 United Kingdom | England | British | 166448770001 | |||||
| POWER, Joseph | Director | Croxley Park Hatters Lane WD18 8WW Watford Building 9 United Kingdom | Ireland | Irish | 276026740001 | |||||
| WARE, Andrew | Secretario | Cauldwell Snows Green Road DH8 0NJ Shotley Bridge Durham | British | 110947260001 | ||||||
| WEST, David Roy | Secretario | 154 Fareham Road Gosport PO13 0AS Hampshire | British | 10831940003 | ||||||
| BLEBTA, Colin | Director | 11 Bishops Close BH7 7AB Bournemouth Dorset | England | British | 93805030001 | |||||
| BRENIKOV, Peter | Director | 12 Bloomsbury Court Gosforth NE3 4LW Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 71132960001 | ||||||
| COSTANTINO, Marco | Director | Parkway Whiteley PO15 7NY Fareham 4500 Hampshire United Kingdom | Italy | Italian | 183802780001 | |||||
| ELSEY, Mark Justin | Director | Croxley Park Hatters Lane WD18 8WW Watford Building 9 United Kingdom | England | British | 166448770001 | |||||
| ERICKSON, Davilynn Ann | Director | Croxley Park Hatters Lane WD18 8WW Watford Building 9 United Kingdom | England | American | 261950830001 | |||||
| FIELDING, Jacqueline | Director | Croxley Park Hatters Lane WD18 8WW Watford Building 9 United Kingdom | England | English | 218205980001 | |||||
| FORD, Thomas Peter Langmaid, Mr. | Director | Parkway Whiteley PO15 7NY Fareham 4500 Hampshire United Kingdom | Luxembourg | British | 162617380001 | |||||
| JOHNSON, James | Director | 2240 Merion Way 30156 Kennesaw Georgia Usa | American | 44778610001 | ||||||
| LLOYD DAVIES, John | Director | 45 Dukes Wood RG45 6NF Crowthorne Berkshire | British | 70365130001 | ||||||
| MILLET LOPEZ, Oriol | Director | Spring Lane Colden Common SO21 1SD Winchester 32 Hampshire United Kingdom | Spanish | 117789870002 | ||||||
| PATRICK, Anthony John | Director | 20 Belwell Lane Four Oaks B74 4AL Sutton Coldfield West Midlands | British | 19833240001 | ||||||
| REYNOLDS, Debra Margaret | Director | Parkway Whiteley PO15 7NY Fareham 4500 Hampshire United Kingdom | England | British | 136069300001 | |||||
| SETTEVIK, Tomas | Director | Bratenalleen 24-26 Oslo 0487 Norway | Norwegian | 72515790001 | ||||||
| SKEET, Barry John | Director | Tulip Tree House Mill Lane PO9 1RX Havant Hampshire | England | British | 80634300001 | |||||
| SMITH, Garnett | Director | 1170 Northmoor Ct Nw 30327 Atlanta Georgia 30327 Usa | American | 44769450001 | ||||||
| STEFANI, Michelangelo | Director | Parkway Whiteley PO15 7NY Fareham 4500 Hampshire | Luxembourg | Italian | 198540580001 | |||||
| SWINDELLS, Leslie Harvey | Director | 66 High Oaks Close Locks Heath SO31 6SX Southampton Hampshire | British | 57274820001 | ||||||
| TWEEDIE, Kenneth Lionel | Director | 1 Meadow View HA1 3DN Harrow | England | British | 77462930001 | |||||
| WARE, Andrew | Director | Cauldwell Snows Green Road DH8 0NJ Shotley Bridge Durham | United Kingdom | British | 110947260001 | |||||
| WELLS, David Patrick Austin | Director | Claremont Barn 4 Home Farm Close KT10 9HA Esher Surrey | British | 7059270001 | ||||||
| WEST, David Roy | Director | 154 Fareham Road Gosport PO13 0AS Hampshire | United Kingdom | British | 10831940003 | |||||
| WILKINSON, Colin | Director | 12 Carlton Avenue Newsham NE24 4AP Blyth Northumberland | British | 11231360001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de INBRAND UK LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inbrand Holdings Limited | 06 abr 2016 | Croxley Park Hatters Lane WD18 8WW Watford Building 9 Hertfordshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene INBRAND UK LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage | Creado el 30 sept 1993 Entregado el 04 oct 1993 | Pendiente | Cantidad garantizada £375,000 and all other monies due from the company to the chargee | |
Breve descripción One twin-track tampon production machine, model tc-6-type-2, machine no. 7832 supplied by k ruggli ag. One twin-track tampon production machine, model tc-6-type-2, machine no. 7830 supplied by k ruggli ag. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A credit agreement | Creado el 28 abr 1993 Entregado el 12 may 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £36604.60 due from the company to the chargee under the terms of the charge. | |
Breve descripción All its right title and interest to all sums payable under the insurance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage debenture | Creado el 20 abr 1990 Entregado el 04 may 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Charge by way of legal mortgage k/a:- unit of mercantile road, rainton bridge industrial estate houghton le spring, county durham. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0