LOVELL PARTNERSHIPS LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | LOVELL PARTNERSHIPS LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02387333 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | No |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de LOVELL PARTNERSHIPS LIMITED?
- Construcción de edificios domésticos (41202) / Construcción
¿Dónde se encuentra LOVELL PARTNERSHIPS LIMITED?
Dirección de la sede social | Kent House 14 - 17 Market Place W1W 8AJ London |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LOVELL PARTNERSHIPS LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
LOVELL PARTNERSHIP HOMES LIMITED | 28 jul 1995 | 28 jul 1995 |
LOVELL PARTNERSHIPS LIMITED | 23 oct 1991 | 23 oct 1991 |
LOVELL PARTNERSHIPS (EASTERN) LIMITED | 22 oct 1990 | 22 oct 1990 |
LOVELL PARTNERSHIP HOMES (EASTERN) LIMITED | 09 oct 1989 | 09 oct 1989 |
SAFEBUFF LIMITED | 22 may 1989 | 22 may 1989 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de LOVELL PARTNERSHIPS LIMITED?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2024 |
Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para LOVELL PARTNERSHIPS LIMITED?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 31 mar 2026 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 14 abr 2026 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 31 mar 2025 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para LOVELL PARTNERSHIPS LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Registro de la carga 023873330084, creada el 28 abr 2025 | 73 páginas | MR01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Helen Mary Mason como secretario el 22 abr 2025 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2025 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Registro de la carga 023873330083, creada el 11 mar 2025 | 22 páginas | MR01 | ||||||||||
Cancelación parcial de la carga 023873330074 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 023873330065 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 023873330063 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 25 nov 2024
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||
Registro de la carga 023873330081, creada el 23 oct 2024 | 7 páginas | MR01 | ||||||||||
Registro de la carga 023873330082, creada el 23 oct 2024 | 7 páginas | MR01 | ||||||||||
Registro de la carga 023873330080, creada el 24 oct 2024 | 30 páginas | MR01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Clare Sheridan como secretario el 27 jun 2024 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Helen Mary Mason como secretario el 27 jun 2024 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 023873330077 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 023873330070 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Registro de la carga 023873330079, creada el 09 may 2024 | 28 páginas | MR01 | ||||||||||
Nombramiento de Culdip Kelly Kaur Gangotra como director el 07 may 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Paul Crummett como director el 07 may 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 57 páginas | AA | ||||||||||
Cancelación total de la carga 023873330072 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 023873330075 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Registro de la carga 023873330078, creada el 31 ene 2024 | 23 páginas | MR01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 023873330073 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de LOVELL PARTNERSHIPS LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRESLIN, Steven Mark | Director | B78 3HN Tamworth Marston Park Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 184838470002 | ||||
COLEBY, Steve | Director | B78 3HN Tamworth Marston Park Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Managing Director | 148560140002 | ||||
ELLIOTT, Justine Samantha | Director | Bonehill Road B78 3HN Tamworth Marston Park Staffordshire United Kingdom | England | British | Sales Director | 121466340002 | ||||
GANGOTRA, Culdip Kelly Kaur | Director | Kent House 14-17 Market Place W1W 8AJ London C/O Morgan Sindall Group Plc United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 180304190002 | ||||
GOUGH, David Edward | Director | Bonehill Road Tamworth B78 3HN Staffordshire Marston Park United Kingdom | United Kingdom | British | Commercial Director | 195116550001 | ||||
MORGAN, John Christopher | Director | Kent House 14 - 17 Market Place W1W 8AJ London | England | British | Director | 7146080002 | ||||
DUNSMORE, James | Secretario | 1 Fernie Close Lichfield Road ST15 8YD Stone Staffordshire | British | Company Director | 33416520002 | |||||
JOHNSTON, William Raymond | Secretario | 9 Beverley Court 59 Fairfax Road NW6 4EG London | British | Company Secretary | 37227240001 | |||||
MASON, Helen Mary | Secretario | Kent House 14-17 Market Place W1W 8AJ London C/O Morgan Sindall Group Plc United Kingdom | 324689690001 | |||||||
NETTLESHIP, Isobel Mary | Secretario | Kent House 14 - 17 Market Place W1W 8AJ London | British | 147086990001 | ||||||
PRICE, Alan Martin Andrew | Secretario | 30 Offington Gardens BN14 9AU Worthing West Sussex | British | 5634100001 | ||||||
SHERIDAN, Clare | Secretario | Kent House 14 - 17 Market Place W1W 8AJ London | British | 74216410002 | ||||||
BISHOP, John Michael | Director | Orchard View Tintells Lane KT24 6JD West Horsley Surrey | England | British | Company Director | 116243840001 | ||||
CARLISLE, Edward | Director | 17 Swigert Close Hempshill Vale NG6 7AP Nottingham | British | Finance Director | 63224850001 | |||||
CODLING, Robert Eric | Director | Marston Park B78 3HN Tamworth Staffordshire | British | Finance Director | 71381970001 | |||||
CRUMMETT, Stephen Paul | Director | 14-17 Market Place W1W 8AJ London Kent House United Kingdom | England | British | Finance Director | 177741840001 | ||||
DAVENPORT, Ivor Stewart | Director | Bonehill Road B78 3HN Tamworth Marston Park Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 44015420004 | ||||
DEAN, Robert Howard | Director | High Lawn Lodge East Downs Road Bowdon WA14 2LG Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | Marketing Director | 55758580001 | ||||
DUNSMORE, James | Director | 1 Fernie Close Lichfield Road ST15 8YD Stone Staffordshire | British | Company Director | 33416520002 | |||||
GORING, Jonathan Charles Bradbury | Director | Bonehill Road B78 3HN Tamworth Marston Park Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Managing Director | 208781200001 | ||||
HEPPELL, David Henderson | Director | 4 Hill Place Farnham Common SL2 3EW Slough | British | Company Director | 45149820001 | |||||
JOHNSTON, William Raymond | Director | 9 Beverley Court 59 Fairfax Road NW6 4EG London | British | Chartered Secretary | 37227240001 | |||||
JOHNSTON, William Raymond | Director | 9 Beverley Court 59 Fairfax Road NW6 4EG London | British | Company Secretary | 37227240001 | |||||
JONES, Marcus Faughey | Director | B78 3HN Tamworth Marston Park Staffordshire | England | British | Finance Director | 69189090002 | ||||
LEARY, John Christopher | Director | Marston Park B78 3HN Tamworth Staffordshire | England | British | Commercial Director | 162123350002 | ||||
LEWIS, Mark Andrew | Director | Bonehill Road B78 3HN Tamworth Marston Park Staffordshire United Kingdom | England | British | Finance Director | 135597890002 | ||||
LYNCH, Mary | Director | 22 Westleigh Drive BR1 2PN Bickley Kent | British | Strategy Director | 104638930001 | |||||
MCCORMACK, Gerard Joseph | Director | 16 Rectory Road RG40 1DH Wokingham Berkshire | England | British | Finance Director | 93405490001 | ||||
MILLER, George William Leonard | Director | The Gate House North Common Queens Road KT13 9DN Weybridge Surrey | British | Company Director | 36408020001 | |||||
MORGAN, John Christopher | Director | 2 Fishermans Bank Mudeford BH23 3NP Christchurch Dorset | United Kingdom | British | Company Director | 7146080001 | ||||
MULLIGAN, David Kevin | Director | Kent House 14 - 17 Market Place W1W 8AJ London | England | British | Chartered Accountant | 74215210003 | ||||
ODLING, Antony William | Director | 132 Widney Manor Road B91 3JJ Solihull West Midlands | British | Company Director | 71822590001 | |||||
QUINE, Philip Frederick | Director | 6 Stonecross Drive Rainhill L35 6DD Prescot Merseyside | British | Company Director | 67704900001 | |||||
QUINN, Peter Anthony | Director | B78 3HN Tamworth Marston Park Staffordshire United Kingdom | England | English | Business Development Director | 167797180001 | ||||
REES, David Alun | Director | Sykes Holt Plough Lane Christleton CH3 7BA Chester | British | Company Director | 12760480002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de LOVELL PARTNERSHIPS LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Sindall Group Plc | 06 abr 2016 | 14-17 Market Place W1W 8AJ London Kent House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0