GIBB HOLDINGS LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGIBB HOLDINGS LTD
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02387714
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GIBB HOLDINGS LTD?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra GIBB HOLDINGS LTD?

    Dirección de la sede social
    Cottons Centre
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GIBB HOLDINGS LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GIBB LIMITED18 sept 198918 sept 1989
    CHULSAVALE LIMITED22 may 198922 may 1989

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GIBB HOLDINGS LTD?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta01 oct 2021

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GIBB HOLDINGS LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Nombramiento de Mr Geoffrey Roberts como secretario el 21 ago 2023

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Rhona Mary Holman como secretario el 21 ago 2023

    1 páginasTM02

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Estado de capital el 29 jun 2023

    • Capital: GBP 0.40412
    5 páginasSH19

    legacy

    2 páginasSH20

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Nombramiento de Rhona Mary Holman como secretario el 10 feb 2023

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Tejender Singh Chaudhary como secretario el 10 feb 2023

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 20 ene 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mrs Katherine Helen Kenny como director el 15 dic 2022

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Hugh Donald Morrison como director el 15 dic 2022

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 01 oct 2021

    24 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 20 ene 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 02 oct 2020

    26 páginasAA

    Nombramiento de Mrs Sally Miles como director el 11 ago 2021

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Guy Douglas como director el 11 ago 2021

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 20 ene 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2019

    26 páginasAA

    Cese del nombramiento de Jonathan R. Shattock como director el 30 nov 2020

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Hugh Donald Morrison como director el 30 nov 2020

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del director Mr Guy Douglas el 17 dic 2020

    2 páginasCH01

    Modification des détails de Jacobs Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 nov 2020

    2 páginasPSC05

    ¿Quiénes son los directivos de GIBB HOLDINGS LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ROBERTS, Geoffrey
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Secretario
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    312725290001
    KENNY, Katherine Helen
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Director
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish216980410001
    MILES, Sally Linda Joyce
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Director
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    EnglandBritish161125950001
    CHAUDHARY, Tejender Singh
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Secretario
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    246698880001
    HOLMAN, Rhona Mary
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Secretario
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    305629180001
    MARKLEY, William Clyde
    2105 Sunnybank Drive
    La Canada
    91011 Flintridge
    California
    United States Of America
    Secretario
    2105 Sunnybank Drive
    La Canada
    91011 Flintridge
    California
    United States Of America
    American57955380001
    NORRIS, Michael Timothy
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretario
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    British52563600002
    UDOVIC, Michael Sean
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretario
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    165335900001
    WARD, Sandra Lesley
    17 Clayfields
    HP10 8AT Tylers Green
    Bucks
    Secretario
    17 Clayfields
    HP10 8AT Tylers Green
    Bucks
    British89320390001
    WITHERS, Graham Reginald
    33 Ryhill Way
    Lower Earley
    RG6 4AZ Reading
    Berkshire
    Secretario
    33 Ryhill Way
    Lower Earley
    RG6 4AZ Reading
    Berkshire
    British1420080001
    BACK, Paul Adrian Auchmuty, Dr
    Parsonage Farm
    How Lane
    SL6 3JP White Waltham
    Berkshire
    Director
    Parsonage Farm
    How Lane
    SL6 3JP White Waltham
    Berkshire
    British22932520001
    BARBER, Walter Charles
    61 Riverside House
    Bear Wharf Fobney Street
    RG1 6BJ Reading
    Berkshire
    Director
    61 Riverside House
    Bear Wharf Fobney Street
    RG1 6BJ Reading
    Berkshire
    American93663320001
    BOWCOCK, John Brown
    Lothlorien
    Crowsley Road
    RG9 3JU Shiplake
    Oxfordshire
    Director
    Lothlorien
    Crowsley Road
    RG9 3JU Shiplake
    Oxfordshire
    British34950050001
    BRETTELL, Peter Donald
    Blorenge Cottage
    Holly Lane Ashampstead
    RG8 8RT Reading
    Berkshire
    Director
    Blorenge Cottage
    Holly Lane Ashampstead
    RG8 8RT Reading
    Berkshire
    British34455550003
    BRICE, Geoffrey John
    3 Orwell Close
    Caversham
    RG4 7PU Reading
    Berkshire
    Director
    3 Orwell Close
    Caversham
    RG4 7PU Reading
    Berkshire
    British7239880001
    COATES, Geoffrey Hamilton
    The Shealing
    Backsideans Wargrave-On-Thames
    RG10 8JP Reading
    Berkshire
    Director
    The Shealing
    Backsideans Wargrave-On-Thames
    RG10 8JP Reading
    Berkshire
    British1420060001
    COLES, Bruce Charles
    703 Henley Fields Circle
    FOREIGN Duluth
    Georgia 30155
    Usa
    Director
    703 Henley Fields Circle
    FOREIGN Duluth
    Georgia 30155
    Usa
    American49990460001
    DANGER, James Ivan
    2694 Northbrook Drive
    Atlanta
    FOREIGN Georgia 30340
    Usa
    Director
    2694 Northbrook Drive
    Atlanta
    FOREIGN Georgia 30340
    Usa
    American43472160001
    DAWSON, James Grant Forbes
    Woodpeckers
    Pangbourne Hill
    RG8 8JS Pangbourne
    Berkshire
    Director
    Woodpeckers
    Pangbourne Hill
    RG8 8JS Pangbourne
    Berkshire
    British32689240001
    DOUGLAS, Guy
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Director
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish258025190001
    DOYLE, John Conor
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandIrish78009780001
    DUFF, Robert Shepherd
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    ScotlandBritish165632810001
    ELLIS, David
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    Director
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United KingdomBritish206422550001
    FOOSHEE, Robert Brown
    9000 Etching Overlook Drive
    FOREIGN Duluth
    Georgia 30097
    Usa
    Director
    9000 Etching Overlook Drive
    FOREIGN Duluth
    Georgia 30097
    Usa
    American49990480001
    HENNESSEY, John Richard
    Folly Farm
    Barkham Road
    RG11 4BS Wokingham
    Berkshire
    Director
    Folly Farm
    Barkham Road
    RG11 4BS Wokingham
    Berkshire
    British22928530001
    IRVIN, Robert Anthony Michael
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish161055320001
    JONES, Graham Roger
    Coningsby 81 The Rise
    TN13 1RN Sevenoaks
    Kent
    Director
    Coningsby 81 The Rise
    TN13 1RN Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish42069750001
    MONTGOMERY, Michael Wayne
    Red Fox Cottage
    Old Bath Road Sonning
    RG4 0TA Reading
    Berkshire
    Director
    Red Fox Cottage
    Old Bath Road Sonning
    RG4 0TA Reading
    Berkshire
    American32725930002
    MORRISON, Hugh Donald
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Director
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish240150920001
    SEHGAL, Raghbir Kumar
    55 Cliffside Crossing
    Atlanta
    Georgia Ga 30338
    Usa
    Director
    55 Cliffside Crossing
    Atlanta
    Georgia Ga 30338
    Usa
    American32725940001
    SHATTOCK, Jonathan R.
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Director
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish259549880001
    STANCOMBE, Christopher John
    8 Wellington Gardens
    Southend Bradfield
    RG7 6EJ Reading
    Berkshire
    Director
    8 Wellington Gardens
    Southend Bradfield
    RG7 6EJ Reading
    Berkshire
    EnglandBritish33841950002
    STEINBRENNER, Frederick James
    5707 Brynwood Circle
    30101 Georgia
    Usa
    Director
    5707 Brynwood Circle
    30101 Georgia
    Usa
    American7239910004
    TAYLOR, Allyn Byram
    Mill Lane
    Cookham
    SL6 9QT Maidenhead
    Formosa Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Mill Lane
    Cookham
    SL6 9QT Maidenhead
    Formosa Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandUnited States124922150002
    WALKER, William Allen
    3345 Robinson Farms Court
    Marietta
    FOREIGN Atlanta
    Georgia Ga 30068
    Usa
    Director
    3345 Robinson Farms Court
    Marietta
    FOREIGN Atlanta
    Georgia Ga 30068
    Usa
    American15467690004

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de GIBB HOLDINGS LTD?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Jacobs Uk Limited
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland Companies Registry
    Número de registro02594504
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene GIBB HOLDINGS LTD alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deed of rectification and supplemental charge
    Creado el 03 nov 1995
    Entregado el 22 nov 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    13% of the issued share capital of prointec sa being: 300,000 pesetas............................13 Common stock of pesetas,100,000 numbered 8-18 and 21 and 94; all stocks,shares,bonds,debentures,notes...etc..........all dividends/other income and all rights,benefits,money or property..................all repayments of principal on loan notes.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Suntrust Bank,Atlanta
    Transacciones
    • 22 nov 1995Registro de un cargo (395)
    • 31 ene 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creado el 13 oct 1995
    Entregado el 18 oct 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 18 oct 1995Registro de un cargo (395)
    • 31 ene 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over shares
    Creado el 11 oct 1995
    Entregado el 18 oct 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to suntrust bank,atlanta for itself and as agent and trustee on behalf of the lenders (as defined)to each lender in any currency and whether or not the lender in question shall have been a party to the original transaction except any money or liabilities due by any company as guarantor for the depositor
    Breve descripción
    The securities all dividends distributions interest and other income all accretions of a capital nature and all capital sums received. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Suntrust Bank Atlanta
    Transacciones
    • 18 oct 1995Registro de un cargo (395)
    • 31 ene 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    First charge
    Creado el 08 oct 1993
    Entregado el 13 oct 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities (i)of law companies group,inc.to trust company bank and other banks under a credit agreement dated 8 october 1993 (us$42,000,000 together with interest,charges and costs)(ii)of law companies group,inc.to trust company bank under a reimbursement agreement dated 8 october 1993 (all amounts due under letters of credit issued by trust company bank)(iii)of law companies group,inc.and sir alexander gibb & partners limited to barclays bank PLC under a facility letter dated 8 october 1993 (£16,900,000 together with interest charges and costs)(iv)of gibb limited to barclays bank PLC under a commercial mortgage facility letter dated 8 february 1990 (£495,900 together with interest charges and costs) and (v)the obligations of certain partnerships and companies defined as sir alexander gibb partnerships to barclays bank PLC (£2,000,000 together with interest,charges and costs)and amounts due under the indemnity contained in clause 15.3 of the first charge
    Breve descripción
    2,217,800 shares of £1 each in sir alexander gibb & partners limited together with any substituted or additional shares or other securities and further including all allotments,accretions,offers,voting or other rights.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Trust Company Bankertain Other Banksas Collateral Agent and Trustee for Itself and C
    Transacciones
    • 13 oct 1993Registro de un cargo (395)
    • 05 feb 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 02 mar 1990
    Entregado el 07 mar 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Flat 5, 2 hyde park street, london W2. Title no. Ngl 617261.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 07 mar 1990Registro de una carga
    • 31 ene 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 22 ago 1989
    Entregado el 24 ago 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transacciones
    • 24 ago 1989Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0