EX HAMPS DEAC LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaEX HAMPS DEAC LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02396152
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de EX HAMPS DEAC LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra EX HAMPS DEAC LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Portland
    25 High Street
    RH10 1BG Crawley
    West Sussex
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de EX HAMPS DEAC LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    DEACON INSURANCE SERVICES LIMITED16 jun 198916 jun 1989

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de EX HAMPS DEAC LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2011

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para EX HAMPS DEAC LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para EX HAMPS DEAC LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    17 páginas4.71

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 05 nov 2014

    12 páginas4.68

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación

    LRESSP

    Cese del nombramiento de Ian Sutherland como director

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de * Third Floor Sunley House Bedford Park Croydon CR0 2AP* el 14 nov 2013

    2 páginasAD01

    Nombramiento de Ian Ronald Sutherland como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Ian Sutherland como director

    1 páginasTM01

    Exercice comptable précédent raccourci du 31 dic 2012 au 30 dic 2012

    2 páginasAA01

    Exercice comptable en cours raccourci du 31 dic 2013 au 30 dic 2013

    3 páginasAA01

    Cese del nombramiento de Michael Ramsey como director

    1 páginasTM01

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed deacon insurance services LIMITED\certificate issued on 03/06/13
    2 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name03 jun 2013

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 01 may 2013

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    Nombramiento de Kevin Michael Withington como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 11 may 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital31 may 2013

    Estado de capital el 31 may 2013

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    7 páginasAA

    Cese del nombramiento de David Oliver como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Michael Francis Ramsey como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 11 may 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Ian Ronald Sutherland el 21 nov 2011

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Ian Ronald Sutherland como director

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 11 may 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de EX HAMPS DEAC LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    YE, Christina Hong
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    Secretario
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    British133681410001
    WITHINGTON, Kevin Michael
    25 High Street
    RH10 1BG Crawley
    Portland
    West Sussex
    Director
    25 High Street
    RH10 1BG Crawley
    Portland
    West Sussex
    EnglandEnglish178721390001
    ATHERTON, Andrew James
    Beauchamp
    Westover Road Milford On Sea
    SO41 0PW Lymington
    Hampshire
    Secretario
    Beauchamp
    Westover Road Milford On Sea
    SO41 0PW Lymington
    Hampshire
    British148270340001
    BALDWIN, Nicholas Charles
    80 Pilford Heath Road
    BH21 2ND Wimborne
    Dorset
    Secretario
    80 Pilford Heath Road
    BH21 2ND Wimborne
    Dorset
    British57752860001
    BELLIS, Juliet Mary Susan
    4 Grange Hill
    SE25 6SX London
    Secretario
    4 Grange Hill
    SE25 6SX London
    British69991160002
    DAVIS, Nigel Peter
    66 Redway Drive
    TW2 7NW Twickenham
    Middlesex
    Secretario
    66 Redway Drive
    TW2 7NW Twickenham
    Middlesex
    British93673010001
    DUCKER, Elaine
    9 Whincroft Drive
    Ferndown
    BH22 9LH Bournemouth
    Dorset
    Secretario
    9 Whincroft Drive
    Ferndown
    BH22 9LH Bournemouth
    Dorset
    British12261980001
    JOHNSON, Robin Simon
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    Secretario
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    British11498320001
    PALMER, Jeffrey Edward
    22 Catalina Close
    BH23 4JG Christchurch
    Dorset
    Secretario
    22 Catalina Close
    BH23 4JG Christchurch
    Dorset
    British82018950001
    ZEALE, Nadine Catherine
    12 The Brewery The Maltings
    Church Street
    TW18 4XH Staines
    Middlesex
    Secretario
    12 The Brewery The Maltings
    Church Street
    TW18 4XH Staines
    Middlesex
    British58435360001
    ZEALE, Richard John Alexander
    The Clive
    Croft Road,Neacroft
    BH23 8JS Christchurch
    Dorset
    Secretario
    The Clive
    Croft Road,Neacroft
    BH23 8JS Christchurch
    Dorset
    British22396670002
    ATHERTON, Andrew James
    Beauchamp
    Westover Road Milford On Sea
    SO41 0PW Lymington
    Hampshire
    Director
    Beauchamp
    Westover Road Milford On Sea
    SO41 0PW Lymington
    Hampshire
    United KingdomBritish148270340001
    BALDWIN, Nicholas Charles
    80 Pilford Heath Road
    BH21 2ND Wimborne
    Dorset
    Director
    80 Pilford Heath Road
    BH21 2ND Wimborne
    Dorset
    EnglandBritish57752860001
    BOYD, Iain Grant
    1 Highland View Close
    BH21 2QX Wimborne
    Dorset
    Director
    1 Highland View Close
    BH21 2QX Wimborne
    Dorset
    British51260620002
    CRAN, John Andrew George
    19 Countess Gardens
    BH7 7RR Bournemouth
    Dorset
    Director
    19 Countess Gardens
    BH7 7RR Bournemouth
    Dorset
    United KingdomBritish61456650002
    DAVIS, Nigel Peter
    6 Boundary Park
    KT13 9RR Weybridge
    Surrey
    Director
    6 Boundary Park
    KT13 9RR Weybridge
    Surrey
    EnglandBritish93673010002
    DAVIS, Paul Malcolm
    3 Church Close
    WD7 8BJ Radlett
    Hertfordshire
    Director
    3 Church Close
    WD7 8BJ Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritish30526830004
    DUCKER, David George Bartholomew
    43 Groenhof Wezembeek
    Oppen
    FOREIGN 1970 Brussels
    Belgium
    Director
    43 Groenhof Wezembeek
    Oppen
    FOREIGN 1970 Brussels
    Belgium
    British45548190004
    DUCKER, David George Bartholomew
    9 Whincroft Drive
    BH22 9LH Ferndon
    Bournemouth
    Director
    9 Whincroft Drive
    BH22 9LH Ferndon
    Bournemouth
    British45548190002
    GOODING, Jonathan Michael
    13 Albany Street
    NW1 4DX London
    Director
    13 Albany Street
    NW1 4DX London
    United KingdomBritish16684130002
    JENKINSON, Andrew Timothy
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    Director
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    United KingdomBritish74069620002
    LIPMAN, Larry Glenn
    12 Park St James
    Prince Albert Road
    NW8 7LE St Johns Wood
    Director
    12 Park St James
    Prince Albert Road
    NW8 7LE St Johns Wood
    EnglandBritish62622410007
    OLIVER, David Martin
    13 Kirklee Circus
    G12 0TW Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    13 Kirklee Circus
    G12 0TW Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish115764650001
    PALMER, Jeffrey Edward
    22 Catalina Close
    BH23 4JG Christchurch
    Dorset
    Director
    22 Catalina Close
    BH23 4JG Christchurch
    Dorset
    EnglandBritish82018950001
    PEJNOVIC, Tomislav
    18 B Winchester Road
    GU32 3BL Petersfield
    Hampshire
    Director
    18 B Winchester Road
    GU32 3BL Petersfield
    Hampshire
    United KingdomBritish204966490001
    PLUMB, Robert Henry Charles
    Uplands Cottage
    Whitchurch On Thames
    RG8 7HH Reading
    Director
    Uplands Cottage
    Whitchurch On Thames
    RG8 7HH Reading
    EnglandBritish20686100001
    PURKISS, Julie
    1 Headinglea
    5 The Avenue
    BH13 6AA Poole
    Dorset
    Director
    1 Headinglea
    5 The Avenue
    BH13 6AA Poole
    Dorset
    British99182850001
    RAMSEY, Michael Francis
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    Director
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United KingdomBritish80310620002
    SMITH, James Robert Drummond
    11 Wellesley Road
    CR0 2NW Croydon
    Caley Limited Phoenix House
    Surrey
    Director
    11 Wellesley Road
    CR0 2NW Croydon
    Caley Limited Phoenix House
    Surrey
    SpainBritish130443150001
    SUTHERLAND, Ian Ronald
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    Director
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    United KingdomBritish163582690001
    SUTHERLAND, Ian Ronald
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    Director
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    United KingdomBritish189660790001
    WILLIAMS, Neil Vaughan
    1 Richmond Place
    TN2 5JZ Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    1 Richmond Place
    TN2 5JZ Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish71561050001
    ZEALE, Richard John Alexander
    The Whittle
    24 Chewton Farm Road
    BH23 5QN Highcliffe
    Dorset
    Director
    The Whittle
    24 Chewton Farm Road
    BH23 5QN Highcliffe
    Dorset
    British22396670003

    ¿Tiene EX HAMPS DEAC LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Supplemental charge
    Creado el 02 ene 2008
    Entregado el 08 ene 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fifth floor offices, oxford house, oxford road, bournemouth t/no. DT64769.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC (Formerly Known as the Governor and Company of the Bank of Scotland)(the Security Trustee)
    Transacciones
    • 08 ene 2008Registro de un cargo (395)
    • 05 jun 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Group debenture
    Creado el 26 jul 2006
    Entregado el 03 ago 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Finance Parties(The Security Trustee)
    Transacciones
    • 03 ago 2006Registro de un cargo (395)
    • 05 jun 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 06 mar 2002
    Entregado el 14 mar 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC, as Security Trustee for the Secured Parties
    Transacciones
    • 14 mar 2002Registro de un cargo (395)
    • 03 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of accession relating to a composite guarantee and debenture dated 9TH november 1999 issued by the company
    Creado el 08 dic 1999
    Entregado el 18 dic 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All indebtedness, liabilities and obligations due or to become due to the chargee in any manner whatsoever by any group company pursuant to the guarantee or otherwise
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 18 dic 1999Registro de un cargo (395)
    • 03 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 22 dic 1998
    Entregado el 05 ene 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies obligations and liabilities owing or incurred from the company to the chargee under or pursuant to the facilities agreement of even date and/or the debenture
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bhf-Bank Ag
    Transacciones
    • 05 ene 1999Registro de un cargo (395)
    • 18 dic 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 12 sept 1994
    Entregado el 20 sept 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC,
    Transacciones
    • 20 sept 1994Registro de un cargo (395)
    • 13 jun 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene EX HAMPS DEAC LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    2
    FechaTipo
    04 feb 2016Fecha de disolución
    06 nov 2013Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    John Ariel
    Portland 25 High Street
    RH10 1BG Crawley
    West Sussex
    Profesional
    Portland 25 High Street
    RH10 1BG Crawley
    West Sussex
    Matthew Richard Meadley Wild
    3rd Floor One London Square
    Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford
    Profesional
    3rd Floor One London Square
    Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0