EX HAMPS DEAC LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | EX HAMPS DEAC LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02396152 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de EX HAMPS DEAC LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra EX HAMPS DEAC LIMITED?
| Dirección de la sede social | Portland 25 High Street RH10 1BG Crawley West Sussex |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de EX HAMPS DEAC LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| DEACON INSURANCE SERVICES LIMITED | 16 jun 1989 | 16 jun 1989 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de EX HAMPS DEAC LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2011 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para EX HAMPS DEAC LIMITED?
| Declaración anual |
|
|---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para EX HAMPS DEAC LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 17 páginas | 4.71 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 05 nov 2014 | 12 páginas | 4.68 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 2 páginas | 600 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 3 páginas | 4.70 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Ian Sutherland como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de * Third Floor Sunley House Bedford Park Croydon CR0 2AP* el 14 nov 2013 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de Ian Ronald Sutherland como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ian Sutherland como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Exercice comptable précédent raccourci du 31 dic 2012 au 30 dic 2012 | 2 páginas | AA01 | ||||||||||
Exercice comptable en cours raccourci du 31 dic 2013 au 30 dic 2013 | 3 páginas | AA01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Ramsey como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed deacon insurance services LIMITED\certificate issued on 03/06/13 | 2 páginas | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Aviso de cambio de nombre | 2 páginas | CONNOT | ||||||||||
Nombramiento de Kevin Michael Withington como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 11 may 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Oliver como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Michael Francis Ramsey como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 11 may 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Ian Ronald Sutherland el 21 nov 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Ian Ronald Sutherland como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 11 may 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de EX HAMPS DEAC LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YE, Christina Hong | Secretario | Bedford Park CR0 2AP Croydon Third Floor Sunley House United Kingdom | British | 133681410001 | ||||||
| WITHINGTON, Kevin Michael | Director | 25 High Street RH10 1BG Crawley Portland West Sussex | England | English | 178721390001 | |||||
| ATHERTON, Andrew James | Secretario | Beauchamp Westover Road Milford On Sea SO41 0PW Lymington Hampshire | British | 148270340001 | ||||||
| BALDWIN, Nicholas Charles | Secretario | 80 Pilford Heath Road BH21 2ND Wimborne Dorset | British | 57752860001 | ||||||
| BELLIS, Juliet Mary Susan | Secretario | 4 Grange Hill SE25 6SX London | British | 69991160002 | ||||||
| DAVIS, Nigel Peter | Secretario | 66 Redway Drive TW2 7NW Twickenham Middlesex | British | 93673010001 | ||||||
| DUCKER, Elaine | Secretario | 9 Whincroft Drive Ferndown BH22 9LH Bournemouth Dorset | British | 12261980001 | ||||||
| JOHNSON, Robin Simon | Secretario | 25 Thirlmere Road Muswell Hill N10 2DL London | British | 11498320001 | ||||||
| PALMER, Jeffrey Edward | Secretario | 22 Catalina Close BH23 4JG Christchurch Dorset | British | 82018950001 | ||||||
| ZEALE, Nadine Catherine | Secretario | 12 The Brewery The Maltings Church Street TW18 4XH Staines Middlesex | British | 58435360001 | ||||||
| ZEALE, Richard John Alexander | Secretario | The Clive Croft Road,Neacroft BH23 8JS Christchurch Dorset | British | 22396670002 | ||||||
| ATHERTON, Andrew James | Director | Beauchamp Westover Road Milford On Sea SO41 0PW Lymington Hampshire | United Kingdom | British | 148270340001 | |||||
| BALDWIN, Nicholas Charles | Director | 80 Pilford Heath Road BH21 2ND Wimborne Dorset | England | British | 57752860001 | |||||
| BOYD, Iain Grant | Director | 1 Highland View Close BH21 2QX Wimborne Dorset | British | 51260620002 | ||||||
| CRAN, John Andrew George | Director | 19 Countess Gardens BH7 7RR Bournemouth Dorset | United Kingdom | British | 61456650002 | |||||
| DAVIS, Nigel Peter | Director | 6 Boundary Park KT13 9RR Weybridge Surrey | England | British | 93673010002 | |||||
| DAVIS, Paul Malcolm | Director | 3 Church Close WD7 8BJ Radlett Hertfordshire | United Kingdom | British | 30526830004 | |||||
| DUCKER, David George Bartholomew | Director | 43 Groenhof Wezembeek Oppen FOREIGN 1970 Brussels Belgium | British | 45548190004 | ||||||
| DUCKER, David George Bartholomew | Director | 9 Whincroft Drive BH22 9LH Ferndon Bournemouth | British | 45548190002 | ||||||
| GOODING, Jonathan Michael | Director | 13 Albany Street NW1 4DX London | United Kingdom | British | 16684130002 | |||||
| JENKINSON, Andrew Timothy | Director | Bedford Park CR0 2AP Croydon Third Floor Sunley House United Kingdom | United Kingdom | British | 74069620002 | |||||
| LIPMAN, Larry Glenn | Director | 12 Park St James Prince Albert Road NW8 7LE St Johns Wood | England | British | 62622410007 | |||||
| OLIVER, David Martin | Director | 13 Kirklee Circus G12 0TW Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | 115764650001 | |||||
| PALMER, Jeffrey Edward | Director | 22 Catalina Close BH23 4JG Christchurch Dorset | England | British | 82018950001 | |||||
| PEJNOVIC, Tomislav | Director | 18 B Winchester Road GU32 3BL Petersfield Hampshire | United Kingdom | British | 204966490001 | |||||
| PLUMB, Robert Henry Charles | Director | Uplands Cottage Whitchurch On Thames RG8 7HH Reading | England | British | 20686100001 | |||||
| PURKISS, Julie | Director | 1 Headinglea 5 The Avenue BH13 6AA Poole Dorset | British | 99182850001 | ||||||
| RAMSEY, Michael Francis | Director | Bedford Park CR0 2AP Croydon Third Floor Sunley House | United Kingdom | British | 80310620002 | |||||
| SMITH, James Robert Drummond | Director | 11 Wellesley Road CR0 2NW Croydon Caley Limited Phoenix House Surrey | Spain | British | 130443150001 | |||||
| SUTHERLAND, Ian Ronald | Director | Bedford Park CR0 2AP Croydon Third Floor Sunley House United Kingdom | United Kingdom | British | 163582690001 | |||||
| SUTHERLAND, Ian Ronald | Director | Bedford Park CR0 2AP Croydon Third Floor Sunley House United Kingdom | United Kingdom | British | 189660790001 | |||||
| WILLIAMS, Neil Vaughan | Director | 1 Richmond Place TN2 5JZ Tunbridge Wells Kent | England | British | 71561050001 | |||||
| ZEALE, Richard John Alexander | Director | The Whittle 24 Chewton Farm Road BH23 5QN Highcliffe Dorset | British | 22396670003 |
¿Tiene EX HAMPS DEAC LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental charge | Creado el 02 ene 2008 Entregado el 08 ene 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fifth floor offices, oxford house, oxford road, bournemouth t/no. DT64769. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Group debenture | Creado el 26 jul 2006 Entregado el 03 ago 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 06 mar 2002 Entregado el 14 mar 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of accession relating to a composite guarantee and debenture dated 9TH november 1999 issued by the company | Creado el 08 dic 1999 Entregado el 18 dic 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All indebtedness, liabilities and obligations due or to become due to the chargee in any manner whatsoever by any group company pursuant to the guarantee or otherwise | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creado el 22 dic 1998 Entregado el 05 ene 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies obligations and liabilities owing or incurred from the company to the chargee under or pursuant to the facilities agreement of even date and/or the debenture | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage debenture | Creado el 12 sept 1994 Entregado el 20 sept 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene EX HAMPS DEAC LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0