LS TIMES SQUARE LIMITED

LS TIMES SQUARE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaLS TIMES SQUARE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02397775
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de LS TIMES SQUARE LIMITED?

    • Otro alquiler y explotación de bienes inmobiliarios propios o arrendados (68209) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra LS TIMES SQUARE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    100 Victoria Street
    SW1E 5JL London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LS TIMES SQUARE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    L.D. (VICTORIA) LIMITED25 ago 198925 ago 1989
    COPIERTRADE LIMITED22 jun 198922 jun 1989

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de LS TIMES SQUARE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para LS TIMES SQUARE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Application for strike off/company businessapplication for strike off/company business 22/11/2019
    RES13

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Estado de capital el 09 dic 2019

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cancelación total de la carga 6

    5 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 5

    4 páginasMR04

    Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2018

    15 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Louise Miller como director el 01 ene 2018

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Elizabeth Miles como director el 01 ene 2018

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2017

    15 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2017 con actualizaciones

    8 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Michael Arnaouti como director el 31 mar 2017

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Louise Miller como director el 01 mar 2017

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del director Mr Michael Arnaouti el 16 ene 2017

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Land Securities Management Services Limited el 10 ene 2017

    1 páginasCH02

    Cambio de datos del director Ls Director Limited el 10 ene 2017

    1 páginasCH02

    Cambio de datos del secretario Ls Company Secretaries Limited el 10 ene 2017

    1 páginasCH04

    Domicilio social registrado cambiado de 5 Strand London WC2N 5AF a 100 Victoria Street London SW1E 5JL el 10 ene 2017

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2016

    15 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de LS TIMES SQUARE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    LS COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro4365193
    159674790001
    MILES, Elizabeth
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Director
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor235498150001
    LAND SECURITIES MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Director corporativo
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro4156575
    74974580001
    LS DIRECTOR LIMITED
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Director corporativo
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro4299372
    133814600001
    CARRUTHERS, James Mcinally
    22 Audley Close
    Ansley Way St Ives
    PE27 6UJ Huntingdon
    Cambridgeshire
    Secretario
    22 Audley Close
    Ansley Way St Ives
    PE27 6UJ Huntingdon
    Cambridgeshire
    British41372470003
    DUDGEON, Peter Maxwell
    41 Links Road
    KT17 3PP Epsom
    Surrey
    Secretario
    41 Links Road
    KT17 3PP Epsom
    Surrey
    BritishCompany Secretary14674480002
    PAYNE, Ann Maria
    Willow Cottage
    Lambden Road, Pluckley
    TN27 0RB Ashford
    Kent
    Secretario
    Willow Cottage
    Lambden Road, Pluckley
    TN27 0RB Ashford
    Kent
    British72391440001
    ARNAOUTI, Michael
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Director
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary539040004
    BOURNE, Roger Graham
    Globe Cottage
    The Street
    TN29 0DZ Newchurch
    Kent
    Director
    Globe Cottage
    The Street
    TN29 0DZ Newchurch
    Kent
    BritishAccountant72391320001
    BRADY, John
    21 Barrydene Oakleigh Road North
    Whetstone
    N20 9HG London
    Director
    21 Barrydene Oakleigh Road North
    Whetstone
    N20 9HG London
    IrishCommodity Merchant10922700001
    CAPERTON, Roderick Lawrence
    Flat 6 156 Sloane Street
    SW1X 9AD London
    Director
    Flat 6 156 Sloane Street
    SW1X 9AD London
    United KingdomAmericanTrading Manager63440630002
    CARRUTHERS, James Mcinally
    High Beren House
    Dacre Lane Dacre
    HG3 4ES Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    High Beren House
    Dacre Lane Dacre
    HG3 4ES Harrogate
    North Yorkshire
    BritishFinance Director41372470004
    CORNWELL, Roger Eliot
    42 Brompton Square
    SW3 2AF London
    Director
    42 Brompton Square
    SW3 2AF London
    BritishChartered Accountant10487170001
    GILL, Christopher Marshall
    Strand
    WC2N 5AF London
    5
    United Kingdom
    Director
    Strand
    WC2N 5AF London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant133825020001
    HIDIER, Bernard Jean-Marie
    222a Portobello Road
    W11 1LJ London
    Director
    222a Portobello Road
    W11 1LJ London
    FrenchTreasurer80516310001
    MARTIN, Sean W
    55 Townshend Road
    NW8 6LJ London
    Director
    55 Townshend Road
    NW8 6LJ London
    AmericanManager81860190001
    MCINTOSH, Ian Stuart
    Court In Holmes
    Priory Road
    RH18 5HS Forest Row
    East Sussex
    Director
    Court In Holmes
    Priory Road
    RH18 5HS Forest Row
    East Sussex
    EnglandBritishCommodity Trader43610010003
    MILLER, Louise
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Director
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Secretary199935770001
    MOREY, Peter Alan
    Carbondale 161a St Johns Road
    TN4 9UP Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    Carbondale 161a St Johns Road
    TN4 9UP Tunbridge Wells
    Kent
    BritishInsurance Manager9726340001
    SUSSMAN, Jeffrey
    275 Central Park.W
    Apt 14b
    10024 New York
    Usa
    Director
    275 Central Park.W
    Apt 14b
    10024 New York
    Usa
    UsaAmericanDirector42194570001
    THOMAS, Robert Nigel
    7 Nightingale Road
    TW12 2HU Hampton
    Middlesex
    Director
    7 Nightingale Road
    TW12 2HU Hampton
    Middlesex
    BritishAccountant40630840001
    LAND SECURITIES MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    5 Strand
    WC2N 5AF London
    Director corporativo
    5 Strand
    WC2N 5AF London
    74974580001
    LAND SECURITIES PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED
    5 Strand
    WC2N 5AF London
    Director corporativo
    5 Strand
    WC2N 5AF London
    100069790001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de LS TIMES SQUARE LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalUnited Kingdom (England)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro4161239
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene LS TIMES SQUARE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Obligor accession deed
    Creado el 17 jun 2005
    Entregado el 22 jun 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any obligor secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Deutsche Trustee Company Limited (As Obligor Security Trustee) and Land Securities Capitalmarkets PLC (as Issuer)
    Transacciones
    • 22 jun 2005Registro de un cargo (395)
    • 06 jun 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage
    Creado el 17 jun 2005
    Entregado el 22 jun 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any obligor secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Times square 160-162 queen victoria street london t/no NGL248078. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Deutsche Trustee Company Limited (As Obligor Security Trustee)
    Transacciones
    • 22 jun 2005Registro de un cargo (395)
    • 06 jun 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 23 dic 2004
    Entregado el 23 dic 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Site previously k/a continental bank house 162 queen victoria street london, beneficial interest in a lease of the property k/a 160 queen victoria street and 8 st andrews hill (f/h t/no NGL131587) for details of further property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bayerische Landesbank (As Agent and Trustee for Each of the Finance Parties) London Branch
    Transacciones
    • 23 dic 2004Registro de un cargo (395)
    • 22 abr 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture between the company and bayerische landesbank girozentrale (acting through its london branch) as agent and trustee for the finance parties under (and as defined in) the credit agreement (the "agent")
    Creado el 23 may 2001
    Entregado el 07 jun 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligation and liabilities (whether actual or contingent, whether owed jointly, severally or in any other capacity whatsoever and whether originally incurred by an obligor or by some other person) of each obligor to the finance parties (or any of them) under each of the finance documents
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Bayerische Landesbank Girozentrale
    Transacciones
    • 07 jun 2001Registro de un cargo (395)
    • 24 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment of contract(s) by way of security
    Creado el 19 ene 1996
    Entregado el 24 ene 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the terms of any of the finance documents as defined and/or in connection with the loan facility or other financial accommodation from time to time granted and under the terms of the deed
    Breve descripción
    All its rights,title and interest in and to the contracts and arising under or pursuant to the contracts including (I) all monetary debts and claims.(ii) the benefit of all related rights and remedies. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Sumitomo Trust & Banking Co.,Limited
    Transacciones
    • 24 ene 1996Registro de un cargo (395)
    • 24 abr 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 30 ago 1989
    Entregado el 12 sept 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or each transferee (as defined in the loan agreement) to the chargee under the terms of a loan agreement dated 29.8.89 (as from time to time varied, extended or replaced) and the mortgage debenture
    Breve descripción
    Freehold property known as 162 queen victoria street london EC4 title no. Ngl 248078 specific charge all landlord's fixtures plant machinery vehicles computers and office and other equipment (excluding stock in trade of the company) (please see doc for full details). A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • The Sumitomo Trust & Banking Co. LTD.
    Transacciones
    • 12 sept 1989Registro de una carga
    • 24 abr 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0