MH VOKES AIR UK LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | MH VOKES AIR UK LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02400211 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MH VOKES AIR UK LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra MH VOKES AIR UK LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O Vokes Air Limited Farrington Road BB11 5SY Burnley Lancashire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MH VOKES AIR UK LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| VOKES AIR UK LIMITED | 26 ago 2008 | 26 ago 2008 |
| SPX VOKES LIMITED | 13 ene 2006 | 13 ene 2006 |
| MCLEOD RUSSEL INTERNATIONAL LIMITED | 03 ago 1998 | 03 ago 1998 |
| WHEWAY INTERNATIONAL LIMITED | 15 ago 1989 | 15 ago 1989 |
| VOWDIN LIMITED | 03 jul 1989 | 03 jul 1989 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MH VOKES AIR UK LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2013 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MH VOKES AIR UK LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de George Henry Black como director el 23 feb 2017 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Misceláneos Statemenbt of fact - name correction - mh vokes air uk LIMITED LIMITED - mh vokes air uk LIMITED | 1 páginas | MISC | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Aviso de cambio de nombre | 2 páginas | CONNOT | ||||||||||
Restauración por orden judicial | 4 páginas | AC92 | ||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed mann + hummel vokes air uk\certificate issued on 04/11/16 | páginas | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Segunda presentación de AR01 previamente entregado a Companies House elaborado el 12 oct 2014 | 16 páginas | RP04 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 12 oct 2014 avec liste complète des actionnaires | 15 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed vokes air uk LIMITED\certificate issued on 28/03/14 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Aviso de cambio de nombre | 2 páginas | CONNOT | ||||||||||
Nombramiento de Steffen Schneider como director | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Thomas Blomqvist como secretario | 2 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Thomas Blomqvist como director | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director George Henry Black el 19 oct 2013 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 12 oct 2013 avec liste complète des actionnaires | 14 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director George Henry Black el 19 oct 2012 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 12 oct 2012 avec liste complète des actionnaires | 14 páginas | AR01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de MH VOKES AIR UK LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHNEIDER, Steffen | Director | C/O Vokes Air Limited Farrington Road BB11 5SY Burnley Lancashire | Germany | German | 185882550001 | |||||
| BLOMQVIST, Thomas | Secretario | Stureparken 11 4th Floor Stockholm 114 26 Sweden | Swedish | 132005410001 | ||||||
| SOHAL, Balkar | Secretario | 5 North Park NG18 4PA Mansfield Nottinghamshire | British | 122186580001 | ||||||
| M.R. SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | C/O Vokes-Air Limited Farrington Road BB11 5SY Burnley Lancashire | 55567600012 | |||||||
| MR SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Suite 2, Hitching Court, Blacklands Way Abingdon Business Park OX14 1RG Abingdon Oxfordshire | 55567600003 | |||||||
| WHEWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Suite Two Hitching Court Blacklands Way Abingdon Business Par OX14 1RG Abingdon Oxfordshire | 39955810002 | |||||||
| BLACK, George Henry | Director | C/O Vokes Air Limited Farrington Road BB11 5SY Burnley Lancashire | Uk | British | 151256750002 | |||||
| BLOMQVIST, Thomas | Director | Stureparken 11 4th Floor Stockholm 114 26 Sweden | Swedish | 132005410001 | ||||||
| BOSWELL, Brian Peter | Director | Garden Cottage Hawford House Hawford WR3 7SQ Worcester Worcestershire | British | 52804120001 | ||||||
| BRICKER, Ross Benjamin | Director | 2401 Pioneer Road JI 60201 Evanston Illinios Ji 60201 Usa | Canadian | 105172080001 | ||||||
| COLE, Ian Robert | Director | 4 Knarsdale Close Lakeside DY5 3RF Brierley Hill West Midlands | British | 42980510001 | ||||||
| COTTON, Richard John | Director | 148 Myton Road CV34 6PR Warwick | England | British | 45397090001 | |||||
| DOHERTY, James Patrick | Director | 950 S E 82nd Street Road Ocala Florida 34480 | Irish | 105328280001 | ||||||
| FERRARI, Fabio | Director | Lot Chirouzanches 05240 La Salle Les Alps France | French | 132005120001 | ||||||
| FITCHFORD, Andrew Michael John | Director | The Old House The Green B94 5AJ Tanworth In Arden Warwickshire | British | 99141670001 | ||||||
| FROY, Robert Anthony Douglas | Director | 171 Defoe House Barbican EC2Y 8ND London | British | 35373020004 | ||||||
| GOPSILL, Michael Clement | Director | Wood Cottage Norton Road Iverley Stourbridge West Midlands | British | 32481900001 | ||||||
| HAZLEHURST, Ian James | Director | Malvern Park Farm Widney Manor Road B91 3JG Solihull West Midlands | British | 43476760001 | ||||||
| HODGSON, Geoffrey Phillip | Director | Canterbury Cottage Fox Pond Lane LE2 4RY Great Glen Leicestershire | British | 107483910001 | ||||||
| HUMPHREYS, Paul Justin | Director | The Wendy House 3 Elf Meadow Poulton GL7 5HQ Cirencester Gloucestershire | British | 33223550001 | ||||||
| JONES, Alan Martin | Director | 5 Firsway Wightwick WV6 8BJ Wolverhampton West Midlands | British | 47891670001 | ||||||
| KEARNEY, Christopher James | Director | 14675 Rudolph Dadey Drive Charlotte Nc2827749456 Usa | American | 85114770001 | ||||||
| LADENBERGER, Daniel Timothy | Director | 24 Portland Place Saint Louis Missouri 63108 Usa | American | 110032170001 | ||||||
| LEEK, James Anthony | Director | 8 Atherton Drive Wimbledon SW19 5LB London | British | 11293430001 | ||||||
| LILLY, Kevin Lucius | Director | 13515 Ballantyne Corporate Place NC 28277 Charlotte North Carolina Nc 28277 Usa | United States | American | 110636870001 | |||||
| MCGOWAN, John Peter | Director | Lantern House Abbotswood WR11 4NS Evesham Worcestershire | British | 62509010002 | ||||||
| O'LEARY, Patrick Joseph | Director | 6524 Chipstead Lane 28277 Charlotte North Carolina Nc 28277 Usa | United States | American | 61807850002 | |||||
| PETERSON, Andris | Director | Redlands Lower Town WR3 7RY Claines Worcestershire | American | 31642760001 | ||||||
| RADISCH, Klaus Ingo | Director | Weidendstrasse 36 Sonsbeck 47665 Germany | Germany | German | 121578410001 | |||||
| REILLY, Michael Andrew | Director | 2007 Channelstone Way NC 28104 Matthews Nc 28104 Usa | United States | American | 103500870001 | |||||
| RENZI, Anthony Andrew | Director | 5101 Sw 60th Street Road Ocala Florida 34474 Usa | American | 121578380001 | ||||||
| WALKER, Craig Allen | Director | Bruhnstrasse 2a FOREIGN 40225 Dusseldorf Germany | Usa | 109340980001 | ||||||
| WINOWIECKI, Ronald Lee | Director | 8707 Calumet Farms Drive Wexham Nc 28173 Usa | American | 95572300001 |
¿Tiene MH VOKES AIR UK LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental deed | Creado el 22 feb 1993 Entregado el 09 mar 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All moneys due or to become due from the company and/or any other obligors named therein to the chargee under the security trust deed,the financing agreement and the security documents as defined in this deed | |
Breve descripción All moneys,dividends and interest in respect of the shares. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Share pledge agreement | Creado el 18 ene 1993 Entregado el 02 feb 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or wheway secretarial services limited to the chargee under the terms of the pledge agreement (the "secured liabilities as defined) | |
Breve descripción By way of pledge 599 shares in appareils electriques et electoniques belges N.V. (see form 395 ref M93). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage of shares | Creado el 18 ene 1993 Entregado el 02 feb 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the beneficiaries (as defined), under the facilities documents and/or the security documents (as defined) or any of them | |
Breve descripción All the companys right title and interest in and to and under the presentshares the acquired shares and the new rights the deposited shares (see form 395REF M95). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Pledge agreement | Creado el 18 ene 1993 Entregado el 02 feb 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee dated 22/12/92 | |
Breve descripción The pledged shares divends cash instruments chattel paper and other rights property or proceeds.see form 395 for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Pledge agreement | Creado el 18 ene 1993 Entregado el 02 feb 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a security trust deed dated 22/12/92 | |
Breve descripción 25,994 shares in climavent-cadi S.a and any other shares or seurities.see form 395 for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creado el 22 dic 1992 Entregado el 07 ene 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the beneficiaries (as defined) under the financing agreement dated 22ND december 1992 and/or the security documents(as defined) or any of them | |
Breve descripción See doc ref M79 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0