MH VOKES AIR UK LIMITED

MH VOKES AIR UK LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMH VOKES AIR UK LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02400211
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MH VOKES AIR UK LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra MH VOKES AIR UK LIMITED?

    Dirección de la sede social
    C/O Vokes Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MH VOKES AIR UK LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    VOKES AIR UK LIMITED26 ago 200826 ago 2008
    SPX VOKES LIMITED13 ene 200613 ene 2006
    MCLEOD RUSSEL INTERNATIONAL LIMITED03 ago 199803 ago 1998
    WHEWAY INTERNATIONAL LIMITED15 ago 198915 ago 1989
    VOWDIN LIMITED03 jul 198903 jul 1989

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MH VOKES AIR UK LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2013

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MH VOKES AIR UK LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de George Henry Black como director el 23 feb 2017

    2 páginasTM01

    Misceláneos

    Statemenbt of fact - name correction - mh vokes air uk LIMITED LIMITED - mh vokes air uk LIMITED
    1 páginasMISC

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 10 ago 2016

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    Restauración por orden judicial

    4 páginasAC92

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed mann + hummel vokes air uk\certificate issued on 04/11/16
    páginasCERTNM
    Anotaciones
    FechaAnotación
    09 nov 2016Clarification changed its name on 04/11/2016 to MH VOKES AIR UK LIMITED and not the name MH VOKES AIR UK LIMITED LIMITED as incorrectly shown on the face of the certificate of change of name issued on that date.

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Segunda presentación de AR01 previamente entregado a Companies House elaborado el 12 oct 2014

    16 páginasRP04

    Déclaration annuelle établie au 12 oct 2014 avec liste complète des actionnaires

    15 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital21 oct 2014

    Estado de capital el 21 oct 2014

    • Capital: GBP 10,000,001
    SH01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    11 nov 2014Clarification A second filed AR01 was registered on 11/11/2014

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    16 páginasAA

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed vokes air uk LIMITED\certificate issued on 28/03/14
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name28 mar 2014

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 04 mar 2014

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    Nombramiento de Steffen Schneider como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Thomas Blomqvist como secretario

    2 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Thomas Blomqvist como director

    2 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    16 páginasAA

    Cambio de datos del director George Henry Black el 19 oct 2013

    3 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 12 oct 2013 avec liste complète des actionnaires

    14 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 oct 2013

    Estado de capital el 18 oct 2013

    • Capital: GBP 10,000,001
    SH01

    Cambio de datos del director George Henry Black el 19 oct 2012

    3 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 12 oct 2012 avec liste complète des actionnaires

    14 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de MH VOKES AIR UK LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SCHNEIDER, Steffen
    C/O Vokes Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    Director
    C/O Vokes Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    GermanyGerman185882550001
    BLOMQVIST, Thomas
    Stureparken 11 4th Floor
    Stockholm 114 26
    Sweden
    Secretario
    Stureparken 11 4th Floor
    Stockholm 114 26
    Sweden
    Swedish132005410001
    SOHAL, Balkar
    5 North Park
    NG18 4PA Mansfield
    Nottinghamshire
    Secretario
    5 North Park
    NG18 4PA Mansfield
    Nottinghamshire
    British122186580001
    M.R. SERVICES LIMITED
    C/O Vokes-Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    Secretario corporativo
    C/O Vokes-Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    55567600012
    MR SERVICES LIMITED
    Suite 2, Hitching Court, Blacklands Way
    Abingdon Business Park
    OX14 1RG Abingdon
    Oxfordshire
    Secretario corporativo
    Suite 2, Hitching Court, Blacklands Way
    Abingdon Business Park
    OX14 1RG Abingdon
    Oxfordshire
    55567600003
    WHEWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Suite Two Hitching Court
    Blacklands Way Abingdon Business Par
    OX14 1RG Abingdon
    Oxfordshire
    Secretario corporativo
    Suite Two Hitching Court
    Blacklands Way Abingdon Business Par
    OX14 1RG Abingdon
    Oxfordshire
    39955810002
    BLACK, George Henry
    C/O Vokes Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    Director
    C/O Vokes Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    UkBritish151256750002
    BLOMQVIST, Thomas
    Stureparken 11 4th Floor
    Stockholm 114 26
    Sweden
    Director
    Stureparken 11 4th Floor
    Stockholm 114 26
    Sweden
    Swedish132005410001
    BOSWELL, Brian Peter
    Garden Cottage Hawford House
    Hawford
    WR3 7SQ Worcester
    Worcestershire
    Director
    Garden Cottage Hawford House
    Hawford
    WR3 7SQ Worcester
    Worcestershire
    British52804120001
    BRICKER, Ross Benjamin
    2401 Pioneer Road
    JI 60201 Evanston
    Illinios Ji 60201
    Usa
    Director
    2401 Pioneer Road
    JI 60201 Evanston
    Illinios Ji 60201
    Usa
    Canadian105172080001
    COLE, Ian Robert
    4 Knarsdale Close
    Lakeside
    DY5 3RF Brierley Hill
    West Midlands
    Director
    4 Knarsdale Close
    Lakeside
    DY5 3RF Brierley Hill
    West Midlands
    British42980510001
    COTTON, Richard John
    148 Myton Road
    CV34 6PR Warwick
    Director
    148 Myton Road
    CV34 6PR Warwick
    EnglandBritish45397090001
    DOHERTY, James Patrick
    950 S E 82nd Street Road
    Ocala
    Florida 34480
    Director
    950 S E 82nd Street Road
    Ocala
    Florida 34480
    Irish105328280001
    FERRARI, Fabio
    Lot Chirouzanches 05240
    La Salle Les Alps
    France
    Director
    Lot Chirouzanches 05240
    La Salle Les Alps
    France
    French132005120001
    FITCHFORD, Andrew Michael John
    The Old House
    The Green
    B94 5AJ Tanworth In Arden
    Warwickshire
    Director
    The Old House
    The Green
    B94 5AJ Tanworth In Arden
    Warwickshire
    British99141670001
    FROY, Robert Anthony Douglas
    171 Defoe House
    Barbican
    EC2Y 8ND London
    Director
    171 Defoe House
    Barbican
    EC2Y 8ND London
    British35373020004
    GOPSILL, Michael Clement
    Wood Cottage
    Norton Road Iverley
    Stourbridge
    West Midlands
    Director
    Wood Cottage
    Norton Road Iverley
    Stourbridge
    West Midlands
    British32481900001
    HAZLEHURST, Ian James
    Malvern Park Farm
    Widney Manor Road
    B91 3JG Solihull
    West Midlands
    Director
    Malvern Park Farm
    Widney Manor Road
    B91 3JG Solihull
    West Midlands
    British43476760001
    HODGSON, Geoffrey Phillip
    Canterbury Cottage
    Fox Pond Lane
    LE2 4RY Great Glen
    Leicestershire
    Director
    Canterbury Cottage
    Fox Pond Lane
    LE2 4RY Great Glen
    Leicestershire
    British107483910001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    The Wendy House 3 Elf Meadow
    Poulton
    GL7 5HQ Cirencester
    Gloucestershire
    Director
    The Wendy House 3 Elf Meadow
    Poulton
    GL7 5HQ Cirencester
    Gloucestershire
    British33223550001
    JONES, Alan Martin
    5 Firsway
    Wightwick
    WV6 8BJ Wolverhampton
    West Midlands
    Director
    5 Firsway
    Wightwick
    WV6 8BJ Wolverhampton
    West Midlands
    British47891670001
    KEARNEY, Christopher James
    14675 Rudolph Dadey Drive
    Charlotte
    Nc2827749456
    Usa
    Director
    14675 Rudolph Dadey Drive
    Charlotte
    Nc2827749456
    Usa
    American85114770001
    LADENBERGER, Daniel Timothy
    24 Portland Place
    Saint Louis
    Missouri 63108
    Usa
    Director
    24 Portland Place
    Saint Louis
    Missouri 63108
    Usa
    American110032170001
    LEEK, James Anthony
    8 Atherton Drive
    Wimbledon
    SW19 5LB London
    Director
    8 Atherton Drive
    Wimbledon
    SW19 5LB London
    British11293430001
    LILLY, Kevin Lucius
    13515 Ballantyne Corporate Place
    NC 28277 Charlotte
    North Carolina Nc 28277
    Usa
    Director
    13515 Ballantyne Corporate Place
    NC 28277 Charlotte
    North Carolina Nc 28277
    Usa
    United StatesAmerican110636870001
    MCGOWAN, John Peter
    Lantern House
    Abbotswood
    WR11 4NS Evesham
    Worcestershire
    Director
    Lantern House
    Abbotswood
    WR11 4NS Evesham
    Worcestershire
    British62509010002
    O'LEARY, Patrick Joseph
    6524 Chipstead Lane
    28277 Charlotte
    North Carolina Nc 28277
    Usa
    Director
    6524 Chipstead Lane
    28277 Charlotte
    North Carolina Nc 28277
    Usa
    United StatesAmerican61807850002
    PETERSON, Andris
    Redlands
    Lower Town
    WR3 7RY Claines
    Worcestershire
    Director
    Redlands
    Lower Town
    WR3 7RY Claines
    Worcestershire
    American31642760001
    RADISCH, Klaus Ingo
    Weidendstrasse 36
    Sonsbeck 47665
    Germany
    Director
    Weidendstrasse 36
    Sonsbeck 47665
    Germany
    GermanyGerman121578410001
    REILLY, Michael Andrew
    2007 Channelstone Way
    NC 28104 Matthews
    Nc 28104
    Usa
    Director
    2007 Channelstone Way
    NC 28104 Matthews
    Nc 28104
    Usa
    United StatesAmerican103500870001
    RENZI, Anthony Andrew
    5101 Sw 60th Street Road
    Ocala
    Florida 34474
    Usa
    Director
    5101 Sw 60th Street Road
    Ocala
    Florida 34474
    Usa
    American121578380001
    WALKER, Craig Allen
    Bruhnstrasse 2a
    FOREIGN 40225 Dusseldorf
    Germany
    Director
    Bruhnstrasse 2a
    FOREIGN 40225 Dusseldorf
    Germany
    Usa109340980001
    WINOWIECKI, Ronald Lee
    8707 Calumet Farms Drive
    Wexham
    Nc 28173
    Usa
    Director
    8707 Calumet Farms Drive
    Wexham
    Nc 28173
    Usa
    American95572300001

    ¿Tiene MH VOKES AIR UK LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Supplemental deed
    Creado el 22 feb 1993
    Entregado el 09 mar 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from the company and/or any other obligors named therein to the chargee under the security trust deed,the financing agreement and the security documents as defined in this deed
    Breve descripción
    All moneys,dividends and interest in respect of the shares.
    Personas con derecho
    • Midland Bank Plcas Security Trustee
    Transacciones
    • 09 mar 1993Registro de un cargo (395)
    • 23 dic 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Share pledge agreement
    Creado el 18 ene 1993
    Entregado el 02 feb 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or wheway secretarial services limited to the chargee under the terms of the pledge agreement (the "secured liabilities as defined)
    Breve descripción
    By way of pledge 599 shares in appareils electriques et electoniques belges N.V. (see form 395 ref M93).
    Personas con derecho
    • Midland Bank Plcthe "Pledgees" (As Defined)
    Transacciones
    • 02 feb 1993Registro de un cargo (395)
    • 23 dic 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage of shares
    Creado el 18 ene 1993
    Entregado el 02 feb 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the beneficiaries (as defined), under the facilities documents and/or the security documents (as defined) or any of them
    Breve descripción
    All the companys right title and interest in and to and under the presentshares the acquired shares and the new rights the deposited shares (see form 395REF M95).
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC as Security Trustee
    Transacciones
    • 02 feb 1993Registro de un cargo (395)
    • 23 dic 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Pledge agreement
    Creado el 18 ene 1993
    Entregado el 02 feb 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee dated 22/12/92
    Breve descripción
    The pledged shares divends cash instruments chattel paper and other rights property or proceeds.see form 395 for full details.
    Personas con derecho
    • Midland Bank Plcas Security Trustee
    Transacciones
    • 02 feb 1993Registro de un cargo (395)
    • 23 dic 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Pledge agreement
    Creado el 18 ene 1993
    Entregado el 02 feb 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a security trust deed dated 22/12/92
    Breve descripción
    25,994 shares in climavent-cadi S.a and any other shares or seurities.see form 395 for full details.
    Personas con derecho
    • Midland Bank Plcas Security Trustee
    Transacciones
    • 02 feb 1993Registro de un cargo (395)
    • 23 dic 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 22 dic 1992
    Entregado el 07 ene 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the beneficiaries (as defined) under the financing agreement dated 22ND december 1992 and/or the security documents(as defined) or any of them
    Breve descripción
    See doc ref M79 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Midland Bank Plcas "Security Trustee" for the Beneficiaries (Asdefined)
    Transacciones
    • 07 ene 1993Registro de un cargo (395)
    • 23 dic 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0