UTI WORLDWIDE (UK) LIMITED

UTI WORLDWIDE (UK) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaUTI WORLDWIDE (UK) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02402322
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de UTI WORLDWIDE (UK) LIMITED?

    • Operación de instalaciones de almacenamiento y depósito para actividades de transporte aéreo (52102) / Transporte y almacenamiento

    ¿Dónde se encuentra UTI WORLDWIDE (UK) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Third Floor Connexions Building
    159 Princes Street
    IP1 1QJ Ipswich
    Suffolk
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de UTI WORLDWIDE (UK) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    UNION AIR TRANSPORT LIMITED25 sept 198925 sept 1989
    BUFFMAL LIMITED10 jul 198910 jul 1989

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de UTI WORLDWIDE (UK) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 abr 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para UTI WORLDWIDE (UK) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    12 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 07 feb 2022

    12 páginasLIQ03

    Domicilio social registrado cambiado de Cardinal House 46 st Nicholas Street Ipswich Suffolk IP1 1TT a Third Floor Connexions Building 159 Princes Street Ipswich Suffolk IP1 1QJ el 24 ago 2021

    2 páginasAD01

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 07 feb 2021

    12 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 07 feb 2020

    10 páginasLIQ03

    Domicilio social registrado cambiado de Scandinavia House Refinery Road Harwich Essex CO12 4QG England a Cardinal House 46 st Nicholas Street Ipswich Suffolk IP1 1TT el 04 mar 2019

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    6 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 08 feb 2019

    LRESSP

    Declaración de confirmación presentada el 16 dic 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Jens Bjorn Andersen como director el 27 sept 2018

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Gary Maurice Ridsdale como director el 27 sept 2018

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Jens Hesselberg Lund como director el 27 sept 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Carsten Elmdal Trolle como director el 27 sept 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Michael Dyhre Hansen como director el 27 sept 2018

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 abr 2017

    33 páginasAA

    Cancelación total de la carga 4

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 5

    1 páginasMR04

    Declaración de confirmación presentada el 16 dic 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 abr 2016

    34 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 16 dic 2016 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Memorándum y Estatutos

    6 páginasMA

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01

    Exercice comptable précédent prolongé du 31 ene 2016 au 30 abr 2016

    1 páginasAA01

    ¿Quiénes son los directivos de UTI WORLDWIDE (UK) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    RIDSDALE, Gary Maurice
    159 Princes Street
    IP1 1QJ Ipswich
    Third Floor Connexions Building
    Suffolk
    Secretario
    159 Princes Street
    IP1 1QJ Ipswich
    Third Floor Connexions Building
    Suffolk
    204894490001
    RIDSDALE, Gary Maurice
    159 Princes Street
    IP1 1QJ Ipswich
    Third Floor Connexions Building
    Suffolk
    Director
    159 Princes Street
    IP1 1QJ Ipswich
    Third Floor Connexions Building
    Suffolk
    EnglandBritishFinance Director250889010001
    SICHAU, Klaus Otto
    9 Ely Close
    Paddock Hill
    GU16 9FB Frimley
    Surrey
    Secretario
    9 Ely Close
    Paddock Hill
    GU16 9FB Frimley
    Surrey
    German40677590002
    ALHEIT, Dieter
    Dieselstrasse 19
    Solingen D 5650
    Germany
    Director
    Dieselstrasse 19
    Solingen D 5650
    Germany
    GermanDirector20862430001
    ANDERSEN, Jens Bjorn
    Refinery Road
    CO12 4QG Harwich
    Scandinavia House
    Essex
    England
    Director
    Refinery Road
    CO12 4QG Harwich
    Scandinavia House
    Essex
    England
    DenmarkDanishChief Executive86707390004
    DIETER, Schenk Dr
    Gandersheimer Str 17
    Duesseldorf 31 4000
    Germany
    Director
    Gandersheimer Str 17
    Duesseldorf 31 4000
    Germany
    GermanDirector27411220001
    HALLISSEY, Steven Peter
    16 Sedgefield Close
    Sonning Common
    RG4 9TS Reading
    Berkshire
    Director
    16 Sedgefield Close
    Sonning Common
    RG4 9TS Reading
    Berkshire
    BritishFinancial Director110732160001
    HANSEN, Michael Dyhre
    Refinery Road
    CO12 4QG Harwich
    Scandinavia House
    Essex
    England
    Director
    Refinery Road
    CO12 4QG Harwich
    Scandinavia House
    Essex
    England
    EnglandDanishManaging Director170623520002
    HEXTALL, John Steers
    Thetford Burleigh Road
    SL5 7LE Ascot
    Berkshire
    Director
    Thetford Burleigh Road
    SL5 7LE Ascot
    Berkshire
    BritishDirector51174940002
    HOOEY, Anthony Grattan
    5 Greenways Drive
    Sunningdale
    SL5 9QS Ascot
    Berkshire
    Director
    5 Greenways Drive
    Sunningdale
    SL5 9QS Ascot
    Berkshire
    BritishExecutive Vice President25114150001
    HOWARTH, Neil Alexander
    8 Cairds Wynd
    AB31 5XU Banchory
    Aberdeenshire
    Director
    8 Cairds Wynd
    AB31 5XU Banchory
    Aberdeenshire
    BritishDirector86485360001
    HUGHES, David Owen
    4 Station Road
    Kintbury
    RG17 9UP Hungerford
    Berkshire
    Director
    4 Station Road
    Kintbury
    RG17 9UP Hungerford
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector2866910010
    JENKINS, Mark David James
    4b Church Road
    Cholsey
    OX10 9PP Wallingford
    Oxfordshire
    Director
    4b Church Road
    Cholsey
    OX10 9PP Wallingford
    Oxfordshire
    EnglandBritishVice President Logistics118809290001
    KEARNEY, Barbara
    54 Drumnigh Wood
    Portmarnock
    Co Dublin
    Ireland
    Director
    54 Drumnigh Wood
    Portmarnock
    Co Dublin
    Ireland
    IrelandIrishVice President138050130001
    KEELY, Julian Hugh
    2 Broadway
    SK9 1NB Wilmslow
    Cheshire
    Director
    2 Broadway
    SK9 1NB Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritishDirector57382310002
    KRAUS, Heinz Dieter
    Bruhler Strasse 291
    Koln 51
    Nordrhein-Westfalen 5000
    Germany
    Director
    Bruhler Strasse 291
    Koln 51
    Nordrhein-Westfalen 5000
    Germany
    GermanForwarding Agent27411230001
    LIEBENBERG, Robert Edward
    45 Top Common
    Warfield
    RG42 3SH Bracknell
    Berkshire
    Director
    45 Top Common
    Warfield
    RG42 3SH Bracknell
    Berkshire
    South AfricanIt Director57382760001
    LOGAN, Steven George
    The Air Cargo Centre / Arran Avenue
    Glasgow Airport
    PA3 2AY Paisley
    Building B
    Renfrewshire
    Scotland
    Director
    The Air Cargo Centre / Arran Avenue
    Glasgow Airport
    PA3 2AY Paisley
    Building B
    Renfrewshire
    Scotland
    Scotland / U.K.BritishRegional Director (Uk) North Region178330200001
    LORD, Stephen John William
    Southernhay Road
    LE2 3TP Leicester
    83
    Leicestershire
    United Kingdom
    Director
    Southernhay Road
    LE2 3TP Leicester
    83
    Leicestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector134469010001
    LUND, Jens Hesselberg
    Refinery Road
    CO12 4QG Harwich
    Scandinavia House
    Essex
    England
    Director
    Refinery Road
    CO12 4QG Harwich
    Scandinavia House
    Essex
    England
    DenmarkDanishFinancial Director181002220001
    LUSHINGTON, David Nelson
    166 Oxford Road
    OX14 2AF Abingdon
    Oxfordshire
    Director
    166 Oxford Road
    OX14 2AF Abingdon
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector36110630002
    MCCANN, Samantha Marie
    Solar Park
    Monkshall Industrial Park
    Solihull
    Unit 610
    West Midlands
    England
    Director
    Solar Park
    Monkshall Industrial Park
    Solihull
    Unit 610
    West Midlands
    England
    EnglandBritishSales Director Uk & Ireland178392700001
    MCKENNA, Richard Charles
    14 Oakwood Road
    GU20 6JD Windlesham
    Surrey
    Director
    14 Oakwood Road
    GU20 6JD Windlesham
    Surrey
    EnglandBritishDirector25923100001
    PHILLIPS, Robert William
    Meadsway Horton Road
    TW19 6BQ Staines
    Middlesex
    Director
    Meadsway Horton Road
    TW19 6BQ Staines
    Middlesex
    BritishCompany Director49450600001
    RONCO, Renee
    Refinery Road
    CO12 4QG Harwich
    Scandinavia House
    Essex
    England
    Director
    Refinery Road
    CO12 4QG Harwich
    Scandinavia House
    Essex
    England
    NetherlandsAmericanSenior Vice President Finance203116310001
    RYAN, Steven John
    Reading Cargo Centre
    Hyperion Way Rose Kiln Lane
    RG2 0JS Reading
    Berkshire
    Director
    Reading Cargo Centre
    Hyperion Way Rose Kiln Lane
    RG2 0JS Reading
    Berkshire
    Great BritainBritishSenior Vice President197330440001
    SCHUSTER, Karl
    Aprils End Penn Road
    HP9 2LW Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    Aprils End Penn Road
    HP9 2LW Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomGermanManaging Director20862440001
    SICHAU, Klaus Otto
    9 Ely Close
    Paddock Hill
    GU16 9FB Frimley
    Surrey
    Director
    9 Ely Close
    Paddock Hill
    GU16 9FB Frimley
    Surrey
    GermanCompany Secretary40677590002
    SMITH, Clinton
    4 Pickwell Close
    RG6 4EX Reading
    Berkshire
    Director
    4 Pickwell Close
    RG6 4EX Reading
    Berkshire
    South AfricanCharted Accountant85547810001
    THORRINGTON, Peter
    1544 Paseo Del Mar
    90274 Balos Verdes Esates
    California
    Usa
    Director
    1544 Paseo Del Mar
    90274 Balos Verdes Esates
    California
    Usa
    BritishFreight Agent36155440001
    TROLLE, Carsten Elmdal
    Refinery Road
    CO12 4QG Harwich
    Scandinavia House
    Essex
    England
    Director
    Refinery Road
    CO12 4QG Harwich
    Scandinavia House
    Essex
    England
    United StatesDanishManaging Director195300240001
    TURNER, Andrew Evan Paul
    5 Vicarage Court
    Church Lane Shinfield
    RG2 9HJ Reading
    Berkshire
    Director
    5 Vicarage Court
    Church Lane Shinfield
    RG2 9HJ Reading
    Berkshire
    EnglandBritishFinance Director111379060001
    VAN AALST, Daniel Jan
    Fokker Logistics Park
    Fokkerweg 300
    1438 AN Oude Meer
    Building 3a
    Netherlands
    Director
    Fokker Logistics Park
    Fokkerweg 300
    1438 AN Oude Meer
    Building 3a
    Netherlands
    NetherlandsDutchSenior Vice President - Northern Emena178331080001
    WHITE, James Feaks
    The Stables Hatchgate Farm
    Cold Ash
    RG16 9NY Newbury
    Berks
    Director
    The Stables Hatchgate Farm
    Cold Ash
    RG16 9NY Newbury
    Berks
    BritishDirector9644220001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de UTI WORLDWIDE (UK) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Dsv A/S
    Hovedgaden
    2640 Hedehusene
    630
    Denmark
    06 abr 2016
    Hovedgaden
    2640 Hedehusene
    630
    Denmark
    No
    Forma jurídicaLimited Liability Company
    País de registroDenmark
    Autoridad legalDanish Companies Act
    Lugar de registroDanish Company Register
    Número de registro58233528
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene UTI WORLDWIDE (UK) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Rent deposit deed
    Creado el 01 feb 2013
    Entregado el 12 feb 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The interest in the account and the proportion of the amount from time to time standing to the credit of the account including any accrued interest see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bilton PLC
    Transacciones
    • 12 feb 2013Registro de un cargo (MG01)
    • 20 feb 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Rent deposit deed
    Creado el 01 feb 2013
    Entregado el 12 feb 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The interest in the account and the proportion of the amount from time to time standing to the credit of the account including any accrued interest see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bilton PLC
    Transacciones
    • 12 feb 2013Registro de un cargo (MG01)
    • 20 feb 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of charge over credit balances
    Creado el 04 ene 1996
    Entregado el 11 ene 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A fixed charge over all the "deposit(s) being all sums of money in any currency in union air transport limited gts bid deposit account limited to £50,000 together with all interest from time to time accruing thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 11 ene 1996Registro de un cargo (395)
    • 21 jul 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 21 ago 1995
    Entregado el 29 ago 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Nedcor Bank Limited
    Transacciones
    • 29 ago 1995Registro de un cargo (395)
    • 21 jul 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 24 sept 1993
    Entregado el 04 oct 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 04 oct 1993Registro de un cargo (395)
    • 30 mar 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene UTI WORLDWIDE (UK) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    08 feb 2019Inicio de la liquidación
    24 abr 2023Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Mark Upton
    Cardinal House 46 St Nicholas Street
    IP1 1TT Ipswich
    Profesional
    Cardinal House 46 St Nicholas Street
    IP1 1TT Ipswich
    David Paul Scrivener
    Ensors Cardinal House
    46 St Nicholas Street
    IP1 1TT Ipswich
    Suffolk
    Profesional
    Ensors Cardinal House
    46 St Nicholas Street
    IP1 1TT Ipswich
    Suffolk

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0