G & G TRAVEL LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaG & G TRAVEL LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02406571
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de G & G TRAVEL LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra G & G TRAVEL LIMITED?

    Dirección de la sede social
    C/O Stagecoach Services Limited One Stockport Exchange
    20 Railway Road
    SK1 3SW Stockport
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de G & G TRAVEL LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SCOOPGLEN LIMITED20 jul 198920 jul 1989

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de G & G TRAVEL LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta02 may 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para G & G TRAVEL LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 01 may 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 02 may 2020

    4 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 may 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2019

    4 páginasAA

    Nombramiento de Karen Rosaleen Robbins como director el 31 may 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Colin Brown como director el 31 may 2019

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Bruce Dingwall como director el 31 may 2019

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 01 may 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2018

    4 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 may 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2017

    4 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de Daw Bank Stockport Cheshire SK3 0DU a C/O Stagecoach Services Limited One Stockport Exchange 20 Railway Road Stockport SK1 3SW el 16 nov 2017

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 01 may 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2016

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 may 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 may 2016

    Estado de capital el 04 may 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2015

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 may 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital05 may 2015

    Estado de capital el 05 may 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2014

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 may 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 may 2014

    Estado de capital el 06 may 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cambio de datos del director Mr Michael John Vaux el 20 mar 2014

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mr Michael John Vaux como director

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2013

    4 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de G & G TRAVEL LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    VAUX, Michael John
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Secretario
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    British137383880001
    DINGWALL, Bruce Maxwell
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Director
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish185252790001
    ROBBINS, Karen Rosaleen
    Chendre Close
    Hayfield
    SK22 2PH High Peak
    8
    Derbyshire
    England
    Director
    Chendre Close
    Hayfield
    SK22 2PH High Peak
    8
    Derbyshire
    England
    EnglandBritish73518280001
    VAUX, Michael John
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Director
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish137383880003
    DAVISON, Jeremy Robert
    34 Trendlewood Park
    BS16 1TE Bristol
    Secretario
    34 Trendlewood Park
    BS16 1TE Bristol
    British65096740001
    FULLER, Alan Charles
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    Secretario
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    British70283550001
    HEMMING, Christopher Thomas
    Bankura Stoke Road
    Bishops Cleeve
    GL52 7RT Cheltenham
    Gloucestershire
    Secretario
    Bankura Stoke Road
    Bishops Cleeve
    GL52 7RT Cheltenham
    Gloucestershire
    British17902220001
    STAITE, John Frederick
    30 Byfords Close
    Huntley
    GL19 3SA Gloucester
    Secretario
    30 Byfords Close
    Huntley
    GL19 3SA Gloucester
    British45931770001
    WHITNALL, Alan Leonard
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    Secretario
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    British54184420002
    BROWN, Colin
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Director
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish85970020003
    CARTER, Alex Paul
    The Hayes
    Stubbs Road Everdon
    NN11 3BN Daventry
    Northamptonshire
    Director
    The Hayes
    Stubbs Road Everdon
    NN11 3BN Daventry
    Northamptonshire
    British41601830001
    COCHRANE, Keith Robertson
    Glen Hall
    Belwood Park
    PH2 7AJ Perth
    Director
    Glen Hall
    Belwood Park
    PH2 7AJ Perth
    British47574960002
    COX, Anthony Geoffrey
    4 Keats Close
    Great Houghton
    NN4 7NX Northampton
    Northamptonshire
    Director
    4 Keats Close
    Great Houghton
    NN4 7NX Northampton
    Northamptonshire
    British70180950001
    COX, Brian John
    Kirknewton House
    Kirknewton
    NE71 6XF Wooler
    Northumberland
    Director
    Kirknewton House
    Kirknewton
    NE71 6XF Wooler
    Northumberland
    EnglandBritish1436830002
    DAVISON, Jeremy Robert
    34 Trendlewood Park
    BS16 1TE Bristol
    Director
    34 Trendlewood Park
    BS16 1TE Bristol
    British65096740001
    FULLER, Alan Charles
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    Director
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    EnglandBritish70283550001
    GLOAG, Ann Heron
    Kinfauns Castle
    PH2 7JZ Perth
    Perthshire
    Director
    Kinfauns Castle
    PH2 7JZ Perth
    Perthshire
    ScotlandBritish141120003
    GRIFFITHS, Martin Andrew
    Upland
    2 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Director
    Upland
    2 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    ScotlandBritish61722690002
    HILDITCH, Christopher Graham
    51 Hildene Ampleforth Drive
    The Meadows
    ST17 4TE Stafford
    Staffordshire
    Director
    51 Hildene Ampleforth Drive
    The Meadows
    ST17 4TE Stafford
    Staffordshire
    British10417870001
    HINKLEY, William Barry
    Mandalay
    Bassenthwaite
    CA12 4QG Keswick
    Cumbria
    Director
    Mandalay
    Bassenthwaite
    CA12 4QG Keswick
    Cumbria
    EnglandBritish2268190002
    HODGKINS, John Christopher
    10 Piers Close
    CV34 5HS Warwick
    Warwickshire
    Director
    10 Piers Close
    CV34 5HS Warwick
    Warwickshire
    British15371120001
    KINSKI, Michael John
    Cherry Tree House 268 Dunchurch Road
    CV22 6HX Rugby
    Warwickshire
    Director
    Cherry Tree House 268 Dunchurch Road
    CV22 6HX Rugby
    Warwickshire
    United KingdomBritish58643710001
    LYON, Inglis
    102 Lewis Road
    Radford Semele
    CV31 1UP Leamington Spa
    Warwickshire
    Director
    102 Lewis Road
    Radford Semele
    CV31 1UP Leamington Spa
    Warwickshire
    British72280120001
    RHYS-DAVIES, Mark Iorwedd
    10 Evesham Road
    GL52 2AB Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    10 Evesham Road
    GL52 2AB Cheltenham
    Gloucestershire
    British5652350001
    ROBBINS, Karen Rosaleen
    8 Chendre Close
    Hayfield
    SK22 2PH High Peak
    Derbyshire
    Director
    8 Chendre Close
    Hayfield
    SK22 2PH High Peak
    Derbyshire
    EnglandBritish73518280001
    SOUTER, Brian
    Murrayfield House
    St Magdalenes Road
    PH2 0BT Perth
    Perthshire
    Director
    Murrayfield House
    St Magdalenes Road
    PH2 0BT Perth
    Perthshire
    British1436810001
    STAITE, John Frederick
    30 Byfords Close
    Huntley
    GL19 3SA Gloucester
    Director
    30 Byfords Close
    Huntley
    GL19 3SA Gloucester
    United KingdomBritish45931770001
    THOMAS, Mark Richard
    The Quarry House
    Upper Lynch Road France Lynch
    GL6 8LZ Stroud
    Gloucestershire
    Director
    The Quarry House
    Upper Lynch Road France Lynch
    GL6 8LZ Stroud
    Gloucestershire
    British28914510001
    THOMAS, Norrie Russell
    Catherine Cottage Silver Street
    Chalford Hill
    GL6 8ES Stroud
    Gloucestershire
    Director
    Catherine Cottage Silver Street
    Chalford Hill
    GL6 8ES Stroud
    Gloucestershire
    EnglandBritish1447710001
    WARNEFORD, Leslie Brian
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Director
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish49771140004

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de G & G TRAVEL LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroScotland
    Autoridad legalUnited Kingdom (Scotland)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registroSc176671
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene G & G TRAVEL LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 28 abr 1992
    Entregado el 11 may 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 11 may 1992Registro de un cargo (395)
    • 17 dic 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 01 feb 1991
    Entregado el 07 feb 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the facility letter 1ST february 1991, this debenture or any other finance document (as defined).
    Breve descripción
    (See form 395. ref M224 for full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hill Samuel Bank Limited.
    Transacciones
    • 07 feb 1991Registro de una carga
    • 21 dic 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0