G & G TRAVEL LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | G & G TRAVEL LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02406571 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de G & G TRAVEL LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra G & G TRAVEL LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O Stagecoach Services Limited One Stockport Exchange 20 Railway Road SK1 3SW Stockport United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de G & G TRAVEL LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| SCOOPGLEN LIMITED | 20 jul 1989 | 20 jul 1989 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de G & G TRAVEL LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 02 may 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para G & G TRAVEL LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 may 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 02 may 2020 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 may 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2019 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Karen Rosaleen Robbins como director el 31 may 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Colin Brown como director el 31 may 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Bruce Dingwall como director el 31 may 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 may 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2018 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 may 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2017 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Daw Bank Stockport Cheshire SK3 0DU a C/O Stagecoach Services Limited One Stockport Exchange 20 Railway Road Stockport SK1 3SW el 16 nov 2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 may 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2016 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 may 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2015 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 may 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2014 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 may 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Michael John Vaux el 20 mar 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Michael John Vaux como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2013 | 4 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de G & G TRAVEL LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUX, Michael John | Secretario | 10 Dunkeld Road PH1 5TW Perth Stagecoach Group Plc Perthshire United Kingdom | British | 137383880001 | ||||||
| DINGWALL, Bruce Maxwell | Director | 10 Dunkeld Road PH1 5TW Perth Stagecoach Group Plc Perthshire United Kingdom | United Kingdom | British | 185252790001 | |||||
| ROBBINS, Karen Rosaleen | Director | Chendre Close Hayfield SK22 2PH High Peak 8 Derbyshire England | England | British | 73518280001 | |||||
| VAUX, Michael John | Director | 10 Dunkeld Road PH1 5TW Perth Stagecoach Group Plc Perthshire United Kingdom | United Kingdom | British | 137383880003 | |||||
| DAVISON, Jeremy Robert | Secretario | 34 Trendlewood Park BS16 1TE Bristol | British | 65096740001 | ||||||
| FULLER, Alan Charles | Secretario | Freshwater Cottage 2 Chapel Brow Charlesworth SK13 5HH Glossop Derbyshire | British | 70283550001 | ||||||
| HEMMING, Christopher Thomas | Secretario | Bankura Stoke Road Bishops Cleeve GL52 7RT Cheltenham Gloucestershire | British | 17902220001 | ||||||
| STAITE, John Frederick | Secretario | 30 Byfords Close Huntley GL19 3SA Gloucester | British | 45931770001 | ||||||
| WHITNALL, Alan Leonard | Secretario | 25 Millhill Drive Greenloaning FK15 0LS Dunblane Perthshire | British | 54184420002 | ||||||
| BROWN, Colin | Director | 10 Dunkeld Road PH1 5TW Perth Stagecoach Group Plc Perthshire United Kingdom | United Kingdom | British | 85970020003 | |||||
| CARTER, Alex Paul | Director | The Hayes Stubbs Road Everdon NN11 3BN Daventry Northamptonshire | British | 41601830001 | ||||||
| COCHRANE, Keith Robertson | Director | Glen Hall Belwood Park PH2 7AJ Perth | British | 47574960002 | ||||||
| COX, Anthony Geoffrey | Director | 4 Keats Close Great Houghton NN4 7NX Northampton Northamptonshire | British | 70180950001 | ||||||
| COX, Brian John | Director | Kirknewton House Kirknewton NE71 6XF Wooler Northumberland | England | British | 1436830002 | |||||
| DAVISON, Jeremy Robert | Director | 34 Trendlewood Park BS16 1TE Bristol | British | 65096740001 | ||||||
| FULLER, Alan Charles | Director | Freshwater Cottage 2 Chapel Brow Charlesworth SK13 5HH Glossop Derbyshire | England | British | 70283550001 | |||||
| GLOAG, Ann Heron | Director | Kinfauns Castle PH2 7JZ Perth Perthshire | Scotland | British | 141120003 | |||||
| GRIFFITHS, Martin Andrew | Director | Upland 2 Dupplin Terrace PH2 7DG Perth | Scotland | British | 61722690002 | |||||
| HILDITCH, Christopher Graham | Director | 51 Hildene Ampleforth Drive The Meadows ST17 4TE Stafford Staffordshire | British | 10417870001 | ||||||
| HINKLEY, William Barry | Director | Mandalay Bassenthwaite CA12 4QG Keswick Cumbria | England | British | 2268190002 | |||||
| HODGKINS, John Christopher | Director | 10 Piers Close CV34 5HS Warwick Warwickshire | British | 15371120001 | ||||||
| KINSKI, Michael John | Director | Cherry Tree House 268 Dunchurch Road CV22 6HX Rugby Warwickshire | United Kingdom | British | 58643710001 | |||||
| LYON, Inglis | Director | 102 Lewis Road Radford Semele CV31 1UP Leamington Spa Warwickshire | British | 72280120001 | ||||||
| RHYS-DAVIES, Mark Iorwedd | Director | 10 Evesham Road GL52 2AB Cheltenham Gloucestershire | British | 5652350001 | ||||||
| ROBBINS, Karen Rosaleen | Director | 8 Chendre Close Hayfield SK22 2PH High Peak Derbyshire | England | British | 73518280001 | |||||
| SOUTER, Brian | Director | Murrayfield House St Magdalenes Road PH2 0BT Perth Perthshire | British | 1436810001 | ||||||
| STAITE, John Frederick | Director | 30 Byfords Close Huntley GL19 3SA Gloucester | United Kingdom | British | 45931770001 | |||||
| THOMAS, Mark Richard | Director | The Quarry House Upper Lynch Road France Lynch GL6 8LZ Stroud Gloucestershire | British | 28914510001 | ||||||
| THOMAS, Norrie Russell | Director | Catherine Cottage Silver Street Chalford Hill GL6 8ES Stroud Gloucestershire | England | British | 1447710001 | |||||
| WARNEFORD, Leslie Brian | Director | 10 Dunkeld Road PH1 5TW Perth Stagecoach Group Plc Perthshire United Kingdom | United Kingdom | British | 49771140004 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de G & G TRAVEL LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagecoach Bus Holdings Limited | 06 abr 2016 | 10 Dunkeld Road PH1 5TW Perth Stagecoach Group Plc Perthshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene G & G TRAVEL LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 28 abr 1992 Entregado el 11 may 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Guarantee & debenture | Creado el 01 feb 1991 Entregado el 07 feb 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the facility letter 1ST february 1991, this debenture or any other finance document (as defined). | |
Breve descripción (See form 395. ref M224 for full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0