KENWOOD MARKS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaKENWOOD MARKS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02407362
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de KENWOOD MARKS LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra KENWOOD MARKS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de KENWOOD MARKS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SCOOPMARK LIMITED24 jul 198924 jul 1989

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de KENWOOD MARKS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para KENWOOD MARKS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    8 páginas4.71

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Domicilio social registrado cambiado de Unit 1 Kenwood Business Park New Lane Havant Hampshire PO9 2NH el 25 oct 2012

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 12 oct 2012

    LRESSP

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 20 jul 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital24 jul 2012

    Estado de capital el 24 jul 2012

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Déclaration annuelle établie au 20 jul 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    6 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    6 páginasAA

    Nombramiento de Mr Richard Kevin Kirk como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Ian Fry como secretario

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 20 jul 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cambio de datos del director Thierry Hubert el 20 jul 2010

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2008

    6 páginasAA

    Cambio de datos del secretario Mr Ian Richard Fry el 01 oct 2009

    1 páginasCH03

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas288a

    Resoluciones

    Resolutions
    7 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2007

    6 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2006

    7 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de KENWOOD MARKS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    KIRK, Richard Kevin
    Snow Hill
    EC1A 2AY London
    6
    Secretario
    Snow Hill
    EC1A 2AY London
    6
    153464160001
    HUBERT, Thierry
    Avenue Des Dames Blanches
    Brussels
    135
    1150
    Belgium
    Director
    Avenue Des Dames Blanches
    Brussels
    135
    1150
    Belgium
    BelgiumBelgian134423120001
    EASTWOOD, Martin
    27 Broadbent Close
    Rownhams
    SO16 8LQ Southampton
    Hampshire
    Secretario
    27 Broadbent Close
    Rownhams
    SO16 8LQ Southampton
    Hampshire
    British7620670002
    FRY, Ian Richard
    Unit 1 Kenwood Business Park
    New Lane
    PO9 2NH Havant
    Hampshire
    Secretario
    Unit 1 Kenwood Business Park
    New Lane
    PO9 2NH Havant
    Hampshire
    British80540100002
    HATTON, Thomas David Michael
    65 Crossbush Road
    PO22 7LY Felpham
    West Sussex
    Secretario
    65 Crossbush Road
    PO22 7LY Felpham
    West Sussex
    British728380004
    YOUNG, Mark Osborne
    2 Oyster Quay
    Port Solent
    PO6 4TE Portsmouth
    Hampshire
    Secretario
    2 Oyster Quay
    Port Solent
    PO6 4TE Portsmouth
    Hampshire
    British71930040003
    BEECH, Timothy Paul
    Bramble Copse
    Crow Hill
    BH24 3DE Ringwood
    Hampshire
    Director
    Bramble Copse
    Crow Hill
    BH24 3DE Ringwood
    Hampshire
    British67101230002
    BERALDO, Stefano
    Via N Sauro 41 Preganzial
    Treviso
    31032
    Italy
    Director
    Via N Sauro 41 Preganzial
    Treviso
    31032
    Italy
    British102137840001
    CREVOISIER, Philippe Henri Leon
    Via Di Montalbano
    FOREIGN 50136 Florence
    Italy
    Director
    Via Di Montalbano
    FOREIGN 50136 Florence
    Italy
    French78153300001
    DE' LONGHI, Fabio
    20 Via Chiesa
    Lughignano Di Casale Sul Sile
    Tv
    Italy
    Director
    20 Via Chiesa
    Lughignano Di Casale Sul Sile
    Tv
    Italy
    ItalyItalian76342830002
    DOUGLAS, Antony John
    26 Leydene Park Hyden Farm Lane
    East Meon
    GU32 1HF Petersfield
    Hampshire
    Director
    26 Leydene Park Hyden Farm Lane
    East Meon
    GU32 1HF Petersfield
    Hampshire
    British49116420003
    FORMELA, Adam Jonathan
    102 Braywick Road
    SL6 1DJ Maidenhead
    Berkshire
    Director
    102 Braywick Road
    SL6 1DJ Maidenhead
    Berkshire
    British55564910001
    FRIDLINGTON, George Edward
    Bramblefields Martins Lane
    Birdham
    PO20 7AU Chichester
    West Sussex
    Director
    Bramblefields Martins Lane
    Birdham
    PO20 7AU Chichester
    West Sussex
    British5508410001
    GORDON, Colin James
    The Clock House
    St Margarets
    SG12 8EQ Ware
    Hertfordshire
    Director
    The Clock House
    St Margarets
    SG12 8EQ Ware
    Hertfordshire
    EnglandBritish122332620001
    HOTSTON, Peter
    Denns Farm
    East Harting
    GU31 5NA Petersfield
    Hampshire
    Director
    Denns Farm
    East Harting
    GU31 5NA Petersfield
    Hampshire
    British5508420005
    LAPHAM, Michael John
    5 Carmarthen Avenue
    PO6 2AG Portsmouth
    Hampshire
    Director
    5 Carmarthen Avenue
    PO6 2AG Portsmouth
    Hampshire
    British87745630001
    MELO, Dario
    Via Orsoni 18
    FOREIGN Bologna
    40135
    Italy
    Director
    Via Orsoni 18
    FOREIGN Bologna
    40135
    Italy
    Italian101168790001
    MOLONEY, Kieran Joseph
    15 The Mount
    Caversham
    RG4 7RU Reading
    Berkshire
    Director
    15 The Mount
    Caversham
    RG4 7RU Reading
    Berkshire
    British8616170001
    PARKER, Timothy Charles
    The Old Vicarage Vicarage Lane
    Hambledon
    PO7 4RP Waterlooville
    Hampshire
    Director
    The Old Vicarage Vicarage Lane
    Hambledon
    PO7 4RP Waterlooville
    Hampshire
    British47724620001
    TAYLOR, Peter Robert
    34 Bowes Hill
    PO9 6BP Rowlands Castle
    Hampshire
    Director
    34 Bowes Hill
    PO9 6BP Rowlands Castle
    Hampshire
    British5508440001
    WICKENDEN, Graham Roland
    Oerley Hall
    Llanforda
    SY10 7HH Oswestry
    Shropshire
    Director
    Oerley Hall
    Llanforda
    SY10 7HH Oswestry
    Shropshire
    United KingdomBritish23906480002
    YOUNG, Mark Osborne
    2 Oyster Quay
    Port Solent
    PO6 4TE Portsmouth
    Hampshire
    Director
    2 Oyster Quay
    Port Solent
    PO6 4TE Portsmouth
    Hampshire
    British71930040003

    ¿Tiene KENWOOD MARKS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 27 jun 1997
    Entregado el 03 jul 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from kenwood appliances PLC, kenwood international limited, kenwood marks limited, kenwood limited, kenwood appliances (hk) limited and tricom industrial company limited to the chargee under the terms of this debenture
    Breve descripción
    Fixed charge over book debts and goodwill, floating charge over all the undertaking and assets whatsoever and wheresoever both present and future, f/h land and buildings lying to the east of heathfield road freshwater isle of wight t/n-HP43215; f/h land lying to the east of new lane, havant hampshire t/n-HP495824; f/h land and buildings on the north side of eastern road havant hampshire t/n-HP2677 (for the other property charged see form 395).. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC (As Security Agent for Itself and 9 Banks as Set Out in the Debenture)
    Transacciones
    • 03 jul 1997Registro de un cargo (395)
    • 27 abr 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Senior grarantee and debenture
    Creado el 07 sept 1989
    Entregado el 25 sept 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee agent and security trustee for the securied parnets under the terms of the chargee the senior loan agreement of even date and the security documents
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 25 sept 1989Registro de una carga
    • 05 jun 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mezzanine guarantee and debenture
    Creado el 07 sept 1989
    Entregado el 25 sept 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee a s agent and security trustee for the secured parkes under the terms of the charge the magzanine loan agreement of even date and the security documents.
    Breve descripción
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 25 sept 1989Registro de una carga
    • 05 jun 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene KENWOOD MARKS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    05 jul 2013Fecha de disolución
    12 oct 2012Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Michael David Rollings
    Rollings Butt Llp 6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    Profesional
    Rollings Butt Llp 6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    Vivienne Elizabeth Oliver
    6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    Profesional
    6 Snow Hill
    EC1A 2AY London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0