WINDELECTRIC LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | WINDELECTRIC LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02407377 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de WINDELECTRIC LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra WINDELECTRIC LIMITED?
| Dirección de la sede social | Monkton Reach Monkton Hill SN15 1EE Chippenham Wiltshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de WINDELECTRIC LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2010 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para WINDELECTRIC LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Juliet Sarah Loveday Davenport el 17 jul 2012 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Nigel Tranah como secretario el 16 abr 2012 | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Angela Newman como secretario el 16 abr 2012 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 mar 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Sellers como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | CAP-SS | ||||||||||
legacy | 3 páginas | SH20 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 mar 2011 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Nombramiento de Miss Angela Newman como secretario | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Hopkins como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 mar 2010 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Jonathan George Fairchild el 11 mar 2010 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Peter Dixon Edwards el 01 ene 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Juliet Sarah Loveday Davenport el 01 ene 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Mark Hopkins como secretario | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jonathan Fairchild como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2008 | 22 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 4 páginas | 363a | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2007 | 17 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 4 páginas | 363a | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de WINDELECTRIC LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANAH, Nigel | Secretario | Monkton Reach Monkton Hill SN15 1EE Chippenham Wiltshire | 168397380001 | |||||||
| DAVENPORT, Juliet Sarah Lovedy | Director | Monkton Reach Monkton Hill SN15 1EE Chippenham Wiltshire | United Kingdom | British | 70686370003 | |||||
| EDWARDS, Martin John | Director | The Bungalow Deli PL33 9BZ Delabole Cornwall | England | British | 81829090001 | |||||
| EDWARDS, Peter Dixon | Director | Deli PL33 9BZ Delabole N Cornwall | United Kingdom | British | 6723810001 | |||||
| EDWARDS, Jeremy Paul | Secretario | Kempson House PO BOX 570,Camomile Street EC3A 7AN London | British | 27850190002 | ||||||
| FAIRCHILD, Jonathan George | Secretario | Monkton Reach Monkton Hill SN15 1EE Chippenham Wiltshire | British | 91228100003 | ||||||
| HOPKINS, Mark | Secretario | Monkton Reach Monkton Hill SN15 1EE Chippenham Wiltshire | 149634170001 | |||||||
| NEWMAN, Angela | Secretario | Monkton Reach Monkton Hill SN15 1EE Chippenham Wiltshire | 155558130001 | |||||||
| OVALSEC LIMITED | Secretario designado corporativo | 2 Temple Back East Temple Quay BS1 6EG Bristol | 900002570001 | |||||||
| FISK, Nicholas John Spencer | Director | 10 Edwards Meadow SN8 1UD Marlborough Wiltshire | British | 36028930001 | ||||||
| LOPEZ-CACICEDO, Carlos, Dr | Director | 362 Marlborough Road SN3 1NP Swindon | Spanish | 14105600002 | ||||||
| MASOOD, Tariq | Director | 22 Ashgrove Avenue Ashley Down BS7 9LJ Bristol | United Kingdom | British | 46049660002 | |||||
| MASOOD, Tariq | Director | 46 Sherbourne Avenue Bradley Stoke BS12 8BB Bristol Avon | British | 46049660001 | ||||||
| MASTERMAN, Richard Thomas | Director | Thuborough House Sutcombe EX22 7QE Holsworthy Devon | British | 3437250001 | ||||||
| SEED, John Junior | Director | Highfield House North Road BA2 6HW Bath Bath & North East Somerset | British | 8670120001 | ||||||
| SELLERS, John Ernest | Director | Rodway Hill Manor Manor Road Mangotsfield BS16 9LG Bristol | United Kingdom | British | 47428650001 | |||||
| SWARBRICK, Gerard Joseph | Director | 39 Upper Cranbrook Road Westbury Park BS6 7UR Bristol | England | British | 27850210001 | |||||
| SWINDELLS, Brian James | Director | 7 Hollymead Lane Stoke Bishop BS9 1LN Bristol | British | 32426200002 | ||||||
| SAXON FINANCE CORPORATION LIMITED | Director corporativo | Thuborough House Sutcombe EX22 7QE Holsworthy Devon | 59178080001 |
¿Tiene WINDELECTRIC LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Performance guarantee and warranty guarantee assignment | Creado el 14 nov 1991 Entregado el 22 nov 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 4/11/91 and security documents issued pursuant thereto | |
Breve descripción All the companys rights title and interest in and to a performance guarantee dated 12/11/91. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Contract consultant's appointment and warranty and maintenance agreement charge | Creado el 04 nov 1991 Entregado el 20 nov 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All moneys due or to become due from thecompany to the chargee under the terms of the facility letter dated 4TH NOVEMBER1991 and this deed | |
Breve descripción All the benefit of the contract agreement,the agreement,andthe warranty and maintenance agreement all dated 19TH july 1991 see form 395 ref M792C for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Contract charge | Creado el 04 nov 1991 Entregado el 15 nov 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter of even date and the charge | |
Breve descripción All the benefit of an agreement dated 9/8/91. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge over deposit account | Creado el 04 nov 1991 Entregado el 13 nov 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción All the company's right, title and interest-bearing deposit account number 66457901 at natwest investment bank limited designated cnw re: windelectric limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge over power purchase agreement | Creado el 04 nov 1991 Entregado el 13 nov 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to natwest investment bank limited or to any receiver appointed by the bank under the terms of the facility letter and/or mortgage debenture, both of even date, and/or this charge | |
Breve descripción All sums payable by non-fossil purchasing agency limited to the company under the power purchase agreement dated 12TH september 1990 and made beyween the company (1) non-fossil purchasing agency limited (2) and south western electricity PLC (3). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage debenture | Creado el 04 nov 1991 Entregado el 13 nov 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción By way of legal mortgage all those areas of leasehold land and premises at deli farm development delabole cornwall and/or the proceeds of sale thereof. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0