WINDELECTRIC LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaWINDELECTRIC LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02407377
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de WINDELECTRIC LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra WINDELECTRIC LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Monkton Reach
    Monkton Hill
    SN15 1EE Chippenham
    Wiltshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de WINDELECTRIC LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para WINDELECTRIC LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cambio de datos del director Juliet Sarah Loveday Davenport el 17 jul 2012

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mr Nigel Tranah como secretario el 16 abr 2012

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Angela Newman como secretario el 16 abr 2012

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 01 mar 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital05 mar 2012

    Estado de capital el 05 mar 2012

    • Capital: GBP 14,875
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    23 páginasAA

    Cese del nombramiento de John Sellers como director

    1 páginasTM01

    legacy

    3 páginasCAP-SS

    legacy

    3 páginasSH20

    Déclaration annuelle établie au 01 mar 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Nombramiento de Miss Angela Newman como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Mark Hopkins como secretario

    1 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    23 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 mar 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cambio de datos del secretario Jonathan George Fairchild el 11 mar 2010

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mr Peter Dixon Edwards el 01 ene 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Juliet Sarah Loveday Davenport el 01 ene 2010

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mr Mark Hopkins como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Jonathan Fairchild como secretario

    1 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2008

    22 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2007

    17 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    ¿Quiénes son los directivos de WINDELECTRIC LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    TRANAH, Nigel
    Monkton Reach
    Monkton Hill
    SN15 1EE Chippenham
    Wiltshire
    Secretario
    Monkton Reach
    Monkton Hill
    SN15 1EE Chippenham
    Wiltshire
    168397380001
    DAVENPORT, Juliet Sarah Lovedy
    Monkton Reach
    Monkton Hill
    SN15 1EE Chippenham
    Wiltshire
    Director
    Monkton Reach
    Monkton Hill
    SN15 1EE Chippenham
    Wiltshire
    United KingdomBritish70686370003
    EDWARDS, Martin John
    The Bungalow
    Deli
    PL33 9BZ Delabole
    Cornwall
    Director
    The Bungalow
    Deli
    PL33 9BZ Delabole
    Cornwall
    EnglandBritish81829090001
    EDWARDS, Peter Dixon
    Deli
    PL33 9BZ Delabole
    N Cornwall
    Director
    Deli
    PL33 9BZ Delabole
    N Cornwall
    United KingdomBritish6723810001
    EDWARDS, Jeremy Paul
    Kempson House
    PO BOX 570,Camomile Street
    EC3A 7AN London
    Secretario
    Kempson House
    PO BOX 570,Camomile Street
    EC3A 7AN London
    British27850190002
    FAIRCHILD, Jonathan George
    Monkton Reach
    Monkton Hill
    SN15 1EE Chippenham
    Wiltshire
    Secretario
    Monkton Reach
    Monkton Hill
    SN15 1EE Chippenham
    Wiltshire
    British91228100003
    HOPKINS, Mark
    Monkton Reach
    Monkton Hill
    SN15 1EE Chippenham
    Wiltshire
    Secretario
    Monkton Reach
    Monkton Hill
    SN15 1EE Chippenham
    Wiltshire
    149634170001
    NEWMAN, Angela
    Monkton Reach
    Monkton Hill
    SN15 1EE Chippenham
    Wiltshire
    Secretario
    Monkton Reach
    Monkton Hill
    SN15 1EE Chippenham
    Wiltshire
    155558130001
    OVALSEC LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Secretario designado corporativo
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002570001
    FISK, Nicholas John Spencer
    10 Edwards Meadow
    SN8 1UD Marlborough
    Wiltshire
    Director
    10 Edwards Meadow
    SN8 1UD Marlborough
    Wiltshire
    British36028930001
    LOPEZ-CACICEDO, Carlos, Dr
    362 Marlborough Road
    SN3 1NP Swindon
    Director
    362 Marlborough Road
    SN3 1NP Swindon
    Spanish14105600002
    MASOOD, Tariq
    22 Ashgrove Avenue
    Ashley Down
    BS7 9LJ Bristol
    Director
    22 Ashgrove Avenue
    Ashley Down
    BS7 9LJ Bristol
    United KingdomBritish46049660002
    MASOOD, Tariq
    46 Sherbourne Avenue
    Bradley Stoke
    BS12 8BB Bristol
    Avon
    Director
    46 Sherbourne Avenue
    Bradley Stoke
    BS12 8BB Bristol
    Avon
    British46049660001
    MASTERMAN, Richard Thomas
    Thuborough House
    Sutcombe
    EX22 7QE Holsworthy
    Devon
    Director
    Thuborough House
    Sutcombe
    EX22 7QE Holsworthy
    Devon
    British3437250001
    SEED, John Junior
    Highfield House North Road
    BA2 6HW Bath
    Bath & North East Somerset
    Director
    Highfield House North Road
    BA2 6HW Bath
    Bath & North East Somerset
    British8670120001
    SELLERS, John Ernest
    Rodway Hill Manor
    Manor Road Mangotsfield
    BS16 9LG Bristol
    Director
    Rodway Hill Manor
    Manor Road Mangotsfield
    BS16 9LG Bristol
    United KingdomBritish47428650001
    SWARBRICK, Gerard Joseph
    39 Upper Cranbrook Road
    Westbury Park
    BS6 7UR Bristol
    Director
    39 Upper Cranbrook Road
    Westbury Park
    BS6 7UR Bristol
    EnglandBritish27850210001
    SWINDELLS, Brian James
    7 Hollymead Lane
    Stoke Bishop
    BS9 1LN Bristol
    Director
    7 Hollymead Lane
    Stoke Bishop
    BS9 1LN Bristol
    British32426200002
    SAXON FINANCE CORPORATION LIMITED
    Thuborough House
    Sutcombe
    EX22 7QE Holsworthy
    Devon
    Director corporativo
    Thuborough House
    Sutcombe
    EX22 7QE Holsworthy
    Devon
    59178080001

    ¿Tiene WINDELECTRIC LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Performance guarantee and warranty guarantee assignment
    Creado el 14 nov 1991
    Entregado el 22 nov 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 4/11/91 and security documents issued pursuant thereto
    Breve descripción
    All the companys rights title and interest in and to a performance guarantee dated 12/11/91.
    Personas con derecho
    • Natwest Investment Bank Limited
    Transacciones
    • 22 nov 1991Registro de un cargo (395)
    • 14 nov 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Contract consultant's appointment and warranty and maintenance agreement charge
    Creado el 04 nov 1991
    Entregado el 20 nov 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from thecompany to the chargee under the terms of the facility letter dated 4TH NOVEMBER1991 and this deed
    Breve descripción
    All the benefit of the contract agreement,the agreement,andthe warranty and maintenance agreement all dated 19TH july 1991 see form 395 ref M792C for full details.
    Personas con derecho
    • Natwest Investment Bank Limited
    Transacciones
    • 20 nov 1991Registro de un cargo (395)
    • 14 nov 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Contract charge
    Creado el 04 nov 1991
    Entregado el 15 nov 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter of even date and the charge
    Breve descripción
    All the benefit of an agreement dated 9/8/91.
    Personas con derecho
    • Natwest Investment Banl Limited
    Transacciones
    • 15 nov 1991Registro de un cargo (395)
    • 14 nov 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over deposit account
    Creado el 04 nov 1991
    Entregado el 13 nov 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All the company's right, title and interest-bearing deposit account number 66457901 at natwest investment bank limited designated cnw re: windelectric limited. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Natwest Investment Bank Limited
    Transacciones
    • 13 nov 1991Registro de un cargo (395)
    • 01 sept 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over power purchase agreement
    Creado el 04 nov 1991
    Entregado el 13 nov 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to natwest investment bank limited or to any receiver appointed by the bank under the terms of the facility letter and/or mortgage debenture, both of even date, and/or this charge
    Breve descripción
    All sums payable by non-fossil purchasing agency limited to the company under the power purchase agreement dated 12TH september 1990 and made beyween the company (1) non-fossil purchasing agency limited (2) and south western electricity PLC (3).
    Personas con derecho
    • Natwest Investment Bank Limited
    Transacciones
    • 13 nov 1991Registro de un cargo (395)
    • 14 nov 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 04 nov 1991
    Entregado el 13 nov 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of legal mortgage all those areas of leasehold land and premises at deli farm development delabole cornwall and/or the proceeds of sale thereof. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Natwest Investment Bank Limited
    Transacciones
    • 13 nov 1991Registro de un cargo (395)
    • 01 sept 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0