C & C TECHNOLOGY LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | C & C TECHNOLOGY LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02411308 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de C & C TECHNOLOGY LIMITED?
- Actividades de consultoría en tecnología de la información (62020) / Información y comunicación
¿Dónde se encuentra C & C TECHNOLOGY LIMITED?
| Dirección de la sede social | 158 Edmund Street B3 2HB Birmingham |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de C & C TECHNOLOGY LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 oct 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para C & C TECHNOLOGY LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 25 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 13 dic 2022 | 24 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Field House Uttoxeter Old Road Derby DE1 1NH a 158 Edmund Street Birmingham B3 2HB el 29 dic 2021 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 06 ene 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 oct 2020 au 30 abr 2021 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 oct 2019 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 06 ene 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 oct 2018 | 21 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 06 ene 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 oct 2017 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 06 ene 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 oct 2016 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Kevin Henry Newport como director el 24 mar 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 06 ene 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Carol Denise Lunn como director el 20 dic 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 oct 2015 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de William Timothy Webb como director el 31 mar 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Foster como director el 30 mar 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Peter Louis Burridge como director el 31 mar 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Shane Colombo como director el 30 mar 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jason Peter Colombo como director el 30 mar 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de C & C TECHNOLOGY LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAMS, Philip Edward | Secretario | Edmund Street B3 2HB Birmingham 158 | 184113550001 | |||||||
| NORFIELD, Michael Stewart | Director | Uttoxeter Old Road DE1 1NH Derby Field House United Kingdom | United Kingdom | British | 127477840001 | |||||
| WILLIAMS, Philip Edward | Director | Uttoxeter Old Road DE1 1NH Derby Field House United Kingdom | England | British | 160393000001 | |||||
| COLOMBO, Ralph Andre | Secretario | Cornfields Ox Drove Burghclere RG20 9HH Newbury | British | 51259330002 | ||||||
| LUNN, Carol Denise | Secretario | Kew Walk Millway Gardens SP10 3UL Andover 8 Hampshire United Kingdom | 148730180001 | |||||||
| SANDS, Ann Evelyn | Secretario | Rowan House Mill Lane Longparish SP11 6PN Andover Hampshire | British | 7071860001 | ||||||
| BURRIDGE, Peter Louis | Director | Uttoxeter Old Road DE1 1NH Derby Field House | England | British | 58738180001 | |||||
| COLOMBO, Jason Peter | Director | 19 Chilton Ridge RG22 4RG Basingstoke Hampshire | United Kingdom | British | 40675770002 | |||||
| COLOMBO, Ralph Andre | Director | Cornfields Ox Drove Burghclere RG20 9HH Newbury | United Kingdom | British | 51259330002 | |||||
| COLOMBO, Ralph Andre | Director | 3 Phoenix Court Kingsclere RG20 5PH Newbury Berkshire | British | 51259330001 | ||||||
| COLOMBO, Shane | Director | Uttoxeter Old Road DE1 1NH Derby Field House England | United Kingdom | British | 156531720001 | |||||
| FINCHAM, John Robert | Director | High Street Harmondsworth UB7 0BT West Drayton Duval House Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | 159806070001 | |||||
| FOSTER, John | Director | 14 The Crescent KT13 8EL Weybridge Surrey | United Kingdom | British | 87933320003 | |||||
| GIGG, Richard David | Director | Trigpoint House Streetway Road Palestine SP11 7EH Andover | England | British | 62883090002 | |||||
| GOULD, Kirstie | Director | Uttoxeter Old Road DE1 1NH Derby Field House England | United Kingdom | British | 174035320001 | |||||
| LAKS, Khangura | Director | High Street Harmondsworth UB7 0BT West Drayton Duval House Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | 160392810001 | |||||
| LUNN, Carol Denise | Director | 8 Kew Walk Millway Gardens SP10 3UL Andover Hampshire | England | British | 125068450001 | |||||
| NEWPORT, Kevin Henry | Director | Uttoxeter Old Road DE1 1NH Derby Field House | United Kingdom | British | 122758370002 | |||||
| NICHOLSON, Brian James | Director | High Street Harmondsworth UB7 0BT West Drayton Duval House Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | 92342690002 | |||||
| SANDS, Ann Evelyn | Director | Rowan House Mill Lane Longparish SP11 6PN Andover Hampshire | England | British | 7071860001 | |||||
| SANDS, Roy Bonner | Director | Rowan House Mill Lane Longparish SP11 6PN Andover Hampshire | England | British | 7071870001 | |||||
| WEBB, William Timothy, Dr. | Director | Uttoxeter Old Road DE1 1NH Derby Field House | England | British | 138014140001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de C & C TECHNOLOGY LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Radio Limited | 06 abr 2016 | Uttoxeter Old Road DE1 1NH Derby Field House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene C & C TECHNOLOGY LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Accession deed to a debenture | Creado el 31 dic 2012 Entregado el 04 ene 2013 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All the freehold and leasehold property first fixed charge all the equipment all charged securities all insurance policies all intellectual property see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge | Creado el 30 abr 1992 Entregado el 14 may 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed charge on goodwill patents and uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Fixed and floating charge | Creado el 23 nov 1990 Entregado el 28 nov 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene C & C TECHNOLOGY LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0