WASTE RECOVERY LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | WASTE RECOVERY LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02411841 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de WASTE RECOVERY LIMITED?
- Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos (38210) / Captación, depuración y distribución de agua; gestión de residuos; actividades de descontaminación y recuperación
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra WASTE RECOVERY LIMITED?
| Dirección de la sede social | Staverton Court Staverton GL51 0UX Cheltenham |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WASTE RECOVERY LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| WASTE RECYCLING LIMITED | 08 ago 1989 | 08 ago 1989 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de WASTE RECOVERY LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para WASTE RECOVERY LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 10 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 07 sept 2023 | 9 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 3 Sidings Court White Rose Way Doncaster DN4 5NU England a Staverton Court Staverton Cheltenham GL51 0UX el 20 sept 2022 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Ground Floor West 900 Pavilion Drive Northampton Business Park Northampton NN4 7RG a 3 Sidings Court White Rose Way Doncaster DN4 5NU el 01 abr 2022 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Agustin Serrano Minchan como director el 11 feb 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Georgina Violet Crowhurst como secretario el 28 ene 2020 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 024118410010 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Nombramiento de Miss Georgina Violet Crowhurst como secretario el 15 oct 2019 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 21 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2019 con actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Carol Jayne Nunn como secretario el 17 may 2019 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Registro de la carga 024118410010, creada el 18 jun 2018 | 105 páginas | MR01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 024118410009 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 19 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de WASTE RECOVERY LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTS-LLOPIS, Vicente Federico | Director | Staverton GL51 0UX Cheltenham Staverton Court | United Kingdom | Spanish | 147551840001 | |||||
| TAYLOR, Paul | Director | Staverton GL51 0UX Cheltenham Staverton Court | United Kingdom | British | 147757950001 | |||||
| BOLTON, Jonathan Mark | Secretario | Ground Floor West 900 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7RG Northampton Northamptonshire | British | 15931960007 | ||||||
| BUNTON, Victoria | Secretario | Ground Floor West 900 Pavilion Drive NN4 7RG Northampton Business Park Northampton | 164525630001 | |||||||
| CALDER, Samantha Jane | Secretario | Cowslip Cottage Roade Hill Ashton NN7 2JH Northampton Northamptonshire | British | 75830790003 | ||||||
| CROWHURST, Georgina Violet | Secretario | Ground Floor West 900 Pavilion Drive NN4 7RG Northampton Business Park Northampton | 263557120001 | |||||||
| DE FEO, Caterina | Secretario | Pavilion Drive NN4 7RG Northampton Ground Floor West, 900 United Kingdom | Italian | 140556050001 | ||||||
| FAVIER TILSTON, Claire | Secretario | Ground Floor West 900 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7RG Northampton Northamptonshire | British | 117647490002 | ||||||
| HARDMAN, Steven Neville | Secretario | The Wing Jaggards House Jaggards Lane Neston SN13 9SF Corsham Wiltshire | British | 93743250001 | ||||||
| HARDMAN, Steven Neville | Secretario | Merrywood Sion Hill BA1 2UL Bath Avon | British | 93743250004 | ||||||
| NUNN, Carol Jayne | Secretario | Ground Floor West 900 Pavilion Drive NN4 7RG Northampton Business Park Northampton | 174531890001 | |||||||
| STUTELEY, Stephen Russell | Secretario | 2 Oak Grove Barton Hill IP31 1TH Bury St Edmunds Suffolk | British | 60742960001 | ||||||
| WATERHOUSE, Alan | Secretario | 2a Norwood Grove Birkenshaw BD11 2NP Bradford West Yorkshire | British | 24588340001 | ||||||
| BASTOW, Edward William | Director | Rose Cottage Nowton IP29 5NB Bury St. Edmunds Suffolk | United Kingdom | British | 85608360001 | |||||
| BURNS, Phillip Wesley | Director | Flat 15 12 Bourchier Street W1D 4HZ London | United Kingdom | British | 160550800001 | |||||
| CASSELLS, Leslie James Davidson | Director | Ground Floor West 900 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7RG Northampton Northamptonshire | British | 95347040005 | ||||||
| ELLIS, Christopher John | Director | 900 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7RG Northampton Ground Floor West | United Kingdom | British | 132052980001 | |||||
| ETHERIDGE, Hugh Charles | Director | 5 Springfield Place BA1 5RA Bath Avon | United Kingdom | British | 1491130002 | |||||
| HARDMAN, Steven Neville | Director | Ground Floor West 900 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7RG Northampton Northamptonshire | British | 93743250006 | ||||||
| HUNTINGTON, John Michael | Director | Skelton Hall Skelton Lane Thorner LS14 1AE Leeds West Yorkshire | British | 102172280001 | ||||||
| KNOTT, Gordon Peter | Director | Duxrdun Dodds Road NR17 2HH Attleborough Norfolk | British | 74368950001 | ||||||
| MEREDITH, James Robert | Director | Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7RG Northampton Ground Floor West 900 Northamptonshire | British | 29339860005 | ||||||
| PRIOR, Ruth Catherine | Director | 56 Northchurch Road N1 4EJ London | United Kingdom | British | 92539490002 | |||||
| RACKHAM, Sheila Anne | Director | Manor Farm NR16 2RX Bridgham Norfolk | England | English | 56243630001 | |||||
| RACKHAM (SNR), Paul Anthony | Director | Manor Farm Bridgham NR16 2RX Norwich Norfolk | United Kingdom | British | 74659430001 | |||||
| RACKHAM JNR, Paul Anthony | Director | 14 Hardwick Park Gardens IP33 2QU Bury St Edmunds Suffolk | British | 84636840002 | ||||||
| SANDY, Nigel Desmond Alexander | Director | 3 Collett Way BA11 2XN Frome Somerset | England | British | 6470660001 | |||||
| SERRANO MINCHAN, Agustin | Director | Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7RG Northampton Ground Floor West, 900 United Kingdom | Spain | Spanish | 140598310001 | |||||
| SHEPPARD, Derrick Richard Adam, Reverend | Director | Orchard House Back Lane Garboldisham IP22 2SD Diss Norfolk | England | British | 54306660001 | |||||
| STEWART, Quentin Richard | Director | 62 Anchor Brew House Shad Thames SE1 2LY London | United Kingdom | British | 94880800002 | |||||
| STUTELEY, Stephen Russell | Director | 2 Oak Grove Barton Hill IP31 1TH Bury St Edmunds Suffolk | British | 60742960001 | ||||||
| TRENDELL, William Anthony | Director | Victorian Rendezvous 18 Rectory Close Merrow GU4 7AR Guildford Surrey | England | British | 12317760001 | |||||
| WALSH, Timothy Charles | Director | White House Farm The Street, Hindolveston NR20 5DF Dereham Norfolk | British | 106429250001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de WASTE RECOVERY LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fcc Environment (Uk) Limited | 07 abr 2016 | 900 Pavilion Drive NN4 7RG Northampton Ground Floor West Northamptonshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene WASTE RECOVERY LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 18 jun 2018 Entregado el 21 jun 2018 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción The debenture dated 18 june 2018 between, amongst others, waste recovery limited and glas trustees limited creates fixed security over certain real property and intellectual property rights owned by waste recovery limited. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 22 ene 2014 Entregado el 24 ene 2014 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción Notification of addition to or amendment of charge. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 17 dic 2013 Entregado el 20 dic 2013 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción F/H property k/a the thetford site located at burrell way thetford norfolk t/no NK103462. Notification of addition to or amendment of charge. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 17 dic 2013 Entregado el 20 dic 2013 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción Notification of addition to or amendment of charge. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Account charge | Creado el 21 dic 2006 Entregado el 05 ene 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the borrower and each obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción By way of floating charge all its present and future rights, title and interest to each cash account and all amounts credited to each cash account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 15 dic 2004 Entregado el 23 dic 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to the second secured creditors and/or any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción By way of second legal mortgage and second fixed charge the property (as defined in the form 395) by way of second fixed charge the investments, book debts, intellectual property, plant and machinery, contracts, pension funds, all its uncalled capital, all its goodwill and all its present and future rights and interests in respect of the relevant documents by way of second floating charge, its undertaking and all its assets both present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 05 sept 2003 Entregado el 12 sept 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 12 ago 2003 Entregado el 21 ago 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due of each obligor to the security agent and/or the finance parties and/or any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción By way of first legal mortgage, the scheduled property other than (I) any leasehold restricted property, the aldeby restricted property or the cinergy properties, in relation to which the provisions of clause 3.15 shall apply (ii) the excluded properties, in relation to which the provisions of clause 3.16 of the debenture shall apply and (iii) any excluded gas assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Single debenture | Creado el 08 mar 1990 Entregado el 17 mar 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Including heritable property and assets in scotland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Single debenture | Creado el 15 ene 1990 Entregado el 17 ene 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Inc all property and assets in scotland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene WASTE RECOVERY LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0