WASTE RECOVERY LIMITED

WASTE RECOVERY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaWASTE RECOVERY LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02411841
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de WASTE RECOVERY LIMITED?

    • Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos (38210) / Captación, depuración y distribución de agua; gestión de residuos; actividades de descontaminación y recuperación
    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra WASTE RECOVERY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Staverton Court
    Staverton
    GL51 0UX Cheltenham
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WASTE RECOVERY LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    WASTE RECYCLING LIMITED08 ago 198908 ago 1989

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de WASTE RECOVERY LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para WASTE RECOVERY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    10 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 07 sept 2023

    9 páginasLIQ03

    Domicilio social registrado cambiado de 3 Sidings Court White Rose Way Doncaster DN4 5NU England a Staverton Court Staverton Cheltenham GL51 0UX el 20 sept 2022

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 08 sept 2022

    LRESSP

    Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de Ground Floor West 900 Pavilion Drive Northampton Business Park Northampton NN4 7RG a 3 Sidings Court White Rose Way Doncaster DN4 5NU el 01 abr 2022

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Agustin Serrano Minchan como director el 11 feb 2022

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020

    17 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019

    18 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Georgina Violet Crowhurst como secretario el 28 ene 2020

    1 páginasTM02

    Cancelación total de la carga 024118410010

    1 páginasMR04

    Nombramiento de Miss Georgina Violet Crowhurst como secretario el 15 oct 2019

    2 páginasAP03

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    21 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2019 con actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Carol Jayne Nunn como secretario el 17 may 2019

    1 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    20 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Registro de la carga 024118410010, creada el 18 jun 2018

    105 páginasMR01

    Cancelación total de la carga 024118410009

    1 páginasMR04

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    19 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de WASTE RECOVERY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ORTS-LLOPIS, Vicente Federico
    Staverton
    GL51 0UX Cheltenham
    Staverton Court
    Director
    Staverton
    GL51 0UX Cheltenham
    Staverton Court
    United KingdomSpanish147551840001
    TAYLOR, Paul
    Staverton
    GL51 0UX Cheltenham
    Staverton Court
    Director
    Staverton
    GL51 0UX Cheltenham
    Staverton Court
    United KingdomBritish147757950001
    BOLTON, Jonathan Mark
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    Secretario
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    British15931960007
    BUNTON, Victoria
    Ground Floor West
    900 Pavilion Drive
    NN4 7RG Northampton Business Park
    Northampton
    Secretario
    Ground Floor West
    900 Pavilion Drive
    NN4 7RG Northampton Business Park
    Northampton
    164525630001
    CALDER, Samantha Jane
    Cowslip Cottage
    Roade Hill Ashton
    NN7 2JH Northampton
    Northamptonshire
    Secretario
    Cowslip Cottage
    Roade Hill Ashton
    NN7 2JH Northampton
    Northamptonshire
    British75830790003
    CROWHURST, Georgina Violet
    Ground Floor West
    900 Pavilion Drive
    NN4 7RG Northampton Business Park
    Northampton
    Secretario
    Ground Floor West
    900 Pavilion Drive
    NN4 7RG Northampton Business Park
    Northampton
    263557120001
    DE FEO, Caterina
    Pavilion Drive
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West, 900
    United Kingdom
    Secretario
    Pavilion Drive
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West, 900
    United Kingdom
    Italian140556050001
    FAVIER TILSTON, Claire
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    Secretario
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    British117647490002
    HARDMAN, Steven Neville
    The Wing Jaggards House
    Jaggards Lane Neston
    SN13 9SF Corsham
    Wiltshire
    Secretario
    The Wing Jaggards House
    Jaggards Lane Neston
    SN13 9SF Corsham
    Wiltshire
    British93743250001
    HARDMAN, Steven Neville
    Merrywood
    Sion Hill
    BA1 2UL Bath
    Avon
    Secretario
    Merrywood
    Sion Hill
    BA1 2UL Bath
    Avon
    British93743250004
    NUNN, Carol Jayne
    Ground Floor West
    900 Pavilion Drive
    NN4 7RG Northampton Business Park
    Northampton
    Secretario
    Ground Floor West
    900 Pavilion Drive
    NN4 7RG Northampton Business Park
    Northampton
    174531890001
    STUTELEY, Stephen Russell
    2 Oak Grove
    Barton Hill
    IP31 1TH Bury St Edmunds
    Suffolk
    Secretario
    2 Oak Grove
    Barton Hill
    IP31 1TH Bury St Edmunds
    Suffolk
    British60742960001
    WATERHOUSE, Alan
    2a Norwood Grove
    Birkenshaw
    BD11 2NP Bradford
    West Yorkshire
    Secretario
    2a Norwood Grove
    Birkenshaw
    BD11 2NP Bradford
    West Yorkshire
    British24588340001
    BASTOW, Edward William
    Rose Cottage
    Nowton
    IP29 5NB Bury St. Edmunds
    Suffolk
    Director
    Rose Cottage
    Nowton
    IP29 5NB Bury St. Edmunds
    Suffolk
    United KingdomBritish85608360001
    BURNS, Phillip Wesley
    Flat 15
    12 Bourchier Street
    W1D 4HZ London
    Director
    Flat 15
    12 Bourchier Street
    W1D 4HZ London
    United KingdomBritish160550800001
    CASSELLS, Leslie James Davidson
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    Director
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    British95347040005
    ELLIS, Christopher John
    900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West
    Director
    900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West
    United KingdomBritish132052980001
    ETHERIDGE, Hugh Charles
    5 Springfield Place
    BA1 5RA Bath
    Avon
    Director
    5 Springfield Place
    BA1 5RA Bath
    Avon
    United KingdomBritish1491130002
    HARDMAN, Steven Neville
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    Director
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    British93743250006
    HUNTINGTON, John Michael
    Skelton Hall
    Skelton Lane Thorner
    LS14 1AE Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Skelton Hall
    Skelton Lane Thorner
    LS14 1AE Leeds
    West Yorkshire
    British102172280001
    KNOTT, Gordon Peter
    Duxrdun
    Dodds Road
    NR17 2HH Attleborough
    Norfolk
    Director
    Duxrdun
    Dodds Road
    NR17 2HH Attleborough
    Norfolk
    British74368950001
    MEREDITH, James Robert
    Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West 900
    Northamptonshire
    Director
    Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West 900
    Northamptonshire
    British29339860005
    PRIOR, Ruth Catherine
    56 Northchurch Road
    N1 4EJ London
    Director
    56 Northchurch Road
    N1 4EJ London
    United KingdomBritish92539490002
    RACKHAM, Sheila Anne
    Manor Farm
    NR16 2RX Bridgham
    Norfolk
    Director
    Manor Farm
    NR16 2RX Bridgham
    Norfolk
    EnglandEnglish56243630001
    RACKHAM (SNR), Paul Anthony
    Manor Farm
    Bridgham
    NR16 2RX Norwich
    Norfolk
    Director
    Manor Farm
    Bridgham
    NR16 2RX Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritish74659430001
    RACKHAM JNR, Paul Anthony
    14 Hardwick Park Gardens
    IP33 2QU Bury St Edmunds
    Suffolk
    Director
    14 Hardwick Park Gardens
    IP33 2QU Bury St Edmunds
    Suffolk
    British84636840002
    SANDY, Nigel Desmond Alexander
    3 Collett Way
    BA11 2XN Frome
    Somerset
    Director
    3 Collett Way
    BA11 2XN Frome
    Somerset
    EnglandBritish6470660001
    SERRANO MINCHAN, Agustin
    Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West, 900
    United Kingdom
    Director
    Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West, 900
    United Kingdom
    SpainSpanish140598310001
    SHEPPARD, Derrick Richard Adam, Reverend
    Orchard House Back Lane
    Garboldisham
    IP22 2SD Diss
    Norfolk
    Director
    Orchard House Back Lane
    Garboldisham
    IP22 2SD Diss
    Norfolk
    EnglandBritish54306660001
    STEWART, Quentin Richard
    62 Anchor Brew House
    Shad Thames
    SE1 2LY London
    Director
    62 Anchor Brew House
    Shad Thames
    SE1 2LY London
    United KingdomBritish94880800002
    STUTELEY, Stephen Russell
    2 Oak Grove
    Barton Hill
    IP31 1TH Bury St Edmunds
    Suffolk
    Director
    2 Oak Grove
    Barton Hill
    IP31 1TH Bury St Edmunds
    Suffolk
    British60742960001
    TRENDELL, William Anthony
    Victorian Rendezvous
    18 Rectory Close Merrow
    GU4 7AR Guildford
    Surrey
    Director
    Victorian Rendezvous
    18 Rectory Close Merrow
    GU4 7AR Guildford
    Surrey
    EnglandBritish12317760001
    WALSH, Timothy Charles
    White House Farm
    The Street, Hindolveston
    NR20 5DF Dereham
    Norfolk
    Director
    White House Farm
    The Street, Hindolveston
    NR20 5DF Dereham
    Norfolk
    British106429250001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de WASTE RECOVERY LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Fcc Environment (Uk) Limited
    900 Pavilion Drive
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West
    Northamptonshire
    England
    07 abr 2016
    900 Pavilion Drive
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West
    Northamptonshire
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House England & Wales
    Número de registro2902416
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.

    ¿Tiene WASTE RECOVERY LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 18 jun 2018
    Entregado el 21 jun 2018
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    The debenture dated 18 june 2018 between, amongst others, waste recovery limited and glas trustees limited creates fixed security over certain real property and intellectual property rights owned by waste recovery limited.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Glas Trustees Limited
    Transacciones
    • 21 jun 2018Registro de una carga (MR01)
    • 19 dic 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 22 ene 2014
    Entregado el 24 ene 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Glas Nominees Limited (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 24 ene 2014Registro de una carga (MR01)
    • 18 jun 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 17 dic 2013
    Entregado el 20 dic 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    F/H property k/a the thetford site located at burrell way thetford norfolk t/no NK103462. Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Glas Nominees Limited (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 20 dic 2013Registro de una carga (MR01)
    • 24 ene 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 17 dic 2013
    Entregado el 20 dic 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Glas Nominees Limited
    Transacciones
    • 20 dic 2013Registro de una carga (MR01)
    • 24 ene 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Account charge
    Creado el 21 dic 2006
    Entregado el 05 ene 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the borrower and each obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of floating charge all its present and future rights, title and interest to each cash account and all amounts credited to each cash account. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Banco Santander Central Hispano, S.A., London Branch as Trustee for the Finance Parties (Thesecurity Trustee)
    Transacciones
    • 05 ene 2007Registro de un cargo (395)
    • 24 ene 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 15 dic 2004
    Entregado el 23 dic 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the second secured creditors and/or any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of second legal mortgage and second fixed charge the property (as defined in the form 395) by way of second fixed charge the investments, book debts, intellectual property, plant and machinery, contracts, pension funds, all its uncalled capital, all its goodwill and all its present and future rights and interests in respect of the relevant documents by way of second floating charge, its undertaking and all its assets both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Bank of New York as Second Secured Note Trustee (The "Second Secured Note Trustee")
    Transacciones
    • 23 dic 2004Registro de un cargo (395)
    • 02 oct 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 05 sept 2003
    Entregado el 12 sept 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (As "Security Agent")
    Transacciones
    • 12 sept 2003Registro de un cargo (395)
    • 02 oct 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 12 ago 2003
    Entregado el 21 ago 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due of each obligor to the security agent and/or the finance parties and/or any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first legal mortgage, the scheduled property other than (I) any leasehold restricted property, the aldeby restricted property or the cinergy properties, in relation to which the provisions of clause 3.15 shall apply (ii) the excluded properties, in relation to which the provisions of clause 3.16 of the debenture shall apply and (iii) any excluded gas assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent)
    Transacciones
    • 21 ago 2003Registro de un cargo (395)
    • 02 oct 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Single debenture
    Creado el 08 mar 1990
    Entregado el 17 mar 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Including heritable property and assets in scotland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 17 mar 1990Registro de una carga
    • 26 ene 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Single debenture
    Creado el 15 ene 1990
    Entregado el 17 ene 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Inc all property and assets in scotland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 17 ene 1990Registro de una carga
    • 23 feb 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene WASTE RECOVERY LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    10 jul 2024Fecha prevista de disolución
    08 sept 2022Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Peter Richard James Frost
    Staverton Court Staverton
    GL51 0UX Cheltenham
    Gloucestershire
    Profesional
    Staverton Court Staverton
    GL51 0UX Cheltenham
    Gloucestershire

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0