NEDLLOYD GENOA LIMITED

NEDLLOYD GENOA LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaNEDLLOYD GENOA LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02412292
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de NEDLLOYD GENOA LIMITED?

    • Arrendamiento financiero (64910) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra NEDLLOYD GENOA LIMITED?

    Dirección de la sede social
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de NEDLLOYD GENOA LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    P & O NEDLLOYD GENOA LIMITED27 oct 200427 oct 2004
    A & L CF DECEMBER (4) LIMITED19 ene 200419 ene 2004
    SOVEREIGN FLEET SERVICES LIMITED30 mar 200030 mar 2000
    SOVEREIGN TOWER LIMITED09 ago 198909 ago 1989

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de NEDLLOYD GENOA LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para NEDLLOYD GENOA LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    8 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 27 jun 2017

    8 páginasLIQ03

    Domicilio social registrado cambiado de 13th Floor, Aldgate Tower 2 Leman Street London E1 8FA United Kingdom a 30 Finsbury Square London EC2P 2YU el 08 jul 2016

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 28 jun 2016

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Domicilio social registrado cambiado de Maersk House Braham Street London E1 8EP a 13th Floor, Aldgate Tower 2 Leman Street London E1 8FA el 27 may 2016

    1 páginasAD01

    Cancelación total de la carga 1

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 2

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 4

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 6

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 5

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 7

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 10

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 3

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 8

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 9

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 11

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 12

    2 páginasMR04

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    17 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 09 ago 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital11 ago 2015

    Estado de capital el 11 ago 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    18 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 09 ago 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital14 ago 2014

    Estado de capital el 14 ago 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cese del nombramiento de Terence Cornick como director

    2 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de NEDLLOYD GENOA LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    KILBY, John, Mr.
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Secretario
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    British76247880001
    KILBY, John, Mr.
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Director
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    EnglandBritish76247880001
    LEHMANN-TAYLOR, Nigel Edmund
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Director
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    EnglandBritish137861000001
    CHEESEMAN, Guy Robert
    60 St Johns Park
    Blackheath
    SE3 7JP London
    Secretario
    60 St Johns Park
    Blackheath
    SE3 7JP London
    British7865940001
    DUVAL, Michael John
    Greenfields
    Ponds Road
    CM2 8QP Chelmsford
    Essex
    Secretario
    Greenfields
    Ponds Road
    CM2 8QP Chelmsford
    Essex
    British72879690001
    SINCLAIR FORD, Ian Andrew
    Stainton 103 Menlove Avenue
    Calderstones
    L18 3HP Liverpool
    Secretario
    Stainton 103 Menlove Avenue
    Calderstones
    L18 3HP Liverpool
    British58189030001
    TAYLOR, Charles Stuart
    Balnacroft 8 Stonewalls
    Rosemary Lane Rossett
    LL12 0LG Wrexham
    Flintshire
    Secretario
    Balnacroft 8 Stonewalls
    Rosemary Lane Rossett
    LL12 0LG Wrexham
    Flintshire
    British27312630001
    ZIMMER, Kaarina Ann
    Riowstraat 43
    2585 Gs
    The Hague
    Netherlands
    Secretario
    Riowstraat 43
    2585 Gs
    The Hague
    Netherlands
    British104894830001
    ALLEN, Martyn Clive
    Maersk House
    Braham Street
    E1 8EP London
    Director
    Maersk House
    Braham Street
    E1 8EP London
    United KingdomBritish117739980001
    ALLEN, Martyn Clive
    17 Inglis Road
    CO3 3HU Colchester
    Essex
    Director
    17 Inglis Road
    CO3 3HU Colchester
    Essex
    United KingdomBritish117739980001
    BENFIELD, Gary John
    7 Broadoaks
    Darland Lane, Rossett
    LL12 0FA Wrexham
    Clwyd
    Director
    7 Broadoaks
    Darland Lane, Rossett
    LL12 0FA Wrexham
    Clwyd
    British68702900001
    BILLINGHAM, David Christopher
    10 Campbell Close
    Kingsmead
    CW9 8NZ Northwich
    Cheshire
    Director
    10 Campbell Close
    Kingsmead
    CW9 8NZ Northwich
    Cheshire
    EnglandBritish68546630003
    BRITTAIN, Frederick Humphrey
    C/O Sovereign Leasing Plc
    298 Deansgate
    M3 4HH Manchester
    Gtr Manchester
    Director
    C/O Sovereign Leasing Plc
    298 Deansgate
    M3 4HH Manchester
    Gtr Manchester
    British23574940002
    BURRIDGE, James George Thomas
    Julien Road
    W5 4XA London
    5
    Director
    Julien Road
    W5 4XA London
    5
    EnglandUnited Kingdom59355820001
    CHRISTENSEN, Sune Norup
    Maersk House
    Braham Street
    E1 8EP London
    Director
    Maersk House
    Braham Street
    E1 8EP London
    United KingdomDanish161396040001
    CORNICK, Terence Eric
    Maersk House
    Braham Street
    E1 8EP London
    Director
    Maersk House
    Braham Street
    E1 8EP London
    United KingdomBritish134551700001
    DUFFY, Anthony Paul
    7 Outram Road
    Alexandra Park
    N22 7AB London
    Director
    7 Outram Road
    Alexandra Park
    N22 7AB London
    EnglandBritish72286750001
    EVANS, Martin William
    26 Moss Lane
    Bramhall
    SK7 1EH Stockport
    Cheshire
    Director
    26 Moss Lane
    Bramhall
    SK7 1EH Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish55210060002
    GREEN, Susan Linda
    4 Old Hall Park
    Guilden Sutton
    CH3 7ER Chester
    Cheshire
    Director
    4 Old Hall Park
    Guilden Sutton
    CH3 7ER Chester
    Cheshire
    British68546700001
    GUGGLBERGER, Klaus
    Graf Starhembergasse 4
    1040 Vienna
    Austria
    Director
    Graf Starhembergasse 4
    1040 Vienna
    Austria
    Austrian32780800002
    JARDINE, John
    The Old School Guilden Sutton Lane
    Guilden Sutton
    CH3 7EX Chester
    Director
    The Old School Guilden Sutton Lane
    Guilden Sutton
    CH3 7EX Chester
    British31897840002
    LEE, Andrew Philip, Mr.
    29 Alder Lane
    Balsall Common
    CV7 7DZ Solihull
    Director
    29 Alder Lane
    Balsall Common
    CV7 7DZ Solihull
    United KingdomBritish73882180001
    MARKS, Norman
    4 Old Hall Park
    Guilden Sutton
    CH3 7ER Chester
    Director
    4 Old Hall Park
    Guilden Sutton
    CH3 7ER Chester
    British48820520002
    MONEY, Timothy John
    Riverdale
    148 Peperharow Road
    GU7 2PW Godalming
    Surrey
    Director
    Riverdale
    148 Peperharow Road
    GU7 2PW Godalming
    Surrey
    EnglandBritish71374890003
    MORLEY, Colin Richard
    Flat 1 Model Lodging House
    Bloom Street
    M3 6AJ Salford
    Lancashire
    Director
    Flat 1 Model Lodging House
    Bloom Street
    M3 6AJ Salford
    Lancashire
    EnglandBritish89102840002
    O'BRIEN, Bernadette Mary
    10 Stormont Road
    Highgate
    N6 4NL London
    Director
    10 Stormont Road
    Highgate
    N6 4NL London
    EnglandIrish95129740001
    PUSEY, Nigel Simon
    Roslyns
    Water Lane
    CB9 7AL Helions Bumpstead
    Suffolk
    Director
    Roslyns
    Water Lane
    CB9 7AL Helions Bumpstead
    Suffolk
    British83149350005
    ROBBIE, David Andrew
    4 St Johns House 30 Smith Square
    SW1P 3HF London
    Director
    4 St Johns House 30 Smith Square
    SW1P 3HF London
    United KingdomBritish108246820001
    SALVERDA, Arnold Ate
    Brugakker 6547
    3704 Rk Zeist
    Netherlands
    Director
    Brugakker 6547
    3704 Rk Zeist
    Netherlands
    Dutch101663120001
    SCOTT, Ian Garden
    Riverbank House
    AB34 5JD Aboyne
    Aberdeenshire
    Director
    Riverbank House
    AB34 5JD Aboyne
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish79132120001
    SWANN, Andrew Blyth
    Nield House
    Beamond End
    HP7 0QT Amersham
    Buckinghamshire
    Director
    Nield House
    Beamond End
    HP7 0QT Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish60626890003
    TAYLOR, Charles Stuart
    Balnacroft 8 Stonewalls
    Rosemary Lane Rossett
    LL12 0LG Wrexham
    Flintshire
    Director
    Balnacroft 8 Stonewalls
    Rosemary Lane Rossett
    LL12 0LG Wrexham
    Flintshire
    United KingdomBritish27312630001
    TOWERS, Robert Leslie
    27 Winwick Park Avenue
    Winwick
    WA2 8XB Warrington
    Director
    27 Winwick Park Avenue
    Winwick
    WA2 8XB Warrington
    United KingdomBritish65275200002
    VAN SLOBBE, Rutger Paul Marie
    Oranje Nassaulaan 54b
    FOREIGN 1075 Ar Amsterdam
    Netherlands
    Director
    Oranje Nassaulaan 54b
    FOREIGN 1075 Ar Amsterdam
    Netherlands
    Dutch97369340002
    WHITE, Charles Toby Fitzherbert
    Hopton Wafers
    DY14 0NA Cleobury Mortimer
    The Manor House
    Shropshire
    Director
    Hopton Wafers
    DY14 0NA Cleobury Mortimer
    The Manor House
    Shropshire
    United KingdomUk129100360001

    ¿Tiene NEDLLOYD GENOA LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    British statutory mortgage
    Creado el 22 oct 2004
    Entregado el 09 nov 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company formerly known as a & l cf december (4) limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The vessel: the british flagged motor vessel p & o nedlloyd marseille official number 901564, and engines, machinery, boats, tackle, outfit, equipment, spare gear, fuel, consumable and other stores, belongings and appurtenances;. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Granite Shipping Company Limited
    Transacciones
    • 09 nov 2004Registro de un cargo (395)
    • 23 mar 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Assignment
    Creado el 22 oct 2004
    Entregado el 09 nov 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company formerly known as a & l cf december (4) limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The assigned property: the 2900 teu british flag container vessel M.V. p & o nedlloyd marseille, all of the company's present and future rights, title and interest in and to all benefits;. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Granite Shipping Company Limited
    Transacciones
    • 09 nov 2004Registro de un cargo (395)
    • 23 mar 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of covenants
    Creado el 22 oct 2004
    Entregado el 09 nov 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company formerly known as a & l cf december (4) limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The mortgaged property: the container vessel M.V. p & o nedlloyd marseille official number 901564, and includes any share or interest therein and her engines, machinery, boats, tackle, outfit, equipment, spare gear, fuel, consumable and other stores, belongings and appurtenances;. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Granite Shipping Company Limited
    Transacciones
    • 09 nov 2004Registro de un cargo (395)
    • 23 mar 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Assignment
    Creado el 22 oct 2004
    Entregado el 08 nov 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the borrowers to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All of the companys rights, title and interest in and to all the benefits and interests from and under each assigned contract and the earnings an dby way of floating charge all the undertaking and assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Nib Capital Bank N.V.
    Transacciones
    • 08 nov 2004Registro de un cargo (395)
    • 23 mar 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of covenant
    Creado el 22 oct 2004
    Entregado el 08 nov 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the borrowers to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The companys rights title and interest in and to the ship, the owners insurances and all of the companys benefits and interests present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Nib Capital Bank N.V.
    Transacciones
    • 08 nov 2004Registro de un cargo (395)
    • 23 mar 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Ship mortgage
    Creado el 22 oct 2004
    Entregado el 08 nov 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the borrowers to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The container vessel M.V. "p&o nedlloyd genoa"registered under british flag under official number 901564 and includes any share or interest and her engines, machinery, boats, tackle, outfit, equipment, spare gear, fuel, consumable and other stores, belongings and appurtenances whether on board or ashore and whether owned on the date of the mortgage or thereafter acquired.
    Personas con derecho
    • Nib Capital Bank N.V.
    Transacciones
    • 08 nov 2004Registro de un cargo (395)
    • 23 mar 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    First priority statutory mortgage
    Creado el 22 oct 2004
    Entregado el 03 nov 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due by the borrowers to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    64/64TH shares in M.v "nedlloyd genoa" registered under the british flag under official number "901564" and its appurtenances.
    Personas con derecho
    • Kfw (Formerly K/a Kreditanstalt Fur Wiederaufbau)
    Transacciones
    • 03 nov 2004Registro de un cargo (395)
    • 23 mar 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    First assignment
    Creado el 22 oct 2004
    Entregado el 03 nov 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due by the borrowers to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All the assigners undertaking and all its assets and rights, the assets, the excluded assets and any other assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Kfw (Formerly K/a Kreditanstalt Fur Wiederaufbau)
    Transacciones
    • 03 nov 2004Registro de un cargo (395)
    • 23 mar 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of covenant
    Creado el 22 oct 2004
    Entregado el 03 nov 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Right title and interest in the property= the ship being the container vessel M.v "p&o nedlloyd genoa" registered under the british flag under official number "901564" including any share or interest therein, the engine, machinery, boats, tackle, outfit, equipment, share gear, fuel consumable and other stores. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Kfw (Formerly K/a Kreditanstalt Fur Wiederaufbau)
    Transacciones
    • 03 nov 2004Registro de un cargo (395)
    • 23 mar 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of covenants
    Creado el 05 abr 2004
    Entregado el 21 abr 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Mortgaged property being (a) the vessel (b) the insurances and (c) any lessor's requisition compensation. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Granite Shipping Company Limited
    Transacciones
    • 21 abr 2004Registro de un cargo (395)
    • 23 mar 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage of a ship
    Creado el 05 abr 2004
    Entregado el 21 abr 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All 64/64TH shares in the british flag "p&o nedlloyd genoa" official no. 901564.
    Personas con derecho
    • Granite Shipping Company Limited
    Transacciones
    • 21 abr 2004Registro de un cargo (395)
    • 23 mar 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of charge
    Creado el 05 abr 2004
    Entregado el 21 abr 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The account balances and all other rights, titles and interests of the company in and to the account.
    Personas con derecho
    • Granite Shipping Company Limited
    Transacciones
    • 21 abr 2004Registro de un cargo (395)
    • 23 mar 2016Satisfacción de una carga (MR04)

    ¿Tiene NEDLLOYD GENOA LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    28 jun 2016Inicio de la liquidación
    13 dic 2017Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Profesional
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0