EPISODE (GB) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaEPISODE (GB) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02413656
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de EPISODE (GB) LIMITED?

    • (5242) /

    ¿Dónde se encuentra EPISODE (GB) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    12 Gleneagles Court
    Brighton Road
    RH10 6AD Crawley
    West Sussex
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de EPISODE (GB) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    TOPPY U.K. LIMITED19 oct 198919 oct 1989
    BROOMCO (334) LIMITED16 ago 198916 ago 1989

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de EPISODE (GB) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 ene 2004

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para EPISODE (GB) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 29 sept 2010

    6 páginas4.68

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    7 páginas4.72

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 26 jul 2010

    7 páginas4.68

    Orden judicial de insolvencia

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    10 páginasLIQ MISC OC

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Aviso de cese de funciones como liquidador voluntario

    1 páginas4.40

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 26 ene 2010

    6 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 26 jul 2009

    6 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 26 ene 2009

    8 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 26 jul 2008

    6 páginas4.68

    Misceláneos

    Sec/state release of liquidator
    1 páginasMISC

    Declaración de recibos y pagos del liquidador

    8 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador

    8 páginas4.68

    Misceláneos

    C/O replacement liquidator
    15 páginasMISC

    Aviso de cese de funciones como liquidador voluntario

    1 páginas4.40

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Informe de progreso del administrador

    21 páginas2.24B

    Aviso de cambio de la administración a la liquidación voluntaria de acreedores

    21 páginas2.34B

    Aviso de renuncia de un administrador

    10 páginas2.38B

    Aviso de nombramiento de administrador suplente/adicional

    1 páginas2.40B

    Informe de progreso del administrador

    18 páginas2.24B

    Resultado de la reunión de acreedores

    3 páginas2.23B

    Declaración de asuntos

    6 páginas2.16B

    Declaración de la propuesta del administrador

    31 páginas2.17B

    ¿Quiénes son los directivos de EPISODE (GB) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ABOGADO NOMINEES LIMITED
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    Secretario designado corporativo
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    900021150001
    FANG, Jeffrey Fang
    27th Floor Block A Regent Centre
    63 Wo Yip Hop Road
    Kwai Chling New Territories
    Honk Kong
    Director
    27th Floor Block A Regent Centre
    63 Wo Yip Hop Road
    Kwai Chling New Territories
    Honk Kong
    ChinaIrish40581680004
    FOSTER, Paul Geoffrey
    4 Kenwood Rise
    Bramley
    S66 3YE Rotherham
    South Yorkshire
    Director
    4 Kenwood Rise
    Bramley
    S66 3YE Rotherham
    South Yorkshire
    United KingdomBritish94392530001
    MAN, Christine Fang Ma Sau
    27th Floor Block A Regent Centre
    63 Wo Yip Hop Road
    Kwai Chung New Territories
    Hong Kong
    Director
    27th Floor Block A Regent Centre
    63 Wo Yip Hop Road
    Kwai Chung New Territories
    Hong Kong
    Hong Konger40581720003
    FIELDHOUSE, Nicholas John Carpmael
    18 Furzefield Road
    RH2 7HG Reigate
    Surrey
    Secretario
    18 Furzefield Road
    RH2 7HG Reigate
    Surrey
    U.K.74928500001
    CHUTER, Michael David
    167 Mottingham Road
    SE9 4SS London
    Director
    167 Mottingham Road
    SE9 4SS London
    British106296490001
    MCKEON, Mark David
    New Forest Gate House
    Lyndhurst
    SO43 7GR Southampton
    Hampshire
    Director
    New Forest Gate House
    Lyndhurst
    SO43 7GR Southampton
    Hampshire
    British75187920001

    ¿Tiene EPISODE (GB) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Rent deposit deed
    Creado el 18 feb 2002
    Entregado el 01 mar 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £12,737.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    The company's right title and interest in and to the account in its name with the royal bank of scotland PLC (or such other bank as the landlord shall in its sole discretion decide) into which the deposit is from time to time paid.
    Personas con derecho
    • The Berkeley Festival Waterfront Company Limited
    Transacciones
    • 01 mar 2002Registro de un cargo (395)
    • 09 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Trust deed
    Creado el 11 feb 2000
    Entregado el 23 feb 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease
    Breve descripción
    The deposit account in to which the initial deposit of £11,441.56 has been placed.
    Personas con derecho
    • Baa Mcarthur/Glen (Swindon) Limited
    Transacciones
    • 23 feb 2000Registro de un cargo (395)
    • 09 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 24 abr 1998
    Entregado el 07 may 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 07 may 1998Registro de un cargo (395)
    • 09 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creado el 19 nov 1996
    Entregado el 20 nov 1996
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to christ's hospital under the provision of a lease of premises known as 21 church street kingston surrey dated 9TH may 1989 and the said rent deposit deed
    Breve descripción
    £16,250 deposited as security for all monies due under this deed.
    Personas con derecho
    • The Governors of Christ's Hospital
    Transacciones
    • 20 nov 1996Registro de un cargo (395)
    Deed of deposit
    Creado el 27 mar 1995
    Entregado el 29 mar 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a lease of even date
    Breve descripción
    The interest of the company in the deposit account being a high interest bearing account opened in the name of coutts and company (guernsey) limited and tipaza limited with a london clearing bank. The deposit balance at the date of deed is £5,625.00.. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Coutts and Company (Guernsey) Limited
    Transacciones
    • 29 mar 1995Registro de un cargo (395)
    • 09 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creado el 03 mar 1995
    Entregado el 18 mar 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the lease of even date and this charge
    Breve descripción
    The company's interest in the interest earning deposit account with the initial deposit of £49,200 and all monies withdrawn from the account in accordance with the deed.
    Personas con derecho
    • The Crown Estate Commissionerson Behalf of Her Majesty Acting in Exercise of the Powers of the Crown
    Transacciones
    • 18 mar 1995Registro de un cargo (395)
    • 09 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creado el 02 feb 1995
    Entregado el 08 feb 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £30,000.00
    Breve descripción
    First fixed charge the company's interest in the amount secured by the charge (including interest) as a continuing security for due and prompt performance of the covenants and the warranty on the part of the company contained in a lease dated 2 february 1995 relating to unit LG2 city plaza, birmingham.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Burford Acquisitions Limited
    Transacciones
    • 08 feb 1995Registro de un cargo (395)
    • 09 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed
    Creado el 15 abr 1994
    Entregado el 27 abr 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease of even date
    Breve descripción
    £ 55,313 together with interest credited to the deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Ropemaker Properties Limited
    Transacciones
    • 27 abr 1994Registro de un cargo (395)
    • 09 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security deposit deed
    Creado el 18 jun 1993
    Entregado el 09 jul 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 8TH august 1986
    Breve descripción
    The sum of £3,000 (the "deposit").
    Personas con derecho
    • Fogal of Switzerland (UK) Limited
    Transacciones
    • 09 jul 1993Registro de un cargo (395)
    • 09 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent security deposit deed
    Creado el 12 mar 1993
    Entregado el 30 mar 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease of even date
    Breve descripción
    £8,825 together with any interest credited to the deposit account (see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Ropemaker Properties Limited
    Transacciones
    • 30 mar 1993Registro de un cargo (395)
    • 09 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent security deposit deed
    Creado el 17 feb 1993
    Entregado el 22 feb 1993
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease
    Breve descripción
    The deposit of £110,627 together with all interest earned thereon.
    Personas con derecho
    • Ropemaker Properties Limited
    Transacciones
    • 22 feb 1993Registro de un cargo (395)

    ¿Tiene EPISODE (GB) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    29 jul 2005Inicio de la administración
    27 jul 2006Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Andrew John Tate
    Baker Tilly
    12 Gleneagles Court
    RH10 6AD Brighton Road
    Crawley West Sussex
    Profesional
    Baker Tilly
    12 Gleneagles Court
    RH10 6AD Brighton Road
    Crawley West Sussex
    John Ariel
    Baker Tilly
    12 Gleneagles Court
    RH10 6AD Brighton Road
    Crawley
    Profesional
    Baker Tilly
    12 Gleneagles Court
    RH10 6AD Brighton Road
    Crawley
    Karl Christopher Holmes
    Baker Tilly
    12 Gleneagles Court
    RH10 6AD Brighton Road
    Crawley West Sussex
    Profesional
    Baker Tilly
    12 Gleneagles Court
    RH10 6AD Brighton Road
    Crawley West Sussex
    2
    FechaTipo
    27 jul 2006Inicio de la liquidación
    07 ene 2011Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    John Ariel
    Baker Tilly
    12 Gleneagles Court
    RH10 6AD Brighton Road
    Crawley
    Profesional
    Baker Tilly
    12 Gleneagles Court
    RH10 6AD Brighton Road
    Crawley
    Karl Christopher Holmes
    Baker Tilly
    12 Gleneagles Court
    RH10 6AD Brighton Road
    Crawley West Sussex
    Profesional
    Baker Tilly
    12 Gleneagles Court
    RH10 6AD Brighton Road
    Crawley West Sussex
    Andrew White
    Baker Tilly
    First Floor International House
    BN1 3XE Queens Road
    Brighton
    Profesional
    Baker Tilly
    First Floor International House
    BN1 3XE Queens Road
    Brighton
    Matthew Richard Meadley Wild
    Baker Tilly The Clock House
    140 London Road
    GU1 1UW Guildford
    Surrey
    Profesional
    Baker Tilly The Clock House
    140 London Road
    GU1 1UW Guildford
    Surrey

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0