THE GREEN HOUSE BRISTOL
Visión general
| Nombre de la empresa | THE GREEN HOUSE BRISTOL |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited' |
| Número de empresa | 02414332 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de THE GREEN HOUSE BRISTOL?
- Otras actividades de asistencia sanitaria (86900) / Actividades sanitarias y de asistencia social
¿Dónde se encuentra THE GREEN HOUSE BRISTOL?
| Dirección de la sede social | St Agnes Lodge 45 Thomas Street St. Pauls BS2 9LJ Bristol England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de THE GREEN HOUSE BRISTOL?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| AVON SEXUAL ABUSE CENTRE | 11 feb 1997 | 11 feb 1997 |
| "THE CENTRE"- A COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY SERVICE FOR ADULT AND YOUNG WOMEN WHO HAVE BEEN SEXUALLY ABUSED | 29 feb 1996 | 29 feb 1996 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de THE GREEN HOUSE BRISTOL?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para THE GREEN HOUSE BRISTOL?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 01 nov 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 15 nov 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 01 nov 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE GREEN HOUSE BRISTOL?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2025 | 33 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2024 | 35 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Richard Owen Howell como director el 29 ago 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Anthony John Merrill como director el 12 sept 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mrs Jacqueline Anne Marshall-Dibble como director el 29 ago 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mrs Philippa Jayne Mcgrath como director el 01 ago 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Luca Conrad Maitland Dunkley como director el 01 ago 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Anthony John Merrill como director el 01 ago 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Nicholas Richard Marston como director el 02 jul 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Yasmin Hannah Metcalfe como director el 02 jul 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2023 | 30 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Dr Rob Senior como director el 01 dic 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cancelación total de la carga 024143320004 | 4 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga 024143320003 | 4 páginas | MR04 | ||
Nombramiento de Dr Lucy Martin como director el 26 ene 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Dr Susan O'connor como director el 26 ene 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Kamala Das como director el 26 ene 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2022 | 30 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Alan Rogan como secretario el 10 nov 2022 | 1 páginas | TM02 | ||
Cese del nombramiento de Karen Ann Michael-Cox como director el 10 nov 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Alan Rogan como director el 10 nov 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de THE GREEN HOUSE BRISTOL?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUNKLEY, Luca Conrad Maitland | Director | 45 Thomas Street St. Pauls BS2 9LJ Bristol St Agnes Lodge England | England | British,Italian | 326191680001 | |||||
| HOWELL, Richard Owen | Director | 45 Thomas Street St. Pauls BS2 9LJ Bristol St Agnes Lodge England | United Kingdom | British | 50034300002 | |||||
| LIVINGS, Stephen Michael | Director | 45 Thomas Street St. Pauls BS2 9LJ Bristol St Agnes Lodge England | United Kingdom | British | 65890550001 | |||||
| MARSHALL-DIBBLE, Jacqueline Anne | Director | 45 Thomas Street St. Pauls BS2 9LJ Bristol St Agnes Lodge England | England | British | 172356450001 | |||||
| MARTIN, Lucy, Dr | Director | 45 Thomas Street St. Pauls BS2 9LJ Bristol St Agnes Lodge England | England | British | 307234700001 | |||||
| MCGRATH, Philippa Jayne | Director | 45 Thomas Street St. Pauls BS2 9LJ Bristol St Agnes Lodge England | Wales | British | 326223060001 | |||||
| O'CONNOR, Susan, Dr | Director | 45 Thomas Street St. Pauls BS2 9LJ Bristol St Agnes Lodge England | England | British | 163056140001 | |||||
| REIBSTEIN, Janet, Professor | Director | 45 Thomas Street St. Pauls BS2 9LJ Bristol St Agnes Lodge England | England | British | 134768030002 | |||||
| SENIOR, Rob, Dr | Director | 45 Thomas Street St. Pauls BS2 9LJ Bristol St Agnes Lodge England | England | British | 314499490001 | |||||
| ALLEN, Joanne Georgina | Secretario | 16 Upper Belgrave Road Clifton BS8 2XH Bristol Avon | British | 78002690001 | ||||||
| BAILEY, Lynne | Secretario | 17 Bowden Road BS5 7AU Bristol | British | 49430100001 | ||||||
| LEWIS, Jennifer Veronis | Secretario | 3 St Albans Road Westbury Park BS6 7SF Bristol Avon | British | 30098690001 | ||||||
| MINNS, Sarah Jane Valerie | Secretario | 11 Cleave Street St Werburghs BS2 9UD Bristol Avon | British | 101502130001 | ||||||
| PEARSON, Suzanne | Secretario | 46 Hill Street Totterdown BS3 4TS Bristol Avon | British | 45104480001 | ||||||
| PEARSON, Suzanne | Secretario | 46 Hill Street Totterdown BS3 4TS Bristol Avon | British | 45104480001 | ||||||
| POLLOCK, Sue | Secretario | 25 Florence Park Westbury Park BS6 7LS Bristol Avon | British | 19010930001 | ||||||
| ROGAN, Alan, Dr | Secretario | 45 Thomas Street St. Pauls BS2 9LJ Bristol St Agnes Lodge England | 282174720001 | |||||||
| WELDON, Karen Aileen | Secretario | 101 Chelsea Road Easton BS5 6AS Bristol | British | 86513470002 | ||||||
| WETZ, James Anthony Ignatius | Secretario | 7 Redland Green Road Redland BS6 7HE Bristol Avon | British | 80613320001 | ||||||
| WIGHTMAN, Helen | Secretario | 33 Rockside Drive BS9 4NU Bristol | British | 60482330001 | ||||||
| ALLEN, Joanne Georgina | Director | 16 Upper Belgrave Road Clifton BS8 2XH Bristol Avon | British | 78002690001 | ||||||
| AYRES, Stella | Director | Tanglewood West Hay Road Udley Wrington BS40 5NR Bristol | British | 60482240001 | ||||||
| BAILEY, Lynne | Director | 17 Bowden Road BS5 7AU Bristol | British | 49430100001 | ||||||
| BARRY, Patricia | Director | Flat 1 Rosecroft 13 Alumhurst Road BH4 8EL Westbourne Dorset | Irish | 92062350001 | ||||||
| BATTEN, Cecilia, Dr | Director | 45 Thomas Street St. Pauls BS2 9LJ Bristol St Agnes Lodge England | England | British | 282174830001 | |||||
| BRICKWOOD, Barbara Jane | Director | 84 Holly Lodge Road Speedwell BS5 7UD Bristol Avon | British | 107743510001 | ||||||
| CAWOOD, Hazel | Director | 45 Thomas Street St. Pauls BS2 9LJ Bristol St Agnes Lodge England | England | British | 282235680002 | |||||
| COOPER, Justine | Director | 49 Barratt Street Easton BS5 6DE Bristol Avon | English | 30098680001 | ||||||
| DAS, Kamala | Director | 45 Thomas Street St. Pauls BS2 9LJ Bristol St Agnes Lodge England | England | British | 62340470003 | |||||
| DENNINGTON, Martin | Director | 2 Birchall Road BS6 7TT Bristol | British | 60482160001 | ||||||
| FERNANDO, Laetitia | Director | 45 Thomas Street St. Pauls BS2 9LJ Bristol St Agnes Lodge England | England | British | 282235660002 | |||||
| GAMSA, Helen | Director | 87 Berkeley Road Bishopston BS7 8HQ Bristol Avon | British | 68476180001 | ||||||
| HALLIWELL, Gemma, Dr | Director | 45 Thomas Street St. Pauls BS2 9LJ Bristol St Agnes Lodge England | England | British | 282174750002 | |||||
| HOWARD, Janet Adele Danziger | Director | 45 Thomas Street St. Pauls BS2 9LJ Bristol St Agnes Lodge England | United Kingdom | British | 110535030001 | |||||
| INSALL, Jennifer | Director | 31 Mendip Road Windmill Hill BS3 4PB Bristol | British | 49430150001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de THE GREEN HOUSE BRISTOL?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
|---|---|---|---|
| Mr Stephen Livings | 06 abr 2016 | 45 Thomas Street St. Pauls BS2 9LJ Bristol St Agnes Lodge England | No |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0