TELEWEST COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED

TELEWEST COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTELEWEST COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02415291
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TELEWEST COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED?

    • (7499) /

    ¿Dónde se encuentra TELEWEST COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Media House
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Hampshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TELEWEST COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HERON INVESTMENTS LIMITED21 ago 198921 ago 1989

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TELEWEST COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TELEWEST COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cambio de datos del secretario Gillian Elizabeth James el 31 mar 2011

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Robert Charles Gale el 31 mar 2011

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Joanne Christine Tillbrook como director el 16 sept 2011

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Joanne Christine Tillbrook como director el 16 sept 2011

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 30 sept 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital07 oct 2011

    Estado de capital el 07 oct 2011

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cese del nombramiento de Robert Mario Mackenzie como director el 16 sept 2011

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Joanne Christine Tillbrook como director el 16 sept 2011

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    4 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de 160 Great Portland Street London W1W 5QA el 31 mar 2011

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 30 sept 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    4 páginasAA

    Cese del nombramiento de Virgin Media Secretaries Limited como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Virgin Media Secretaries Limited como secretario

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Virgin Media Directors Limited como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Robert Mario Mackenzie como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Robert Charles Gale como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Gillian Elizabeth James como secretario

    1 páginasAP03

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2008

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 30 sept 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    legacy

    5 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2007

    4 páginasAA

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2006

    5 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de TELEWEST COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    JAMES, Gillian Elizabeth
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Secretario
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    151395930001
    GALE, Robert Charles
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Director
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish96956740001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Director
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    BURNS, Clive
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    Secretario
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    British71073800001
    HULL, Victoria Mary, Sol
    Flat 2
    53 Palace Gardens Terrace Kensington
    W8 4SB London
    Secretario
    Flat 2
    53 Palace Gardens Terrace Kensington
    W8 4SB London
    British77283810001
    LAVER, John Michael
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    Secretario
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    British8207040001
    QUADRANGLE SECRETARIES LIMITED
    95 The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    Gloucestershire
    Secretario designado corporativo
    95 The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    Gloucestershire
    900002950001
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Secretario corporativo
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    BURDICK, Charles James
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    Director
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    British-American52311710004
    COOK, Stephen Sands
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    Director
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    British73000530008
    DAVIDSON, Stephen James
    Hughenden Close
    Denner Hill
    HP16 0JJ Great Missenden
    Buckinghamshire
    Director
    Hughenden Close
    Denner Hill
    HP16 0JJ Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish92784240001
    HULL, Victoria Mary, Sol
    Flat 2
    53 Palace Gardens Terrace Kensington
    W8 4SB London
    Director
    Flat 2
    53 Palace Gardens Terrace Kensington
    W8 4SB London
    British77283810001
    ILLSLEY, Anthony Kim
    4 St Peters Road
    TW1 1QX Twickenham
    Middlesex
    Director
    4 St Peters Road
    TW1 1QX Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritish43836970001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Director
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish47785600002
    SMITH, Neil Reynolds
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    Director
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    British79956240002
    STENHAM, Anthony William Paul
    4 The Grove
    Highgate
    N6 6JU London
    Director
    4 The Grove
    Highgate
    N6 6JU London
    British8281170001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Director
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    VAN VALKENBURG, David Raynor
    Flat 6
    35/37 Grosvenor Square
    W1X 9AE London
    Director
    Flat 6
    35/37 Grosvenor Square
    W1X 9AE London
    American53941940001
    STOORNE SERVICES LIMITED
    95 The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    Gloucestershire
    Director corporativo
    95 The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    Gloucestershire
    55227800002
    STOORNE SERVICES LIMITED
    95 The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    Gloucestershire
    Director designado corporativo
    95 The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    Gloucestershire
    900002930001
    VIRGIN MEDIA DIRECTORS LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Director corporativo
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107430002
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Director corporativo
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002

    ¿Tiene TELEWEST COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee and debenture dated 26TH september 1998 made between (1)telewest communications networks limited,(1) the original charging subsidiaries (2) the original charging partnerships (3) and the toronto-dominion bank in its capacity as security trustee (4)
    Creado el 26 sept 1998
    Entregado el 08 oct 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies, obligations and liabilities whether actual or contingent which are covenanted or guaranteed to be paid by each chargor (as defined therein) to the chargees under or pursuant to the agreement dated 27TH march 1998 and/or the security trust deed and/or all or any of the other security documents (as defined)
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Toronto Dominion Bank (In Its Capacity as Security Trustee,Agent and First Beneficiary Under the Terms of the Debenture), the Arrangers and the Banks (or Any of Them).
    Transacciones
    • 08 oct 1998Registro de un cargo (395)
    • 01 jun 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental deed
    Creado el 09 abr 1998
    Entregado el 24 abr 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the agreement and/or the debenture and/or the security trust deed (all as defined)
    Breve descripción
    First fixed charge all f/hold and l/hold property vested in the company and all rights,title and/or interest in the assets,both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Cibc Wood Gundy PLC,as Security Trustee
    Transacciones
    • 24 abr 1998Registro de un cargo (395)
    • 01 jun 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0