TELEWEST COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | TELEWEST COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02415291 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de TELEWEST COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED?
- (7499) /
¿Dónde se encuentra TELEWEST COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED?
| Dirección de la sede social | Media House Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Hampshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TELEWEST COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| HERON INVESTMENTS LIMITED | 21 ago 1989 | 21 ago 1989 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de TELEWEST COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2010 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para TELEWEST COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Gillian Elizabeth James el 31 mar 2011 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cambio de datos del director Robert Charles Gale el 31 mar 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Joanne Christine Tillbrook como director el 16 sept 2011 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Joanne Christine Tillbrook como director el 16 sept 2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 sept 2011 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Robert Mario Mackenzie como director el 16 sept 2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Joanne Christine Tillbrook como director el 16 sept 2011 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 160 Great Portland Street London W1W 5QA el 31 mar 2011 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 sept 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Virgin Media Secretaries Limited como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Virgin Media Secretaries Limited como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Virgin Media Directors Limited como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Robert Mario Mackenzie como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Robert Charles Gale como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Gillian Elizabeth James como secretario | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2008 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 sept 2009 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
legacy | 5 páginas | 363a | ||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2007 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2006 | 5 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de TELEWEST COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMES, Gillian Elizabeth | Secretario | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | 151395930001 | |||||||
| GALE, Robert Charles | Director | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | England | British | 96956740001 | |||||
| TILLBROOK, Joanne Christine | Director | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | United Kingdom | British | 164134250001 | |||||
| BURNS, Clive | Secretario | The Cottage Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood AL4 8RX Wheathampstead Hertfordshire | British | 71073800001 | ||||||
| HULL, Victoria Mary, Sol | Secretario | Flat 2 53 Palace Gardens Terrace Kensington W8 4SB London | British | 77283810001 | ||||||
| LAVER, John Michael | Secretario | Brook House Homestead Road TN8 6JD Edenbridge Kent | British | 8207040001 | ||||||
| QUADRANGLE SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 95 The Promenade GL50 1WG Cheltenham Gloucestershire | 900002950001 | |||||||
| VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | 160 Great Portland Street W1W 5QA London | 101107380002 | |||||||
| BURDICK, Charles James | Director | 9 Ormonde Place SW1W 8HX London | British-American | 52311710004 | ||||||
| COOK, Stephen Sands | Director | 24a Redcliffe Square SW10 9JY London | British | 73000530008 | ||||||
| DAVIDSON, Stephen James | Director | Hughenden Close Denner Hill HP16 0JJ Great Missenden Buckinghamshire | United Kingdom | British | 92784240001 | |||||
| HULL, Victoria Mary, Sol | Director | Flat 2 53 Palace Gardens Terrace Kensington W8 4SB London | British | 77283810001 | ||||||
| ILLSLEY, Anthony Kim | Director | 4 St Peters Road TW1 1QX Twickenham Middlesex | United Kingdom | British | 43836970001 | |||||
| MACKENZIE, Robert Mario | Director | Great Portland Street W1W 5QA London 160 London United Kingdom | United Kingdom | British | 47785600002 | |||||
| SMITH, Neil Reynolds | Director | Brettwood Green Lane Churt GU10 2PA Farnham Surrey | British | 79956240002 | ||||||
| STENHAM, Anthony William Paul | Director | 4 The Grove Highgate N6 6JU London | British | 8281170001 | ||||||
| TILLBROOK, Joanne Christine | Director | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | United Kingdom | British | 164134250001 | |||||
| VAN VALKENBURG, David Raynor | Director | Flat 6 35/37 Grosvenor Square W1X 9AE London | American | 53941940001 | ||||||
| STOORNE SERVICES LIMITED | Director corporativo | 95 The Promenade GL50 1WG Cheltenham Gloucestershire | 55227800002 | |||||||
| STOORNE SERVICES LIMITED | Director designado corporativo | 95 The Promenade GL50 1WG Cheltenham Gloucestershire | 900002930001 | |||||||
| VIRGIN MEDIA DIRECTORS LIMITED | Director corporativo | 160 Great Portland Street W1W 5QA London | 101107430002 | |||||||
| VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED | Director corporativo | 160 Great Portland Street W1W 5QA London | 101107380002 |
¿Tiene TELEWEST COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee and debenture dated 26TH september 1998 made between (1)telewest communications networks limited,(1) the original charging subsidiaries (2) the original charging partnerships (3) and the toronto-dominion bank in its capacity as security trustee (4) | Creado el 26 sept 1998 Entregado el 08 oct 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies, obligations and liabilities whether actual or contingent which are covenanted or guaranteed to be paid by each chargor (as defined therein) to the chargees under or pursuant to the agreement dated 27TH march 1998 and/or the security trust deed and/or all or any of the other security documents (as defined) | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Supplemental deed | Creado el 09 abr 1998 Entregado el 24 abr 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the agreement and/or the debenture and/or the security trust deed (all as defined) | |
Breve descripción First fixed charge all f/hold and l/hold property vested in the company and all rights,title and/or interest in the assets,both present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0