CRANFIELD AEROSPACE SOLUTIONS LIMITED

CRANFIELD AEROSPACE SOLUTIONS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCRANFIELD AEROSPACE SOLUTIONS LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02415720
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CRANFIELD AEROSPACE SOLUTIONS LIMITED?

    • fabricación de aeronaves y naves espaciales y maquinaria relacionada (30300) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra CRANFIELD AEROSPACE SOLUTIONS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Trent House, (Part) 1st Floor University Way
    Wharley End
    MK43 0AN Cranfield
    Bedfordshire
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CRANFIELD AEROSPACE SOLUTIONS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CRANFIELD AEROSPACE LIMITED29 abr 199629 abr 1996
    CRANFIELD AERONAUTICAL RESEARCH LIMITED22 ago 198922 ago 1989

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CRANFIELD AEROSPACE SOLUTIONS LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 sept 2025
    Próximas cuentas vencen el30 jun 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CRANFIELD AEROSPACE SOLUTIONS LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta26 nov 2026
    Próxima declaración de confirmación vence10 dic 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta26 nov 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CRANFIELD AEROSPACE SOLUTIONS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Declaración de confirmación presentada el 26 nov 2025 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Florent Illat como director el 25 nov 2025

    1 páginasTM01

    Registro de la carga 024157200008, creada el 21 oct 2025

    52 páginasMR01

    Cese del nombramiento de Richard John Hulf como director el 12 ago 2025

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Christian Ziehe como director el 27 jun 2025

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa mediana preparadas hasta el 30 sept 2024

    30 páginasAA

    Cese del nombramiento de Paul Hutton como director el 27 mar 2025

    1 páginasTM01

    Cessation de Cranfield Group Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 ene 2023

    1 páginasPSC07

    Cese del nombramiento de Iain Gilmour Gray como director el 11 feb 2025

    1 páginasTM01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10

    Registro de la carga 024157200007, creada el 11 feb 2025

    52 páginasMR01

    Registro de la carga 024157200006, creada el 29 nov 2024

    27 páginasMR01

    Declaración de confirmación presentada el 26 nov 2024 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Richard John Hulf como director el 11 sept 2024

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de John Joseph Traynor como director el 11 sept 2024

    1 páginasTM01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2023

    31 páginasAA

    Registro de la carga 024157200005, creada el 27 mar 2024

    27 páginasMR01

    Domicilio social registrado cambiado de Hangar 2 Cranfield Airport Cranfield Bedford Bedfordshire MK43 0AL United Kingdom a Trent House, (Part) 1st Floor University Way Wharley End Cranfield Bedfordshire MK43 0AN el 12 dic 2023

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 26 nov 2023 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Registro de la carga 024157200004, creada el 28 sept 2023

    52 páginasMR01

    Domicilio social registrado cambiado de Hanger 2 Cranfield Airport Cranfield Bedfordshire MK43 0AL England a Hangar 2 Cranfield Airport Cranfield Bedford Bedfordshire MK43 0AL el 28 abr 2023

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2022

    25 páginasAA

    Segunda presentación de un estado de capital tras una asignación de acciones el 13 ene 2023

    • Capital: GBP 4,962,703
    5 páginasRP04SH01

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 13 ene 2023

    • Capital: GBP 4,962,703
    5 páginasSH01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    21 ene 2023Clarification A second filed SH01 was registered on 21/01/2023

    ¿Quiénes son los directivos de CRANFIELD AEROSPACE SOLUTIONS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CRAIG, Paul Anthony, Dr
    University Way
    Wharley End
    MK43 0AN Cranfield
    Trent House, (Part) 1st Floor
    Bedfordshire
    England
    Director
    University Way
    Wharley End
    MK43 0AN Cranfield
    Trent House, (Part) 1st Floor
    Bedfordshire
    England
    United KingdomBritish158430960004
    ZAWAIDEH, Samer Nawaf
    University Way
    Wharley End
    MK43 0AN Cranfield
    Trent House, (Part) 1st Floor
    Bedfordshire
    England
    Director
    University Way
    Wharley End
    MK43 0AN Cranfield
    Trent House, (Part) 1st Floor
    Bedfordshire
    England
    United Arab EmiratesJordanian301658770001
    ZIEHE, Christian
    c/o Sdf
    Adgm, Al Maryah Island
    6070
    Abu Dhabi
    19th Floor, Al Sarab Tower
    United Arab Emirates
    Director
    c/o Sdf
    Adgm, Al Maryah Island
    6070
    Abu Dhabi
    19th Floor, Al Sarab Tower
    United Arab Emirates
    United Arab EmiratesGerman337811120001
    ASPINALL, Philip John
    6 Octavian Drive
    Bancroft
    MK13 0PW Milton Keynes
    Secretario
    6 Octavian Drive
    Bancroft
    MK13 0PW Milton Keynes
    British44884380001
    BAILEY, Veronica Fay
    34 St Leonards Street
    MK42 9BS Bedford
    Secretario
    34 St Leonards Street
    MK42 9BS Bedford
    British38491730001
    CALVER, Nicholas John Henry
    7 Tempsford
    AL7 2PA Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Secretario
    7 Tempsford
    AL7 2PA Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British83961430001
    DI CATALDO, Sebastiano
    Cranfield University
    Cranfield
    MK43 0AL Bedford
    Secretario
    Cranfield University
    Cranfield
    MK43 0AL Bedford
    British131892640002
    MACIVER, Alasdair
    21 Upper Stone Hayes
    Great Linford
    MK14 5ER Milton Keynes
    Secretario
    21 Upper Stone Hayes
    Great Linford
    MK14 5ER Milton Keynes
    British59741150001
    MCCOMBIE, Stanley Thomas
    Gregor House
    Aston
    SG2 7EP Stevenage
    Hertfordshire
    Secretario
    Gregor House
    Aston
    SG2 7EP Stevenage
    Hertfordshire
    British1567130001
    PAY, Deborah Eileen
    4 Lichfield Close
    Kempston
    MK42 8UA Bedford
    Secretario
    4 Lichfield Close
    Kempston
    MK42 8UA Bedford
    British52359140001
    SMITH, Andrew Crawford
    The Tree House, Gransden Road
    Caxton
    CB3 8PL Cambridge
    Secretario
    The Tree House, Gransden Road
    Caxton
    CB3 8PL Cambridge
    British18718930002
    WILSON, Neil Philip
    14 Yew Tree Close
    MK45 4EQ Silsoe
    Bedfordshire
    Secretario
    14 Yew Tree Close
    MK45 4EQ Silsoe
    Bedfordshire
    British87759810001
    ALLERTON, David John
    34 Pemberley Avenue
    MK40 2LA Bedford
    Bedfordshire
    Director
    34 Pemberley Avenue
    MK40 2LA Bedford
    Bedfordshire
    British23297290001
    ASPINALL, Philip John
    6 Octavian Drive
    Bancroft
    MK13 0PW Milton Keynes
    Director
    6 Octavian Drive
    Bancroft
    MK13 0PW Milton Keynes
    EnglandBritish44884380001
    BATE, David Harry
    Bramley
    Court Lane
    MK43 7QT Stevington
    Bedfordshire
    Director
    Bramley
    Court Lane
    MK43 7QT Stevington
    Bedfordshire
    British1647050002
    CALVER, Nicholas John Henry
    7 Tempsford
    AL7 2PA Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Director
    7 Tempsford
    AL7 2PA Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British83961430001
    CHARLES, Darrel
    Partridge Lane
    Bromham
    MK43 8PQ Bedford
    26
    Bedfordshire
    England
    Director
    Partridge Lane
    Bromham
    MK43 8PQ Bedford
    26
    Bedfordshire
    England
    United KingdomBritish156181480001
    COPELAND, Garrett Anthony
    Cranfield University
    Cranfield
    MK43 0AL Bedford
    Director
    Cranfield University
    Cranfield
    MK43 0AL Bedford
    EnglandIrish246327890001
    CRAWFORD, Andrew Edward
    Cranfield Airport
    MK43 0AL Cranfield
    Hanger 2
    Bedfordshire
    England
    Director
    Cranfield Airport
    MK43 0AL Cranfield
    Hanger 2
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritish94857490001
    DI CATALDO, Sebastiano
    Cranfield University
    Cranfield
    MK43 0AL Bedford
    Director
    Cranfield University
    Cranfield
    MK43 0AL Bedford
    EnglandBritish131892640003
    DIXSON, Maurice Christopher Scott, Dr
    The Pound House
    Middle Common
    SN15 5NW Kington Langley
    Wiltshire
    Director
    The Pound House
    Middle Common
    SN15 5NW Kington Langley
    Wiltshire
    EnglandBritish92711120001
    DONOVAN, Ian Edward
    Lawn Farm
    Church Lane Tibberton
    WR9 7NW Droitwich
    Hereford & Worcester
    Director
    Lawn Farm
    Church Lane Tibberton
    WR9 7NW Droitwich
    Hereford & Worcester
    Great BritainBritish20848550002
    EARNSHAW, Christopher Martin
    West Common Way
    AL5 2LF Harpenden
    12
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Director
    West Common Way
    AL5 2LF Harpenden
    12
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish27476200001
    EVERITT, Denise Kim
    25 Park Road
    MK18 3DL Winslow
    Buckingham
    Director
    25 Park Road
    MK18 3DL Winslow
    Buckingham
    British44347530001
    FLETCHER, Ronald Stanley, Professor
    34 Brecon Way
    MK41 8DD Bedford
    Bedfordshire
    Director
    34 Brecon Way
    MK41 8DD Bedford
    Bedfordshire
    British2747120001
    GARDNER, David Paul
    30 Sheep Street
    Winslow
    MK18 3HN Buckingham
    Bucks
    Director
    30 Sheep Street
    Winslow
    MK18 3HN Buckingham
    Bucks
    United KingdomBritish48902750003
    GRAY, Iain Gilmour
    University Way
    Wharley End
    MK43 0AN Cranfield
    Trent House, (Part) 1st Floor
    Bedfordshire
    England
    Director
    University Way
    Wharley End
    MK43 0AN Cranfield
    Trent House, (Part) 1st Floor
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritish120882060001
    HOLLIDAY, Christopher William Andrew
    Cranfield Airport
    MK43 0AL Cranfield
    Hanger 2
    Bedfordshire
    England
    Director
    Cranfield Airport
    MK43 0AL Cranfield
    Hanger 2
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritish268642460001
    HOWE, Dennis
    57 Brecon Way
    MK41 8DE Bedford
    Bedfordshire
    Director
    57 Brecon Way
    MK41 8DE Bedford
    Bedfordshire
    British19515490001
    HULF, Richard John
    University Way
    Wharley End
    MK43 0AN Cranfield
    Trent House, (Part) 1st Floor
    Bedfordshire
    England
    Director
    University Way
    Wharley End
    MK43 0AN Cranfield
    Trent House, (Part) 1st Floor
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritish129889610004
    HUTTON, Paul
    University Way
    Wharley End
    MK43 0AN Cranfield
    Trent House, (Part) 1st Floor
    Bedfordshire
    England
    Director
    University Way
    Wharley End
    MK43 0AN Cranfield
    Trent House, (Part) 1st Floor
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritish197800730001
    ILLAT, Florent
    2 Bd Du Général Martial Valin
    75724 Paris Cedex 15
    Safran Corporate Ventures
    France
    Director
    2 Bd Du Général Martial Valin
    75724 Paris Cedex 15
    Safran Corporate Ventures
    France
    FranceFrench294041130001
    JOHN, Philip, Professor
    Wood End Hill
    AL5 3EZ Harpenden
    3
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Director
    Wood End Hill
    AL5 3EZ Harpenden
    3
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish96751630001
    JUPP, Jeffrey Addison
    21 Bloomfield Park
    BA2 2BY Bath
    Director
    21 Bloomfield Park
    BA2 2BY Bath
    United KingdomBritish34052060001
    KNIGHT, Michael William Patrick, Sir
    Craigwell
    Mortehoe
    EX34 7ED Woolacombe
    North Devon
    Director
    Craigwell
    Mortehoe
    EX34 7ED Woolacombe
    North Devon
    British65873590001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CRANFIELD AEROSPACE SOLUTIONS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    125 London Wall,
    EC2Y 5AS London,
    6th Floor
    United Kingdom
    22 abr 2022
    125 London Wall,
    EC2Y 5AS London,
    6th Floor
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro13664666
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    125 London Wall
    EC2Y 5AS London
    6th Floor
    England
    24 mar 2022
    125 London Wall
    EC2Y 5AS London
    6th Floor
    England
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro13407844
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    Cranfield Group Holdings Limited
    College Road
    Cranfield
    MK43 0AL Bedford
    Kent House
    England
    14 jul 2017
    College Road
    Cranfield
    MK43 0AL Bedford
    Kent House
    England
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    Autoridad legalCompanies Act
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.
    Cit Holdings Limited
    College Road
    Cranfield
    MK43 0AL Bedford
    Kent House
    England
    06 abr 2016
    College Road
    Cranfield
    MK43 0AL Bedford
    Kent House
    England
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Acts
    Lugar de registroEngland & Wales Companies House
    Número de registro04027553
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0