CRANFIELD AEROSPACE SOLUTIONS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CRANFIELD AEROSPACE SOLUTIONS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02415720 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CRANFIELD AEROSPACE SOLUTIONS LIMITED?
- fabricación de aeronaves y naves espaciales y maquinaria relacionada (30300) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra CRANFIELD AEROSPACE SOLUTIONS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Trent House, (Part) 1st Floor University Way Wharley End MK43 0AN Cranfield Bedfordshire England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CRANFIELD AEROSPACE SOLUTIONS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CRANFIELD AEROSPACE LIMITED | 29 abr 1996 | 29 abr 1996 |
| CRANFIELD AERONAUTICAL RESEARCH LIMITED | 22 ago 1989 | 22 ago 1989 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CRANFIELD AEROSPACE SOLUTIONS LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 sept 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 jun 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CRANFIELD AEROSPACE SOLUTIONS LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 26 nov 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 10 dic 2026 |
| Última declaraci ón de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 26 nov 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CRANFIELD AEROSPACE SOLUTIONS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 26 nov 2025 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Florent Illat como director el 25 nov 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Registro de la carga 024157200008, creada el 21 oct 2025 | 52 páginas | MR01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard John Hulf como director el 12 ago 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Christian Ziehe como director el 27 jun 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa mediana preparadas hasta el 30 sept 2024 | 30 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Hutton como director el 27 mar 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cessation de Cranfield Group Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 ene 2023 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Iain Gilmour Gray como director el 11 feb 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Registro de la carga 024157200007, creada el 11 feb 2025 | 52 páginas | MR01 | ||||||||||
Registro de la carga 024157200006, creada el 29 nov 2024 | 27 páginas | MR01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 26 nov 2024 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Richard John Hulf como director el 11 sept 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Joseph Traynor como director el 11 sept 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2023 | 31 páginas | AA | ||||||||||
Registro de la carga 024157200005, creada el 27 mar 2024 | 27 páginas | MR01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Hangar 2 Cranfield Airport Cranfield Bedford Bedfordshire MK43 0AL United Kingdom a Trent House, (Part) 1st Floor University Way Wharley End Cranfield Bedfordshire MK43 0AN el 12 dic 2023 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 26 nov 2023 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Registro de la carga 024157200004, creada el 28 sept 2023 | 52 páginas | MR01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Hanger 2 Cranfield Airport Cranfield Bedfordshire MK43 0AL England a Hangar 2 Cranfield Airport Cranfield Bedford Bedfordshire MK43 0AL el 28 abr 2023 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2022 | 25 páginas | AA | ||||||||||
Segunda presentación de un estado de capital tras una asignación de acciones el 13 ene 2023
| 5 páginas | RP04SH01 | ||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 13 ene 2023
| 5 páginas | SH01 | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CRANFIELD AEROSPACE SOLUTIONS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAIG, Paul Anthony, Dr | Director | University Way Wharley End MK43 0AN Cranfield Trent House, (Part) 1st Floor Bedfordshire England | United Kingdom | British | 158430960004 | |||||
| ZAWAIDEH, Samer Nawaf | Director | University Way Wharley End MK43 0AN Cranfield Trent House, (Part) 1st Floor Bedfordshire England | United Arab Emirates | Jordanian | 301658770001 | |||||
| ZIEHE, Christian | Director | c/o Sdf Adgm, Al Maryah Island 6070 Abu Dhabi 19th Floor, Al Sarab Tower United Arab Emirates | United Arab Emirates | German | 337811120001 | |||||
| ASPINALL, Philip John | Secretario | 6 Octavian Drive Bancroft MK13 0PW Milton Keynes | British | 44884380001 | ||||||
| BAILEY, Veronica Fay | Secretario | 34 St Leonards Street MK42 9BS Bedford | British | 38491730001 | ||||||
| CALVER, Nicholas John Henry | Secretario | 7 Tempsford AL7 2PA Welwyn Garden City Hertfordshire | British | 83961430001 | ||||||
| DI CATALDO, Sebastiano | Secretario | Cranfield University Cranfield MK43 0AL Bedford | British | 131892640002 | ||||||
| MACIVER, Alasdair | Secretario | 21 Upper Stone Hayes Great Linford MK14 5ER Milton Keynes | British | 59741150001 | ||||||
| MCCOMBIE, Stanley Thomas | Secretario | Gregor House Aston SG2 7EP Stevenage Hertfordshire | British | 1567130001 | ||||||
| PAY, Deborah Eileen | Secretario | 4 Lichfield Close Kempston MK42 8UA Bedford | British | 52359140001 | ||||||
| SMITH, Andrew Crawford | Secretario | The Tree House, Gransden Road Caxton CB3 8PL Cambridge | British | 18718930002 | ||||||
| WILSON, Neil Philip | Secretario | 14 Yew Tree Close MK45 4EQ Silsoe Bedfordshire | British | 87759810001 | ||||||
| ALLERTON, David John | Director | 34 Pemberley Avenue MK40 2LA Bedford Bedfordshire | British | 23297290001 | ||||||
| ASPINALL, Philip John | Director | 6 Octavian Drive Bancroft MK13 0PW Milton Keynes | England | British | 44884380001 | |||||
| BATE, David Harry | Director | Bramley Court Lane MK43 7QT Stevington Bedfordshire | British | 1647050002 | ||||||
| CALVER, Nicholas John Henry | Director | 7 Tempsford AL7 2PA Welwyn Garden City Hertfordshire | British | 83961430001 | ||||||
| CHARLES, Darrel | Director | Partridge Lane Bromham MK43 8PQ Bedford 26 Bedfordshire England | United Kingdom | British | 156181480001 | |||||
| COPELAND, Garrett Anthony | Director | Cranfield University Cranfield MK43 0AL Bedford | England | Irish | 246327890001 | |||||
| CRAWFORD, Andrew Edward | Director | Cranfield Airport MK43 0AL Cranfield Hanger 2 Bedfordshire England | England | British | 94857490001 | |||||
| DI CATALDO, Sebastiano | Director | Cranfield University Cranfield MK43 0AL Bedford | England | British | 131892640003 | |||||
| DIXSON, Maurice Christopher Scott, Dr | Director | The Pound House Middle Common SN15 5NW Kington Langley Wiltshire | England | British | 92711120001 | |||||
| DONOVAN, Ian Edward | Director | Lawn Farm Church Lane Tibberton WR9 7NW Droitwich Hereford & Worcester | Great Britain | British | 20848550002 | |||||
| EARNSHAW, Christopher Martin | Director | West Common Way AL5 2LF Harpenden 12 Hertfordshire United Kingdom | England | British | 27476200001 | |||||
| EVERITT, Denise Kim | Director | 25 Park Road MK18 3DL Winslow Buckingham | British | 44347530001 | ||||||
| FLETCHER, Ronald Stanley, Professor | Director | 34 Brecon Way MK41 8DD Bedford Bedfordshire | British | 2747120001 | ||||||
| GARDNER, David Paul | Director | 30 Sheep Street Winslow MK18 3HN Buckingham Bucks | United Kingdom | British | 48902750003 | |||||
| GRAY, Iain Gilmour | Director | University Way Wharley End MK43 0AN Cranfield Trent House, (Part) 1st Floor Bedfordshire England | England | British | 120882060001 | |||||
| HOLLIDAY, Christopher William Andrew | Director | Cranfield Airport MK43 0AL Cranfield Hanger 2 Bedfordshire England | England | British | 268642460001 | |||||
| HOWE, Dennis | Director | 57 Brecon Way MK41 8DE Bedford Bedfordshire | British | 19515490001 | ||||||
| HULF, Richard John | Director | University Way Wharley End MK43 0AN Cranfield Trent House, (Part) 1st Floor Bedfordshire England | England | British | 129889610004 | |||||
| HUTTON, Paul | Director | University Way Wharley End MK43 0AN Cranfield Trent House, (Part) 1st Floor Bedfordshire England | England | British | 197800730001 | |||||
| ILLAT, Florent | Director | 2 Bd Du Général Martial Valin 75724 Paris Cedex 15 Safran Corporate Ventures France | France | French | 294041130001 | |||||
| JOHN, Philip, Professor | Director | Wood End Hill AL5 3EZ Harpenden 3 Hertfordshire United Kingdom | England | British | 96751630001 | |||||
| JUPP, Jeffrey Addison | Director | 21 Bloomfield Park BA2 2BY Bath | United Kingdom | British | 34052060001 | |||||
| KNIGHT, Michael William Patrick, Sir | Director | Craigwell Mortehoe EX34 7ED Woolacombe North Devon | British | 65873590001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CRANFIELD AEROSPACE SOLUTIONS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydrogenone Capital Growth (Nominee) Limited | 22 abr 2022 | 125 London Wall, EC2Y 5AS London, 6th Floor United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Hydrogenone Capital Growth (Gp) Limited | 24 mar 2022 | 125 London Wall EC2Y 5AS London 6th Floor England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Cranfield Group Holdings Limited | 14 jul 2017 | College Road Cranfield MK43 0AL Bedford Kent House England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Cit Holdings Limited | 06 abr 2016 | College Road Cranfield MK43 0AL Bedford Kent House England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0