TARGETBASE CLAYDON HEELEY LIMITED

TARGETBASE CLAYDON HEELEY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTARGETBASE CLAYDON HEELEY LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02421407
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TARGETBASE CLAYDON HEELEY LIMITED?

    • Agencias de publicidad (73110) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra TARGETBASE CLAYDON HEELEY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Bankside 3
    90 - 100 Southwark Street
    SE1 0SW London
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TARGETBASE CLAYDON HEELEY LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ZULU NETWORK LIMITED08 may 200608 may 2006
    CLAYDON HEELEY JONES MASON LIMITED31 ene 200131 ene 2001
    CLAYDON HEELEY INTERNATIONAL LIMITED01 may 199201 may 1992
    CLAYDON HEELEY CAULFIELD LIMITED10 nov 198910 nov 1989
    MODPASS LIMITED11 sept 198911 sept 1989

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TARGETBASE CLAYDON HEELEY LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TARGETBASE CLAYDON HEELEY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cambio de datos del director Mr Paul Ian Tomlinson el 10 jun 2022

    2 páginasCH01

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Estado de capital el 26 nov 2021

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    legacy

    1 páginasSH20

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Declaración de confirmación presentada el 25 jun 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2019

    15 páginasAA

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    legacy

    58 páginasPARENT_ACC

    legacy

    2 páginasAGREEMENT2

    Nombramiento de Mr Paul Ian Tomlinson como director el 28 oct 2020

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Dennis Paul Gillespie como director el 28 oct 2020

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 25 jun 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2018

    11 páginasAA

    legacy

    52 páginasPARENT_ACC

    legacy

    2 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Declaración de confirmación presentada el 25 jun 2019 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Modification des détails de Das Uk Investments Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 sept 2018

    2 páginasPSC05

    Nombramiento de Mr John Martin William Betts como director el 30 sept 2018

    2 páginasAP01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2017

    11 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de TARGETBASE CLAYDON HEELEY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BRAY, Sally Ann
    90 - 100 Southwark Street
    SE1 0SW London
    Bankside 3
    England
    Secretario
    90 - 100 Southwark Street
    SE1 0SW London
    Bankside 3
    England
    British51704000002
    BETTS, John Martin William
    Level 1, 100 Southwark Street
    SE1 0SW London
    Bankside 2
    England
    Director
    Level 1, 100 Southwark Street
    SE1 0SW London
    Bankside 2
    England
    EnglandBritish251270030001
    TOMLINSON, Paul Ian
    90 - 100 Southwark Street
    SE1 0SW London
    Bankside 3
    England
    Director
    90 - 100 Southwark Street
    SE1 0SW London
    Bankside 3
    England
    EnglandBritish131839560002
    CRICHTON, Benjamin Stuart
    80 Brook Street
    Mayfair
    W1Y 2DD London
    Secretario
    80 Brook Street
    Mayfair
    W1Y 2DD London
    British75582630001
    JOHNSTONE, Alexandra Renee
    1 Battersea Bridge
    SW11 3BZ London
    The Glassmill
    United Kingdom
    Secretario
    1 Battersea Bridge
    SW11 3BZ London
    The Glassmill
    United Kingdom
    British124292030001
    MCKENZIE, Kathryn Marie
    21 Craneford Way
    TW2 7SB Twickenham
    Middlesex
    Secretario
    21 Craneford Way
    TW2 7SB Twickenham
    Middlesex
    British28995640001
    METCALFE, Neil Barrie
    20 Gordonbrock Road
    Brockley
    SE4 1JB London
    Secretario
    20 Gordonbrock Road
    Brockley
    SE4 1JB London
    British50730180001
    WOOLLEY, Diana Rosemary
    Humphries Bar
    Naunton
    GL54 3AS Cheltenham
    Gloucestershire
    Secretario
    Humphries Bar
    Naunton
    GL54 3AS Cheltenham
    Gloucestershire
    British66518590002
    BIRKIN, Michael John
    Azabudai 3-3-1, Minato-Ku
    Tokyo
    106 0041
    Japan
    Director
    Azabudai 3-3-1, Minato-Ku
    Tokyo
    106 0041
    Japan
    British23500200007
    BROOKS, Martin Lawrence
    4 Royal Crescent
    BN2 1AL Brighton
    East Sussex
    Director
    4 Royal Crescent
    BN2 1AL Brighton
    East Sussex
    British87257940001
    CAMPBELL, Leo Walter Dubois
    15 Northmoor Road
    OX2 6UW Oxford
    Director
    15 Northmoor Road
    OX2 6UW Oxford
    United KingdomBritish50402850004
    CLAYDON, Jonathan Kent
    23 Stanley Gardens
    W11 2NG London
    Director
    23 Stanley Gardens
    W11 2NG London
    United KingdomBritish65705670001
    CURRAN, Brian William
    Strand
    5th Floor
    WC2R 0DW London
    85
    England
    Director
    Strand
    5th Floor
    WC2R 0DW London
    85
    England
    UsaBritish130983460002
    EASTMAN, David Alexander
    770 Jellicoe House
    St George House
    SW8 2JF London
    Director
    770 Jellicoe House
    St George House
    SW8 2JF London
    British126647060001
    EMSELL, Brian Richard
    Cairndale
    Hawkshill
    KT22 9DS Leatherhead
    Surrey
    Director
    Cairndale
    Hawkshill
    KT22 9DS Leatherhead
    Surrey
    British8234350002
    GILLESPIE, Dennis Paul
    90 Southwark Street
    SE1 0SW London
    Bankside 2
    England
    Director
    90 Southwark Street
    SE1 0SW London
    Bankside 2
    England
    EnglandAmerican133085520003
    GORDON, Christopher John
    Malvern House
    Crabtree Drive Givons Grove
    KT22 8LG Leatherhead
    Surrey
    Director
    Malvern House
    Crabtree Drive Givons Grove
    KT22 8LG Leatherhead
    Surrey
    British40451110005
    GROUT, Steven Robert
    1 Battersea Bridge
    SW11 3BZ London
    The Glassmill
    United Kingdom
    Director
    1 Battersea Bridge
    SW11 3BZ London
    The Glassmill
    United Kingdom
    United KingdomEnglish85793050001
    HARMAN, Jonathan James
    Shortfield Cottage
    Hamlash Lane, Frensham
    GU10 3AU Farnham
    Surrey
    Director
    Shortfield Cottage
    Hamlash Lane, Frensham
    GU10 3AU Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish117302830001
    HEELEY, Mark Adrian
    125 Old Church Street
    SW3 6EB London
    Director
    125 Old Church Street
    SW3 6EB London
    British43917230004
    JONES, Nigel Michael
    11 St James's Drive
    Wandsworth Common
    SW17 7RN London
    Director
    11 St James's Drive
    Wandsworth Common
    SW17 7RN London
    EnglandBritish110577900001
    MASON, Edward Geoffrey
    Bridge Farm
    Kettlebaston
    IP7 7QE Ipswich
    Suffolk
    Director
    Bridge Farm
    Kettlebaston
    IP7 7QE Ipswich
    Suffolk
    British55600400002
    MUIRHEAD, William Mortimer
    "Knowl Wood"
    29 Park Avenue
    BR6 8LJ Farnborough Park
    Kent
    Director
    "Knowl Wood"
    29 Park Avenue
    BR6 8LJ Farnborough Park
    Kent
    EnglandBritish167103390001
    PENROSE, Noel Richard
    Dunvegan House The Street
    Shurlock Row
    RG10 0PR Reading
    Berkshire
    Director
    Dunvegan House The Street
    Shurlock Row
    RG10 0PR Reading
    Berkshire
    EnglandBritish41781310002
    RABL, Preston Martin Charles
    Winterbourne Manor
    Winterbourne
    RG20 8AU Newbury
    Berkshire
    Director
    Winterbourne Manor
    Winterbourne
    RG20 8AU Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish11309910003
    RUSH, Emma Jane
    1 Battersea Bridge Road
    SW11 3BZ London
    Glassmill
    England
    Director
    1 Battersea Bridge Road
    SW11 3BZ London
    Glassmill
    England
    EnglandBritish182773300001
    SCHOLES, David
    1 Battersea Bridge
    SW11 3BZ London
    The Glassmill
    United Kingdom
    Director
    1 Battersea Bridge
    SW11 3BZ London
    The Glassmill
    United Kingdom
    United StatesUnited States Citizen131753500002
    TRUEMAN, Peter Douglas
    100 Southwark Street
    SE1 0SW London
    Bankside 2
    England
    Director
    100 Southwark Street
    SE1 0SW London
    Bankside 2
    England
    United KingdomBritish11272780002
    TRUEMAN, Peter Douglas
    Old Marylebone Road
    NW1 5QT London
    239
    England
    Director
    Old Marylebone Road
    NW1 5QT London
    239
    England
    United KingdomBritish11272780002
    WHITWORTH, James Christopher Bardsley
    239 Old Marylebone Road
    London
    NW1 5QT
    Director
    239 Old Marylebone Road
    London
    NW1 5QT
    EnglandCanadian75258220001
    WREFORD, Anthony William
    55 Cheyne Court
    Flood Street
    SW3 5TS London
    Director
    55 Cheyne Court
    Flood Street
    SW3 5TS London
    EnglandBritish33049310001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de TARGETBASE CLAYDON HEELEY LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    90-100 Southwark Street
    SE1 0SW London
    Bankside 3
    England
    06 abr 2016
    90-100 Southwark Street
    SE1 0SW London
    Bankside 3
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro3097778
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene TARGETBASE CLAYDON HEELEY LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal mortgage
    Creado el 06 may 1997
    Entregado el 09 may 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a office premises 1 battersea bridge road london borough of wandsworth t/n-TGL33056 and/or the proceeds of sale thereof, floating charge over all moveable plant, machinery, implements, utensils, furniture and equipment, and an assignment of the goodwill and connection of any business, together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 09 may 1997Registro de un cargo (395)
    • 05 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 15 dic 1995
    Entregado el 27 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The l/h property k/a first floor the glassmill 1 battersea bridge road london borough of wandsworth t/n TGL7508,TGL7534,TGL7546 and TGL7550 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 27 dic 1995Registro de un cargo (395)
    • 05 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 24 ene 1994
    Entregado el 25 ene 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Tsb Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 25 ene 1994Registro de un cargo (395)
    • 15 ago 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creado el 07 may 1992
    Entregado el 27 may 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date
    Breve descripción
    The companys interest in the sum of £15,975.
    Personas con derecho
    • Sir Michael William Bunbury
    • Charles Christian Nicholson
    • The Right Honorable Simon Dallas Earl Cairns
    • James Nicholas Stones
    Transacciones
    • 27 may 1992Registro de un cargo (395)
    • 27 sept 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 30 may 1990
    Entregado el 20 jun 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 20 jun 1990Registro de una carga
    • 21 nov 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0