TARGETBASE CLAYDON HEELEY LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | TARGETBASE CLAYDON HEELEY LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02421407 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de TARGETBASE CLAYDON HEELEY LIMITED?
- Agencias de publicidad (73110) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra TARGETBASE CLAYDON HEELEY LIMITED?
| Dirección de la sede social | Bankside 3 90 - 100 Southwark Street SE1 0SW London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TARGETBASE CLAYDON HEELEY LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ZULU NETWORK LIMITED | 08 may 2006 | 08 may 2006 |
| CLAYDON HEELEY JONES MASON LIMITED | 31 ene 2001 | 31 ene 2001 |
| CLAYDON HEELEY INTERNATIONAL LIMITED | 01 may 1992 | 01 may 1992 |
| CLAYDON HEELEY CAULFIELD LIMITED | 10 nov 1989 | 10 nov 1989 |
| MODPASS LIMITED | 11 sept 1989 | 11 sept 1989 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de TARGETBASE CLAYDON HEELEY LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para TARGETBASE CLAYDON HEELEY LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Paul Ian Tomlinson el 10 jun 2022 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria | 1 páginas | DISS40 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Estado de capital el 26 nov 2021
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 25 jun 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2019 | 15 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 58 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 2 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Paul Ian Tomlinson como director el 28 oct 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Dennis Paul Gillespie como director el 28 oct 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 25 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2018 | 11 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 52 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 2 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 25 jun 2019 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Das Uk Investments Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 sept 2018 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Nombramiento de Mr John Martin William Betts como director el 30 sept 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2017 | 11 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de TARGETBASE CLAYDON HEELEY LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAY, Sally Ann | Secretario | 90 - 100 Southwark Street SE1 0SW London Bankside 3 England | British | 51704000002 | ||||||
| BETTS, John Martin William | Director | Level 1, 100 Southwark Street SE1 0SW London Bankside 2 England | England | British | 251270030001 | |||||
| TOMLINSON, Paul Ian | Director | 90 - 100 Southwark Street SE1 0SW London Bankside 3 England | England | British | 131839560002 | |||||
| CRICHTON, Benjamin Stuart | Secretario | 80 Brook Street Mayfair W1Y 2DD London | British | 75582630001 | ||||||
| JOHNSTONE, Alexandra Renee | Secretario | 1 Battersea Bridge SW11 3BZ London The Glassmill United Kingdom | British | 124292030001 | ||||||
| MCKENZIE, Kathryn Marie | Secretario | 21 Craneford Way TW2 7SB Twickenham Middlesex | British | 28995640001 | ||||||
| METCALFE, Neil Barrie | Secretario | 20 Gordonbrock Road Brockley SE4 1JB London | British | 50730180001 | ||||||
| WOOLLEY, Diana Rosemary | Secretario | Humphries Bar Naunton GL54 3AS Cheltenham Gloucestershire | British | 66518590002 | ||||||
| BIRKIN, Michael John | Director | Azabudai 3-3-1, Minato-Ku Tokyo 106 0041 Japan | British | 23500200007 | ||||||
| BROOKS, Martin Lawrence | Director | 4 Royal Crescent BN2 1AL Brighton East Sussex | British | 87257940001 | ||||||
| CAMPBELL, Leo Walter Dubois | Director | 15 Northmoor Road OX2 6UW Oxford | United Kingdom | British | 50402850004 | |||||
| CLAYDON, Jonathan Kent | Director | 23 Stanley Gardens W11 2NG London | United Kingdom | British | 65705670001 | |||||
| CURRAN, Brian William | Director | Strand 5th Floor WC2R 0DW London 85 England | Usa | British | 130983460002 | |||||
| EASTMAN, David Alexander | Director | 770 Jellicoe House St George House SW8 2JF London | British | 126647060001 | ||||||
| EMSELL, Brian Richard | Director | Cairndale Hawkshill KT22 9DS Leatherhead Surrey | British | 8234350002 | ||||||
| GILLESPIE, Dennis Paul | Director | 90 Southwark Street SE1 0SW London Bankside 2 England | England | American | 133085520003 | |||||
| GORDON, Christopher John | Director | Malvern House Crabtree Drive Givons Grove KT22 8LG Leatherhead Surrey | British | 40451110005 | ||||||
| GROUT, Steven Robert | Director | 1 Battersea Bridge SW11 3BZ London The Glassmill United Kingdom | United Kingdom | English | 85793050001 | |||||
| HARMAN, Jonathan James | Director | Shortfield Cottage Hamlash Lane, Frensham GU10 3AU Farnham Surrey | United Kingdom | British | 117302830001 | |||||
| HEELEY, Mark Adrian | Director | 125 Old Church Street SW3 6EB London | British | 43917230004 | ||||||
| JONES, Nigel Michael | Director | 11 St James's Drive Wandsworth Common SW17 7RN London | England | British | 110577900001 | |||||
| MASON, Edward Geoffrey | Director | Bridge Farm Kettlebaston IP7 7QE Ipswich Suffolk | British | 55600400002 | ||||||
| MUIRHEAD, William Mortimer | Director | "Knowl Wood" 29 Park Avenue BR6 8LJ Farnborough Park Kent | England | British | 167103390001 | |||||
| PENROSE, Noel Richard | Director | Dunvegan House The Street Shurlock Row RG10 0PR Reading Berkshire | England | British | 41781310002 | |||||
| RABL, Preston Martin Charles | Director | Winterbourne Manor Winterbourne RG20 8AU Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 11309910003 | |||||
| RUSH, Emma Jane | Director | 1 Battersea Bridge Road SW11 3BZ London Glassmill England | England | British | 182773300001 | |||||
| SCHOLES, David | Director | 1 Battersea Bridge SW11 3BZ London The Glassmill United Kingdom | United States | United States Citizen | 131753500002 | |||||
| TRUEMAN, Peter Douglas | Director | 100 Southwark Street SE1 0SW London Bankside 2 England | United Kingdom | British | 11272780002 | |||||
| TRUEMAN, Peter Douglas | Director | Old Marylebone Road NW1 5QT London 239 England | United Kingdom | British | 11272780002 | |||||
| WHITWORTH, James Christopher Bardsley | Director | 239 Old Marylebone Road London NW1 5QT | England | Canadian | 75258220001 | |||||
| WREFORD, Anthony William | Director | 55 Cheyne Court Flood Street SW3 5TS London | England | British | 33049310001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de TARGETBASE CLAYDON HEELEY LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Das Uk Investments Limited | 06 abr 2016 | 90-100 Southwark Street SE1 0SW London Bankside 3 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene TARGETBASE CLAYDON HEELEY LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Creado el 06 may 1997 Entregado el 09 may 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción L/H property k/a office premises 1 battersea bridge road london borough of wandsworth t/n-TGL33056 and/or the proceeds of sale thereof, floating charge over all moveable plant, machinery, implements, utensils, furniture and equipment, and an assignment of the goodwill and connection of any business, together with the full benefit of all licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal mortgage | Creado el 15 dic 1995 Entregado el 27 dic 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The l/h property k/a first floor the glassmill 1 battersea bridge road london borough of wandsworth t/n TGL7508,TGL7534,TGL7546 and TGL7550 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 24 ene 1994 Entregado el 25 ene 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Rent deposit deed | Creado el 07 may 1992 Entregado el 27 may 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date | |
Breve descripción The companys interest in the sum of £15,975. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 30 may 1990 Entregado el 20 jun 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0