WOLVERHAMPTON AREA RADIO LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | WOLVERHAMPTON AREA RADIO LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02424035 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de WOLVERHAMPTON AREA RADIO LIMITED?
- Radiodifusión (60100) / Información y comunicación
¿Dónde se encuentra WOLVERHAMPTON AREA RADIO LIMITED?
| Dirección de la sede social | 1 London Bridge Street SE1 9GF London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WOLVERHAMPTON AREA RADIO LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MIDLAND NEWS GROUP LIMITED | 15 nov 1989 | 15 nov 1989 |
| PAGEVINE LIMITED | 19 sept 1989 | 19 sept 1989 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de WOLVERHAMPTON AREA RADIO LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 28 jun 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para WOLVERHAMPTON AREA RADIO LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 jul 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 jun 2020 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 jul 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2019 | 5 páginas | AA | ||||||||||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 jul 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 01 jul 2018 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 jul 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Scott William Taunton el 02 mar 2018 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2017 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Anthony David Tompkins como director el 30 sept 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 jul 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 10 jun 2017 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Norman Mckeown como director el 30 abr 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2016 au 30 jun 2017 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Michael Charles Gill como director el 30 nov 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Christopher Charles Stoddart Longcroft como director el 30 nov 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Anthony Tompkins como secretario el 30 nov 2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Scott William Taunton el 19 dic 2016 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Ground Floor 401 Faraday Street, Birchwood Park Warrington WA3 6GA England a 1 London Bridge Street London SE1 9GF el 02 dic 2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 10 jun 2016 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de WOLVERHAMPTON AREA RADIO LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILL, Michael Charles | Director | London Bridge Street SE1 9GF London 1 England | United Kingdom | British | 123013340001 | |||||
| LONGCROFT, Christopher Charles Stoddart | Director | London Bridge Street SE1 9GF London 1 England | England | British | 163116880001 | |||||
| TAUNTON, Scott William | Director | London Bridge Street SE1 9GF London 1 United Kingdom | United Kingdom | Australian | 80505610007 | |||||
| DOWNEY, James Robinson | Secretario | 33 Karrington Heights Comber Road Dundonald BT16 1XZ Belfast County Antrim Northern Ireland | British | 107097580001 | ||||||
| EVERS, Graham William | Secretario | Green Leys Stourbridge Road WV5 9BN Wombourne South Staffs | British | 1518570002 | ||||||
| FRANCIS, Sharon Lesley | Secretario | 3 Primrose Close DL16 7YE Spennymoor County Durham | British | 72419260001 | ||||||
| LAWRENCE, Eric Alexander | Secretario | 26 Foxhills Covert Whickham NE16 5TN Newcastle Upon Tyne | British | 4250810002 | ||||||
| MADDOX, Peter | Secretario | Beech House Farm Chesterton Road, Pattingham WV6 7BJ Wolverhampton West Midlands | British | 8711640004 | ||||||
| MADDOX, Simon Christopher Peter | Secretario | Amberley Great Moor Road Pattingham WV6 7AU Wolverhampton West Midlands | British | 32709600002 | ||||||
| MILLARD, Andrew Clive | Secretario | 44 Cranmere Avenue WV6 8TS Wolverhampton | British | 63339300001 | ||||||
| SADLER, Keith John | Secretario | 12 Parrys Grove Stoke Bishop BS9 1TT Bristol Avon | British | 73173100006 | ||||||
| TOMPKINS, Anthony | Secretario | London Bridge Street SE1 9GF London 1 England | 165681330001 | |||||||
| ADDISON, Nigel Mark | Director | 8 Westbourne TF7 5QJ Woodside Salop | British | 76665560001 | ||||||
| ALLATT, John David | Director | Lerida Haughton Lane TF11 8HW Shifnal Shropshire | British | 1518610001 | ||||||
| ANDREWS, John Leslie | Director | Olde Orchards Upper Westbeech WV6 7HG Pattingham South Staffordshire | United Kingdom | British | 869230001 | |||||
| AUBREY FLETCHER, Henry Egerton, Sir | Director | Town Hill Farm Dorton Road Chilton HP18 9NA Aylesbury Buckinghamshire | United Kingdom | British | 22980850001 | |||||
| BLAKEMORE, Bernard | Director | Stableford Hall Stableford WV15 5LS Bridgnorth Salop | British | 47714620001 | ||||||
| BRUEN, Sean Lingard | Director | Bramhope 18 Eldorado Crescent GL50 2PY Cheltenham Gloucestershire | British | 48105890001 | ||||||
| CLAYTON, David Frederick George | Director | Greaves Cottage Greaves Lane Draycott In The Clay DE6 5BY Ashbourne Derbyshire | United Kingdom | British | 45420480001 | |||||
| DAVIES, Ian Alexander | Director | Park Farm Barn Topcroft NR35 2BE Bungay Suffolk | British | 58318990002 | ||||||
| DAVIES, Jane | Director | 6 Westbeech Road Pattingham WV6 7AQ Wolverhampton | British | 72904960002 | ||||||
| DENNING, John Howard, Dr | Director | 76 Trotsworth Court GU25 4AH Virginia Water Surrey | British | 66785870002 | ||||||
| DOWNEY, James Robinson | Director | 33 Karrington Heights Comber Road Dundonald BT16 1XZ Belfast County Antrim Northern Ireland | United Kingdom | British | 107097580001 | |||||
| EVERS, Graham William | Director | Green Leys Stourbridge Road WV5 9BN Wombourne South Staffs | British | 1518570002 | ||||||
| FLANAGAN, Mark Simon | Director | 14 Denehurst Gardens W3 9QY London | British | 69776160004 | ||||||
| JEFFRIES, Emma | Director | 19 Riverbank Close CW5 5YF Nantwich Cheshire | British | 69226560001 | ||||||
| JONES, Michael Adrian | Director | 3 Old Shaftesbury Drive Old Blandford Road Harnham SP2 8QH Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | 77984700001 | |||||
| JOSEPHS, John Irving | Director | 22 Osbaldeston Gardens NE3 4JE Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | 3830990001 | |||||
| KERSEN, Mark | Director | Knowlegate Church Lane TF11 8RD Sheriffhales Salop | United Kingdom | British | 48106690001 | |||||
| LAWRENCE, Eric Alexander | Director | 26 Foxhills Covert Whickham NE16 5TN Newcastle Upon Tyne | British | 4250810002 | ||||||
| LONG, Lyn Terasa | Director | 4 Dene Road Headington OX3 7EE Oxford Oxfordshire | British | 72510870001 | ||||||
| MACKENZIE, Ashley Calder | Director | 6 Springshaw Close TN13 2QE Sevenoaks Kent | British | 59529980005 | ||||||
| MACKENZIE, Kelvin Calder | Director | Christophers Lockstone Close KT13 8EF Weybridge Surrey | United Kingdom | British | 141795340001 | |||||
| MADDOX, Peter | Director | Beech House Farm Chesterton Road, Pattingham WV6 7BJ Wolverhampton West Midlands | United Kingdom | British | 8711640004 | |||||
| MATTO, Jit Singh | Director | Earlswood House Stourbridge Road WV4 5NG Penn Wolverhampton West Midlands | United Kingdom | British | 6220030001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de WOLVERHAMPTON AREA RADIO LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forever Broadcasting Ltd | 06 abr 2016 | London Bridge Street SE1 9GF London 1 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene WOLVERHAMPTON AREA RADIO LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 14 oct 2002 Entregado el 23 oct 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 25 sept 2002 Entregado el 02 oct 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts, uncalled capital, buildings, fixtures and fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 21 nov 2001 Entregado el 24 nov 2001 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0