XCHANGING COMPUTER SERVICES LIMITED

XCHANGING COMPUTER SERVICES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaXCHANGING COMPUTER SERVICES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02424356
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de XCHANGING COMPUTER SERVICES LIMITED?

    • Otras actividades de servicios de tecnología de la información (62090) / Información y comunicación
    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra XCHANGING COMPUTER SERVICES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    The Walbrook Building
    25 Walbrook
    EC4N 8AQ London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de XCHANGING COMPUTER SERVICES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    REBUS COMPUTER SERVICES LIMITED 15 ago 199715 ago 1997
    DATASURE LIMITED01 abr 199701 abr 1997
    DATASURE NOMINEES LIMITED31 ene 199631 ene 1996
    MARKETWIDE SYSTEMS LIMITED26 ene 199026 ene 1990
    EMBEX LIMITED19 sept 198919 sept 1989

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de XCHANGING COMPUTER SERVICES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para XCHANGING COMPUTER SERVICES LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para XCHANGING COMPUTER SERVICES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital01 jun 2015

    Estado de capital el 01 jun 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cese del nombramiento de Stephen Eric Dews como director el 26 ene 2015

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 jun 2014

    Estado de capital el 02 jun 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Domicilio social registrado cambiado de * 34 Leadenhall Street London EC3A 1AX* el 07 abr 2014

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Timothy Llewellyn Croom como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    6 páginasAA

    Nombramiento de Stephen Eric Dews como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Andrew Bligh como director

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Nombramiento de Mr Andrew Bligh como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de John Priggen como director

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    7 páginasAA

    Cese del nombramiento de Michael Hobbs como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Anthony Gallagher como secretario

    2 páginasTM02

    Declaración de los objetos de la sociedad

    2 páginasCC04

    ¿Quiénes son los directivos de XCHANGING COMPUTER SERVICES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CROOM, Timothy Llewellyn
    25 Walbrook
    EC4N 8AQ London
    The Walbrook Building
    United Kingdom
    Director
    25 Walbrook
    EC4N 8AQ London
    The Walbrook Building
    United Kingdom
    United KingdomBritish184906470001
    CAMPBELL, Kenneth Francis
    9 Cheldon Barton
    SS1 3TX Thorpe Bay
    Essex
    Secretario
    9 Cheldon Barton
    SS1 3TX Thorpe Bay
    Essex
    British101302400001
    FUSSELL, Christopher Mark
    2 Acris Street
    SW18 2QP London
    Secretario
    2 Acris Street
    SW18 2QP London
    British63476510003
    GALLAGHER, Anthony James
    34 Leadenhall Street
    London
    EC3A 1AX
    Secretario
    34 Leadenhall Street
    London
    EC3A 1AX
    Irish127048740001
    LONEY, Nicholas John
    31 Viewfield Road
    Southfields
    SW18 5JD London
    Secretario
    31 Viewfield Road
    Southfields
    SW18 5JD London
    British8511300001
    SCORE, Timothy
    Chestnut Farmhouse
    Aylesbury Road
    HP27 0JT Monks Risborough
    Buckinghamshire
    Secretario
    Chestnut Farmhouse
    Aylesbury Road
    HP27 0JT Monks Risborough
    Buckinghamshire
    British103319060001
    WILKINSON, Sidney James
    67 Chessfield Park
    Little Chalfont
    HP6 6RU Amersham
    Buckinghamshire
    Secretario
    67 Chessfield Park
    Little Chalfont
    HP6 6RU Amersham
    Buckinghamshire
    British1138390001
    HEXAGON REGISTRARS LIMITED
    Ten Dominion Street
    EC2M 2EE London
    Secretario corporativo
    Ten Dominion Street
    EC2M 2EE London
    4004080002
    BAUERNFEIND, David Gregory
    The Coachouse
    Bathampton Lane
    BA2 6SW Bath
    Director
    The Coachouse
    Bathampton Lane
    BA2 6SW Bath
    United KingdomBritish99529910001
    BLIGH, Andrew William
    34 Leadenhall Street
    London
    EC3A 1AX
    Director
    34 Leadenhall Street
    London
    EC3A 1AX
    United KingdomBritish165498010001
    CAMPBELL, Kenneth Francis
    9 Cheldon Barton
    SS1 3TX Thorpe Bay
    Essex
    Director
    9 Cheldon Barton
    SS1 3TX Thorpe Bay
    Essex
    British101302400001
    CAMPBELL-CARR, Richard Arthur
    9 Cardigan Avenue
    SS0 0SF Westcliff-On-Sea
    Essex
    Director
    9 Cardigan Avenue
    SS0 0SF Westcliff-On-Sea
    Essex
    EnglandBritish32409630001
    CROFT, David Richard
    Brook House 21 Water Lane
    Steeple Bumpstead
    CB9 7DS Haverhill
    Suffolk
    Director
    Brook House 21 Water Lane
    Steeple Bumpstead
    CB9 7DS Haverhill
    Suffolk
    EnglandBritish44741010002
    DEWS, Stephen Eric
    25 Walbrook
    EC4N 8AQ London
    The Walbrook Building
    United Kingdom
    Director
    25 Walbrook
    EC4N 8AQ London
    The Walbrook Building
    United Kingdom
    EnglandBritish172816160001
    DUNSTAN, Michael Ernest
    26 Plymtree
    Thorpe Bay
    SS1 3RA Southend On Sea
    Essex
    Director
    26 Plymtree
    Thorpe Bay
    SS1 3RA Southend On Sea
    Essex
    British28712640001
    GOGEL, Robert Neil, Mr.
    16 Av Emile Deschanel
    FOREIGN Paris
    75007
    France
    Director
    16 Av Emile Deschanel
    FOREIGN Paris
    75007
    France
    FranceUs/French151744580001
    GRAY, Shaun David
    White Cottage
    Lower Chase Road
    SO32 2PB Swanmore
    Hampshire
    Director
    White Cottage
    Lower Chase Road
    SO32 2PB Swanmore
    Hampshire
    EnglandBritish149960650001
    HOBBS, Michael Owen
    34 Leadenhall Street
    London
    EC3A 1AX
    Director
    34 Leadenhall Street
    London
    EC3A 1AX
    EnglandBritish28712650002
    KNIGHT, Owen William
    51a Peartree Lane
    Danbury
    CM3 4LS Chelmsford
    Essex
    Director
    51a Peartree Lane
    Danbury
    CM3 4LS Chelmsford
    Essex
    British28495410001
    PRESLAND, Peter Eric
    Rats Castle
    Castletons Oak Cranbrook Road
    TN27 8DY Biddenden Ashford
    Kent
    Director
    Rats Castle
    Castletons Oak Cranbrook Road
    TN27 8DY Biddenden Ashford
    Kent
    EnglandBritish7649630002
    PRIGGEN, John Edward Frederick
    34 Leadenhall Street
    London
    EC3A 1AX
    Director
    34 Leadenhall Street
    London
    EC3A 1AX
    EnglandBritish128934910003
    SAFFER, Paul Graham
    5 Vulcan Gate
    Uplands Park Road
    EN2 7PP Enfield
    Middlesex
    Director
    5 Vulcan Gate
    Uplands Park Road
    EN2 7PP Enfield
    Middlesex
    British60625080001
    SCORE, Timothy
    Chestnut Farmhouse
    Aylesbury Road
    HP27 0JT Monks Risborough
    Buckinghamshire
    Director
    Chestnut Farmhouse
    Aylesbury Road
    HP27 0JT Monks Risborough
    Buckinghamshire
    British103319060001
    SHARP, Andrew Timothy
    53 Hillbury Road
    CR6 9TH Warlingham
    Surrey
    Director
    53 Hillbury Road
    CR6 9TH Warlingham
    Surrey
    United KingdomBritish330020620001
    SISMEY, Malcolm
    24 Leeward Road
    South Woodham Ferrers
    CM3 5YR Chelmsford
    Essex
    Director
    24 Leeward Road
    South Woodham Ferrers
    CM3 5YR Chelmsford
    Essex
    British55049310001
    SUMMERS, Roger Denis
    Florins
    Birchwood Road Cock Clarks
    CM3 6PR Chelmsford
    Essex
    Director
    Florins
    Birchwood Road Cock Clarks
    CM3 6PR Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritish8559710002
    TOBIN, Janice Annette
    1 Providence Square
    SE1 2EA London
    Director
    1 Providence Square
    SE1 2EA London
    EnglandBritish55049370003

    ¿Tiene XCHANGING COMPUTER SERVICES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A supplemental debenture
    Creado el 09 jul 1999
    Entregado el 28 jul 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee under or pursuant to the finance documents (as defined therein)
    Breve descripción
    All freehold and leasehold property and all assets and undertakings.
    Personas con derecho
    • Chase Manhattan International Limited as Security Agent for and on Behalf of the Financeparties (As Defined in the Supplemental Debenture)
    Transacciones
    • 28 jul 1999Registro de un cargo (395)
    • 10 mar 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 18 mar 1999
    Entregado el 30 mar 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge and the finance documents as defined therein
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Chase Manhattan International Limited(Acting as Security Agent for the Finance Parties Pursuant to the Facilities Agreement)
    Transacciones
    • 30 mar 1999Registro de un cargo (395)
    • 10 mar 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 30 oct 1997
    Entregado el 13 nov 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 13 nov 1997Registro de un cargo (395)
    • 27 abr 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0