QMH (A) DEVELOPMENTS LIMITED

QMH (A) DEVELOPMENTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaQMH (A) DEVELOPMENTS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02426512
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de QMH (A) DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra QMH (A) DEVELOPMENTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Suite 64 Waterhouse Business Park
    2 Cromar Way
    CM1 2QE Chelmsford
    Essex
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de QMH (A) DEVELOPMENTS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    QUEENS MOAT HOUSES (A) DEVELOPMENTS LIMITED04 jul 200504 jul 2005
    ASHFORD DEVELOPMENTS LTD04 dic 198904 dic 1989
    JUGMEAD LIMITED26 sept 198926 sept 1989

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de QMH (A) DEVELOPMENTS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para QMH (A) DEVELOPMENTS LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para QMH (A) DEVELOPMENTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cambio de datos del secretario Sally Ann Coughlan el 02 ene 2016

    1 páginasCH03

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    13 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de 68 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way Chelmsford Essex CM1 2QE a Suite 64 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way Chelmsford Essex CM1 2QE el 07 dic 2015

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 09 jun 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital11 jun 2015

    Estado de capital el 11 jun 2015

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Cambio de datos del secretario Sally Ann Coughlan el 02 oct 2014

    1 páginasCH03

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    17 páginasAA

    Cese del nombramiento de Erwin Joseph Rieck como director el 30 sept 2013

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de Queens Court 9-17 Eastern Road Romford Essex RM1 3NG a 68 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way Chelmsford Essex CM1 2QE el 29 sept 2014

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 09 jun 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 jul 2014

    Estado de capital el 02 jul 2014

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Nombramiento de Martin Quinn como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Matthew Rosenberg como director

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    19 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 09 jun 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cese del nombramiento de W2001 Two Cv como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de W2001 Britannia Llc como director

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    16 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 09 jun 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Erwin Joseph Rieck el 12 sept 2011

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    21 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 09 jun 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Déclaration annuelle établie au 09 jun 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Nombramiento de W2001 Two Cv como director

    2 páginasAP02

    ¿Quiénes son los directivos de QMH (A) DEVELOPMENTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    COUGHLAN, Sally Ann
    Waterhouse Business Park
    2 Cromar Way
    CM1 2QE Chelmsford
    Suite 64
    Essex
    England
    Secretario
    Waterhouse Business Park
    2 Cromar Way
    CM1 2QE Chelmsford
    Suite 64
    Essex
    England
    British107832420001
    QUINN, Martin Joseph
    34 Francis Grove, Wimbledon
    SW19 4DT London
    Westmont Management Limited
    England
    Director
    34 Francis Grove, Wimbledon
    SW19 4DT London
    Westmont Management Limited
    England
    EnglandIrish186571310001
    BURGESS, Keith John
    3 Queen Annes Gate
    White House Walk
    GU9 9AN Farnham
    Surrey
    Secretario
    3 Queen Annes Gate
    White House Walk
    GU9 9AN Farnham
    Surrey
    British7009790002
    CHRISTIAN, Tracy Joanne
    19 Lovell Walk
    RM13 7ND Rainham
    Essex
    Secretario
    19 Lovell Walk
    RM13 7ND Rainham
    Essex
    British102667300001
    JONES, Vanessa
    Stables House
    Castle Hill
    RH1 4LB Bletchingley
    Surrey
    Secretario
    Stables House
    Castle Hill
    RH1 4LB Bletchingley
    Surrey
    British72146200001
    PURVIS, Martin Terence Alan
    Fenetters
    Melfort Road
    TN6 1QT Crowborough
    East Sussex
    Secretario
    Fenetters
    Melfort Road
    TN6 1QT Crowborough
    East Sussex
    British7901050001
    STADEN, Paul Sidney
    Swallows Barn
    New College Court
    MK18 5JP Chackmore
    Buckingham
    Secretario
    Swallows Barn
    New College Court
    MK18 5JP Chackmore
    Buckingham
    British35453800001
    WATERS, Jonathan Roy
    Maldon Road
    CO3 3BQ Colchester
    237
    Essex
    Secretario
    Maldon Road
    CO3 3BQ Colchester
    237
    Essex
    British129848360001
    ALLSOP, Heather Louise
    62 Prebend Street
    N1 8PS London
    Director
    62 Prebend Street
    N1 8PS London
    British101912850001
    ASHFORD, Martin John
    The Elms
    Chessetts Wood Road
    B94 6EL Lapworth
    Solihull
    Director
    The Elms
    Chessetts Wood Road
    B94 6EL Lapworth
    Solihull
    British1450190001
    BEASLEY, Colin John
    The Ridings
    Plumpton Road, Woodend
    NN12 8RZ Towcester
    Northamptonshire
    Director
    The Ridings
    Plumpton Road, Woodend
    NN12 8RZ Towcester
    Northamptonshire
    United KingdomBritish65499270001
    COLES, Alan Clifford
    The Knoll
    Grendon
    NN7 1JG Northampton
    Beeches, 5
    Northamptonshire
    Director
    The Knoll
    Grendon
    NN7 1JG Northampton
    Beeches, 5
    Northamptonshire
    EnglandBritish101144900002
    COLLYER, Brian Charles
    49 Route De Croissy
    78110 Le Vesinet
    France
    Director
    49 Route De Croissy
    78110 Le Vesinet
    France
    Canadian101144260001
    COPPEL, Andrew Maxwell
    Orchard House
    8 Claremont Park Road
    KT10 9LT Esher
    Surrey
    Director
    Orchard House
    8 Claremont Park Road
    KT10 9LT Esher
    Surrey
    EnglandBritish14330100002
    COURT, Gregory James
    46 Buckminster Drive
    Dorridge
    B93 8PG Solihull
    West Midlands
    Director
    46 Buckminster Drive
    Dorridge
    B93 8PG Solihull
    West Midlands
    British17155090002
    CUTTS, John Charles
    Tudor Gables Old Warwick Road
    Lapworth
    B94 6AY Solihull
    West Midlands
    Director
    Tudor Gables Old Warwick Road
    Lapworth
    B94 6AY Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish56651680001
    ELLAMS, Robert
    34 Alderbrook Road
    B91 1NN Solihull
    West Midlands
    Director
    34 Alderbrook Road
    B91 1NN Solihull
    West Midlands
    British80180860001
    FEARNSIDE, James Nicholas
    7 Harris Close
    Henley In Arden
    B95 5DE Solihull
    West Midlands
    Director
    7 Harris Close
    Henley In Arden
    B95 5DE Solihull
    West Midlands
    British54861980001
    GOIN, Russell Todd
    4 Rue Jadin
    75017
    FOREIGN Paris
    France
    Director
    4 Rue Jadin
    75017
    FOREIGN Paris
    France
    American108675490001
    KABALAN, Fadi
    Keyes House
    Dolphin Square
    SW1V 3NA London
    Suite 311
    Director
    Keyes House
    Dolphin Square
    SW1V 3NA London
    Suite 311
    EnglandBritish133846470001
    KEIR, David Christopher Lindsay
    Laird Manoch
    Church Lane
    NN6 9NX Harrington
    Northamptonshire
    Director
    Laird Manoch
    Church Lane
    NN6 9NX Harrington
    Northamptonshire
    British32255280001
    KRAIS, Ashley Simon
    74 Marsh Lane
    NW7 4NT London
    Director
    74 Marsh Lane
    NW7 4NT London
    United KingdomBritish105921220001
    LE POIDEVIN, Andrew Daryl
    Kinneil
    34 Bulstrode Way
    SL9 7QU Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    Kinneil
    34 Bulstrode Way
    SL9 7QU Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish4958800007
    MENARD, Veronique Pascale Dominique
    Goldman Sachs International
    Peterborough Court, 133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Goldman Sachs International
    England
    Director
    Goldman Sachs International
    Peterborough Court, 133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Goldman Sachs International
    England
    United KingdomFrench141156250001
    METCALFE, Michael Stuart
    Harwil 37 Howards Thicket
    SL9 7NT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    Harwil 37 Howards Thicket
    SL9 7NT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish40294180002
    MOORE, Richard John
    2 Maple Wood
    Bedhampton
    PO9 3JB Havant
    Hampshire
    Director
    2 Maple Wood
    Bedhampton
    PO9 3JB Havant
    Hampshire
    EnglandBritish101144680001
    MULAHASANI, Heather Louise
    Goldman Sachs International
    Peterborough Court, 133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Goldman Sachs International
    Director
    Goldman Sachs International
    Peterborough Court, 133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Goldman Sachs International
    EnglandBritish136994090001
    OGDEN, Kathryn
    14 Arundel Court
    43-47 Arundel Gardens
    W11 2LP London
    Director
    14 Arundel Court
    43-47 Arundel Gardens
    W11 2LP London
    American114248790002
    RIECK, Erwin Joseph
    Queens Court
    9-17 Eastern Road
    RM1 3NG Romford
    Queens Court
    Essex
    England
    Director
    Queens Court
    9-17 Eastern Road
    RM1 3NG Romford
    Queens Court
    Essex
    England
    German108675520002
    ROBERTS, Peter Charles William
    White Lodge
    78 Tiddington Road
    CV37 7BA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Director
    White Lodge
    78 Tiddington Road
    CV37 7BA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    United KingdomBritish81817780001
    ROSENBERG, Matthew Alexander
    Queens Court
    9-17 Eastern Road
    RM1 3NG Romford
    Queens Court
    Essex
    England
    Director
    Queens Court
    9-17 Eastern Road
    RM1 3NG Romford
    Queens Court
    Essex
    England
    EnglandBritish134723670001
    SCOBLE, Timothy James
    57 Old Road
    Wheatley
    OX33 1NX Oxford
    Oxfordshire
    Director
    57 Old Road
    Wheatley
    OX33 1NX Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish83743120001
    STADEN, Paul Sidney
    Swallows Barn
    New College Court
    MK18 5JP Chackmore
    Buckingham
    Director
    Swallows Barn
    New College Court
    MK18 5JP Chackmore
    Buckingham
    British35453800001
    W2001 BRITANNIA LLC
    The Corporation Trust Company
    1209 Orange Street
    Wilmington
    The Corporation Trust Company
    County Of Newcastle
    Usa
    Director corporativo
    The Corporation Trust Company
    1209 Orange Street
    Wilmington
    The Corporation Trust Company
    County Of Newcastle
    Usa
    Forma jurídicaLIMITED LIABILITY COMPANY
    Tipo de identificaciónNo EEE
    Autoridad legalDELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY ACT
    152068320001
    W2001 TWO CV
    Strawinskylaan 1207
    1077 Xx Amsterdam
    Strawinskylaan 1207
    Netherlands
    Director corporativo
    Strawinskylaan 1207
    1077 Xx Amsterdam
    Strawinskylaan 1207
    Netherlands
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro34207195
    152068470001

    ¿Tiene QMH (A) DEVELOPMENTS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A composite guarantee and debenture
    Creado el 23 feb 2005
    Entregado el 04 mar 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Goldman Sachs Credit Partners, L.P.
    Transacciones
    • 04 mar 2005Registro de un cargo (395)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 24 nov 2004
    Entregado el 14 dic 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of legal mortgage all estates or interests in the f/h, l/h and other immovable property. By way of fixed charge all estates or interests in any f/h, l/h and other immovable property, all stocks shares debentures bonds notes and loan capital, the goodwill, all copyrights and patents. By way of floating charge the undertaking and all its property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Goldman Sachs Credit Partners, L.P.
    Transacciones
    • 14 dic 2004Registro de un cargo (395)
    • 07 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 18 jun 2004
    Entregado el 25 jun 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Trust Coproration PLC
    Transacciones
    • 25 jun 2004Registro de un cargo (395)
    • 15 feb 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental deed to the composite guarantee and debenture
    Creado el 08 jun 2004
    Entregado el 11 jun 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (As Agent and Security Trustee for the Junior Term Lenders Defined in Theterm Facility Agreement)
    Transacciones
    • 11 jun 2004Registro de un cargo (395)
    • 29 nov 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 25 mar 2004
    Entregado el 26 mar 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (As Agent and Security Trustee for the Junior Term Lenders)
    Transacciones
    • 26 mar 2004Registro de un cargo (395)
    • 29 nov 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge on shares
    Creado el 30 jun 1999
    Entregado el 09 jul 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from glancepress (wokingham) limited or a memeber of the same group to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Seven hundred and fitiyy one sh of £1.00 each in the issued share capiatl of the borrower with all dividends interest and other money for full details please refer to form 395.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transacciones
    • 09 jul 1999Registro de un cargo (395)
    • 30 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed without instrument
    Creado el 03 jun 1992
    Entregado el 13 jun 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £440,000 due from the company and/or wilson bowden properties limited to the chargee
    Breve descripción
    Farmhouse bungalow farm buildings and land containing 6.84 acres or thereabouts forming part of gate farm bardon hill near coalville leicestershire.
    Personas con derecho
    • David Walker
    Transacciones
    • 13 jun 1992Registro de un cargo (395)
    • 19 abr 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 24 ene 1992
    Entregado el 04 feb 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land at rockingham road market harborough leicestershire t/n lt 227168.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 04 feb 1992Registro de un cargo (395)
    • 29 nov 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 24 ene 1992
    Entregado el 04 feb 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land at the embankment wellingborough northhamptonshire t/n nn 147287.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 04 feb 1992Registro de un cargo (395)
    • 29 nov 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 24 ene 1992
    Entregado el 04 feb 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land at embankment wellingborough northamptonshire t/n nn 139614.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 04 feb 1992Registro de un cargo (395)
    • 29 nov 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 24 ene 1992
    Entregado el 04 feb 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The palais bingo hall, wentworth street, peterborough, cambridgeshire. T/n CB77541.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 04 feb 1992Registro de un cargo (395)
    • 29 nov 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 24 ene 1992
    Entregado el 04 feb 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land on the south side of raywell street, kingston-upon-hull, humberside. T/n HS194357.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 04 feb 1992Registro de un cargo (395)
    • 19 abr 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 24 ene 1992
    Entregado el 04 feb 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    5 new walk, and 38-50 (even numbers) king street, leicester, leicestershire. T/n LT151627.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 04 feb 1992Registro de un cargo (395)
    • 29 nov 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 24 ene 1992
    Entregado el 04 feb 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    5 new walk and 38-50 (even numbers) king street, leicester, leicestershire. T/n LT58751.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 04 feb 1992Registro de un cargo (395)
    • 29 nov 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 24 ene 1992
    Entregado el 04 feb 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    5 new walk and 38-50 (even numbers) king street, leicester, leicestershire. T/n LT39919.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 04 feb 1992Registro de un cargo (395)
    • 29 nov 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 24 ene 1992
    Entregado el 04 feb 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land at rockingham road, market harborough, leicestershire. T/n LT233767.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 04 feb 1992Registro de un cargo (395)
    • 29 nov 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 24 ene 1992
    Entregado el 04 feb 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land at barton dock road, trafford park, manchester, greater manchester.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 04 feb 1992Registro de un cargo (395)
    • 19 ago 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 02 jul 1991
    Entregado el 08 jul 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the agreement of even date
    Breve descripción
    F/H plot e, swift park rugby, title no wk 327361 all the companys right title & interest in the balance of the sale proceeds (if any) (see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Electronic Magnetic Services Limited
    Transacciones
    • 08 jul 1991Registro de una carga
    • 19 abr 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 16 nov 1990
    Entregado el 30 nov 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    24.65 acres of land at cosford lane, rugby, warwickshire.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 30 nov 1990Registro de una carga
    • 29 jun 2004Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 29 nov 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0