CARE IN BATHING LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCARE IN BATHING LTD
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02426566
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CARE IN BATHING LTD?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra CARE IN BATHING LTD?

    Dirección de la sede social
    Unit 20-21 Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CARE IN BATHING LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PREMIER BATHROOMS LTD.17 oct 199517 oct 1995
    GULLYMERE LIMITED26 sept 198926 sept 1989

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CARE IN BATHING LTD?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 ago 2022

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CARE IN BATHING LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 07 abr 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Sotos Constantinides como director el 30 oct 2023

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Stephen Michael Murray como director el 18 oct 2023

    1 páginasTM01

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 ago 2022

    3 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 07 abr 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Declaración de confirmación presentada el 07 abr 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 ago 2021

    3 páginasAA

    Nombramiento de Stephen Michael Murray como director el 18 oct 2021

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Jeremy Simon Ling como director el 16 nov 2021

    1 páginasTM01

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 ago 2020

    3 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 07 abr 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ago 2019

    16 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 07 abr 2020 con actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Jeremy Simon Ling como director el 01 dic 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Lawrence Edward Warriner como director el 17 feb 2020

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Kevin Bage como director el 31 ene 2020

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de Premier House Hewell Road Enfield Redditch Worcestershire B97 6BW a Unit 20-21 Padgets Lane Redditch B98 0RA el 29 ago 2019

    1 páginasAD01

    legacy

    6 páginasRP04CS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 ago 2018

    25 páginasAA

    Cessation de Mobility Bathing Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 ago 2018

    3 páginasPSC07

    ¿Quiénes son los directivos de CARE IN BATHING LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CONSTANTINIDES, Sotos
    Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    Unit 20-21
    England
    Director
    Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    Unit 20-21
    England
    United KingdomBritish124622460002
    ELLIS, Lee Richard
    Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    Unit 20-21
    England
    Director
    Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    Unit 20-21
    England
    EnglandBritish199559150001
    FARMILOE, Gordon Trevarthen
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    Secretario
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    British48633500003
    FARMILOE, Gordon Trevarthen
    Perry Mill Farm
    Perry Mill Lane
    B98 6RR Bradley Green Redditch
    Secretario
    Perry Mill Farm
    Perry Mill Lane
    B98 6RR Bradley Green Redditch
    British48633500003
    BAGE, Kevin Bruce
    Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    Unit 20-21
    England
    Director
    Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    Unit 20-21
    England
    EnglandBritish212484210001
    CHAPMAN, Richard Anthony
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    Director
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    EnglandBritish141406650001
    ELLIS, Steven
    Rose Cottage
    Main Street
    WR10 2LX Bishampton
    Worcestershire
    Director
    Rose Cottage
    Main Street
    WR10 2LX Bishampton
    Worcestershire
    British84557420001
    FARMILOE, Gordon Trevarthen
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    Director
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    EnglandBritish150955160001
    FARMILOE, Gordon Trevarthen
    Perry Mill Farm
    Perry Mill Lane
    B98 6RR Bradley Green Redditch
    Director
    Perry Mill Farm
    Perry Mill Lane
    B98 6RR Bradley Green Redditch
    EnglandBritish48633500003
    FARMILOE, Malcolm Patrick
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    Director
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    EnglandBritish5663680011
    FARMILOE, Malcolm Patrick
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    Director
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    United KingdomBritish5663680009
    FARMILOE, Philip Geoffrey
    Manor Cottage
    Abbots Morton
    WR7 4NA Worcester
    Worcestershire
    Director
    Manor Cottage
    Abbots Morton
    WR7 4NA Worcester
    Worcestershire
    United KingdomBritish23681750002
    GARDNER, John William
    9 Caynham Close
    Winyates West
    B98 0JF Redditch
    Director
    9 Caynham Close
    Winyates West
    B98 0JF Redditch
    British53982190004
    HARVEY, Paul Andrew
    1 Manor Road
    B80 7NA Studley
    Warwickshire
    Director
    1 Manor Road
    B80 7NA Studley
    Warwickshire
    EnglandEnglish50633130002
    HOWE, Michael
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    Director
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    EnglandBritish32724080002
    HURFURT, Gareth John
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    Director
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    EnglandBritish112699190001
    JUSTICE, Kevin Thomas
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    Director
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    United KingdomBritish189302640001
    LING, Jeremy Simon
    Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    Unit 20-21
    England
    Director
    Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    Unit 20-21
    England
    EnglandBritish267364260001
    MOSEDALE, Michael John
    44 Luddington Road
    B92 9QH Solihull
    West Midlands
    Director
    44 Luddington Road
    B92 9QH Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish14506050002
    MURRAY, Stephen Michael
    Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    Units 20-21
    England
    Director
    Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    Units 20-21
    England
    EnglandBritish290563950001
    NEWBROOK, David
    5 Wasdale Court
    WR4 9YT Worcester
    Worcestershire
    Director
    5 Wasdale Court
    WR4 9YT Worcester
    Worcestershire
    British28917950001
    PRICE, Richard Duncan
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    Director
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    EnglandBritish111545180001
    VAUGHAN, Andrew Derek
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    Director
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    EnglandBritish174693630001
    WARRINER, Lawrence Edward
    Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    Unit 20-21
    England
    Director
    Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    Unit 20-21
    England
    United KingdomBritish119997720001
    WATSON, Andrew Terence
    12 Battenhall Road
    WR5 2BL Worcester
    Worcestershire
    Director
    12 Battenhall Road
    WR5 2BL Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritish107091420001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CARE IN BATHING LTD?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Hewell Road
    B97 6BW Redditch
    Premier House
    England
    31 ago 2018
    Hewell Road
    B97 6BW Redditch
    Premier House
    England
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro05522263
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    Hewell Road
    B97 6BW Redditch
    Premier House
    England
    06 abr 2016
    Hewell Road
    B97 6BW Redditch
    Premier House
    England
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro10097440
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    Hc1264 Limited
    Hewell Road
    Enfield
    B97 6BW Redditch
    Premier House
    Worcester
    06 abr 2016
    Hewell Road
    Enfield
    B97 6BW Redditch
    Premier House
    Worcester
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalThe Law Of England And Wales
    Lugar de registroRegistrar Of Companies
    Número de registro10097440
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene CARE IN BATHING LTD alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 21 feb 2018
    Entregado el 05 mar 2018
    Pendiente
    Breve descripción
    N/A.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Lonsdale Capital Partners LLP
    Transacciones
    • 05 mar 2018Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 21 feb 2018
    Entregado el 22 feb 2018
    Pendiente
    Breve descripción
    The freehold property known as unit 1, enfield industrial estate, hewell road, redditch, B97 6BG and registered at the land registry with title number HW110381.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • U.S. Bank Trustees Limited (As Security Agent)
    Transacciones
    • 22 feb 2018Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 04 oct 2016
    Entregado el 06 oct 2016
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    All that freehold property known as premier house, unit 1 enfield industrial estate, hewell road, redditch, worcestershire B97 6BG registered at the land registry under title number HW110381.
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 06 oct 2016Registro de una carga (MR01)
    • 26 feb 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 20 jul 2016
    Entregado el 20 jul 2016
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    A fixed and floating charge over all assets.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 20 jul 2016Registro de una carga (MR01)
    • 26 feb 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 26 may 2016
    Entregado el 31 may 2016
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Unit 1, enfield industrial estate, hewell road, redditch, B97 6BG. Title number HW110381.
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Catalyst Business Finance LTD
    Transacciones
    • 31 may 2016Registro de una carga (MR01)
    • 10 oct 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 15 abr 2016
    Entregado el 26 abr 2016
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Catalyst Business Finance LTD
    Transacciones
    • 26 abr 2016Registro de una carga (MR01)
    • 10 oct 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 11 mar 2015
    Entregado el 13 mar 2015
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Unit 1 enfield industrial estate hewell road redditch t/n HW110381.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • The Bank of New York Mellon London Branch as Security Trustee (As Security Trustee for Each of the Secured Parties)
    Transacciones
    • 13 mar 2015Registro de una carga (MR01)
    • 20 abr 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage
    Creado el 27 oct 2011
    Entregado el 02 nov 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    L/H properties at unit 16 vigo place hayward industrial estate aldridge t/n WM884026, gainsborough house brickyard road aldridge and unit 16 vigo place hayward industrial estate aldridge west midlands and any buildings, fixtures, fittings, fixed plant or machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Trustee
    Transacciones
    • 02 nov 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 09 abr 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Omnibus letter of set-off
    Creado el 24 oct 2011
    Entregado el 28 oct 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 28 oct 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 09 abr 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage
    Creado el 01 abr 2011
    Entregado el 18 abr 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/H property at unit 1 enfield industrial estate, hewell road, redditch t/no HW110381 and any buildings, fixtures, fittings, fixed plant and machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Trustee
    Transacciones
    • 18 abr 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 09 abr 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 01 abr 2011
    Entregado el 18 abr 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether for its own account or as trustee for the secured parties or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Trustee
    Transacciones
    • 18 abr 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 09 abr 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creado el 20 mar 2007
    Entregado el 04 abr 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Philip Farmiloe
    Transacciones
    • 04 abr 2007Registro de un cargo (395)
    • 09 abr 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 20 mar 2007
    Entregado el 04 abr 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 04 abr 2007Registro de un cargo (395)
    • 09 abr 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 08 mar 2006
    Entregado el 22 mar 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The f/h property k/a unit 1, enfield industrial estate, hewell road, redditch t/no HW110381. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 22 mar 2006Registro de un cargo (395)
    • 29 oct 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 08 mar 2006
    Entregado el 22 mar 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 22 mar 2006Registro de un cargo (395)
    • 29 oct 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 30 sept 1999
    Entregado el 13 oct 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Unit 1, enfield industrial estate hewell road redditch worcestershire t/n HW110381.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 13 oct 1999Registro de un cargo (395)
    • 16 mar 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 24 nov 1998
    Entregado el 22 abr 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £250,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    The f/h property k/a unit 1 enfield industrial estate hewell road redditch t/n HW110381.
    Personas con derecho
    • Philip Geoffrey Farmiloe
    Transacciones
    • 22 abr 1999Registro de un cargo (395)
    • 16 mar 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 24 nov 1998
    Entregado el 22 abr 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £250,000 and all other monies due or to become due from the company under the debenture
    Breve descripción
    The f/h property k/a unit 1 enfield industrial estate hewell road redditch t/n HW110381. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Philip Geoffrey Farmiloe
    Transacciones
    • 22 abr 1999Registro de un cargo (395)
    • 16 mar 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 15 mar 1995
    Entregado el 29 mar 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £30,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Philip Geoffrey Farmiloe
    Transacciones
    • 29 mar 1995Registro de un cargo (395)
    • 16 mar 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 29 nov 1993
    Entregado el 16 dic 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £10,000 due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Floating charge on the undertaking property and uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Philip Geoffrey Farmiloe
    Transacciones
    • 16 dic 1993Registro de un cargo (395)
    • 16 mar 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 28 may 1993
    Entregado el 09 jun 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 09 jun 1993Registro de un cargo (395)
    • 16 mar 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0