PINDAR PLC

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPINDAR PLC
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad anónima cotizada
    Número de empresa 02428709
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PINDAR PLC?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra PINDAR PLC?

    Dirección de la sede social
    C/O Kpmg Llp 1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PINDAR PLC?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PINDAR GRAPHICS PLC17 nov 198917 nov 1989
    METROTAB PUBLIC LIMITED COMPANY 03 oct 198903 oct 1989

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PINDAR PLC?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PINDAR PLC?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Informe de progreso del administrador hasta 11 ene 2013

    31 páginas2.24B

    Aviso de cambio de la administración a la disolución el 15 ene 2013

    31 páginas2.35B

    Informe de progreso del administrador hasta 13 nov 2012

    33 páginas2.24B

    Informe de progreso del administrador hasta 13 may 2012

    33 páginas2.24B

    Aviso de extensión del período de la administración

    1 páginas2.31B

    Déclaration annuelle établie au 12 mar 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital16 abr 2012

    Estado de capital el 16 abr 2012

    • Capital: GBP 2,000,000
    SH01

    Informe de progreso del administrador hasta 25 ene 2012

    44 páginas2.24B

    Notificación de la aprobación presunta de las propuestas

    1 páginasF2.18

    Declaración de la propuesta del administrador

    75 páginas2.17B

    Declaración de asuntos con el formulario 2.14B

    36 páginas2.16B

    Cese del nombramiento de Jenna Holliday como secretario

    1 páginasTM02

    Domicilio social registrado cambiado de Thornburgh Road Eastfield Scarborough North Yorkshire YO11 3UY el 03 ago 2011

    1 páginasAD01

    Nombramiento de un administrador

    1 páginas2.12B

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    31 páginasMG01

    legacy

    31 páginasMG01

    Cese del nombramiento de Andrew Holmes como director

    1 páginasTM01

    legacy

    5 páginasMG01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 30 sept 2010

    27 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 12 mar 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2009

    26 páginasAA

    Nombramiento de Mr Andrew Charles David Holmes como director

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de PINDAR PLC?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PINDAR, George Thomas Ventress
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    C/O Kpmg Llp
    Director
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    C/O Kpmg Llp
    United KingdomBritish1020460001
    PINDAR, George Andrew
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    C/O Kpmg Llp
    Director
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    C/O Kpmg Llp
    EnglandBritish1120570003
    HOLLIDAY, Jenna Louise
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    C/O Kpmg Llp
    Secretario
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    C/O Kpmg Llp
    British136386570001
    NOAKES, David Anthony
    21 Town Street
    Old Malton
    YO17 7HB Malton
    North Yorkshire
    Secretario
    21 Town Street
    Old Malton
    YO17 7HB Malton
    North Yorkshire
    British54380850004
    WHITTAKER, Paul Meredith Allen
    Martin Garth
    86 Hutton Buscel
    YO13 9LN Scarborough
    North Yorkshire
    Secretario
    Martin Garth
    86 Hutton Buscel
    YO13 9LN Scarborough
    North Yorkshire
    British29811100001
    WOOLLEY, Heather Caroline
    25 Mayville Avenue
    YO12 7NW Scarborough
    North Yorkshire
    Secretario
    25 Mayville Avenue
    YO12 7NW Scarborough
    North Yorkshire
    British38563500003
    BROUGHAM, Martyn
    2 Sawyers Walk
    Dunnington
    YO19 5SJ York
    North Yorkshire
    Director
    2 Sawyers Walk
    Dunnington
    YO19 5SJ York
    North Yorkshire
    British60080800002
    COWLEY, Christian Anthony
    59 Station Road
    Scholes
    LS15 4BY Leeds
    West Yorkshire
    Director
    59 Station Road
    Scholes
    LS15 4BY Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish27271120001
    DALTON, Andrew Leslie
    Kirby House Farm
    Kirby Knowle
    YO7 2JF Thirsk
    North Yorkshire
    Director
    Kirby House Farm
    Kirby Knowle
    YO7 2JF Thirsk
    North Yorkshire
    EnglandBritish116104960001
    DUGGLEBY, Paul Neil
    Lowgill
    LA2 8PS Lancaster
    Mill Bridge Barn
    United Kingdom
    Director
    Lowgill
    LA2 8PS Lancaster
    Mill Bridge Barn
    United Kingdom
    United KingdomBritish42924780005
    GRAY, Richard David
    1 West Parade
    NR2 3DN Norwich
    Norfolk
    Director
    1 West Parade
    NR2 3DN Norwich
    Norfolk
    EnglandBritish56284200002
    HOLMES, Andrew Charles David
    Thornburgh Road
    Eastfield
    YO11 3UY Scarborough
    North Yorkshire
    Director
    Thornburgh Road
    Eastfield
    YO11 3UY Scarborough
    North Yorkshire
    United KingdomBritish64104370003
    LONGBOTHAM, David George
    34 Water Lane
    Dunnington
    YO1 5NS York
    N Yorkshire
    Director
    34 Water Lane
    Dunnington
    YO1 5NS York
    N Yorkshire
    British24899320001
    LUMBY, Richard Stephen
    30 North Street
    Scalby
    YO13 0RP Scarborough
    North Yorkshire
    Director
    30 North Street
    Scalby
    YO13 0RP Scarborough
    North Yorkshire
    British5653290001
    MCFIE SNEDDON, Mark
    11 Oriel Close
    Walkington
    HU17 8YD Beverley
    North Humberside
    Director
    11 Oriel Close
    Walkington
    HU17 8YD Beverley
    North Humberside
    British71831240001
    NIVEN, Fraser Irvine
    30 Bonaly Avenue
    EH13 0ET Edinburgh
    Midlothian
    Director
    30 Bonaly Avenue
    EH13 0ET Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish1245890002
    O'SULLIVAN, Paul Joseph
    Robin Hill
    Ravenscar
    Y013 ONA Scarborough
    North Yorkshire
    Director
    Robin Hill
    Ravenscar
    Y013 ONA Scarborough
    North Yorkshire
    British39741380001
    PALFREY, David Gwyn
    Bay Horse Cottage
    19 Main Street Ebberston
    YO13 9NR Scarborough
    North Yorkshire
    Director
    Bay Horse Cottage
    19 Main Street Ebberston
    YO13 9NR Scarborough
    North Yorkshire
    British1209930001
    PINDAR, George Andrew
    Southend House
    Burniston
    YO13 0HP Scarborough
    North Yorkshire
    Director
    Southend House
    Burniston
    YO13 0HP Scarborough
    North Yorkshire
    British1120570001
    STREET, Nigel
    19 New Walk Terrace
    YO10 4BG York
    North Yorkshire
    Director
    19 New Walk Terrace
    YO10 4BG York
    North Yorkshire
    British60080730002
    WHITE, John
    St Johns Cottage
    8 East Avenue Scalby
    YO13 0QE Scarborough
    North Yorkshire
    Director
    St Johns Cottage
    8 East Avenue Scalby
    YO13 0QE Scarborough
    North Yorkshire
    British5503640001
    WILKINSON, Peter James
    Bridgewater House 16 Station Road
    Scalby
    YO13 0PU Scarborough
    Director
    Bridgewater House 16 Station Road
    Scalby
    YO13 0PU Scarborough
    EnglandBritish70519070001

    ¿Tiene PINDAR PLC alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Chattels mortgage
    Creado el 19 may 2011
    Entregado el 27 may 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    With full title guarantee assigns the items of equipment and/or other chattels described or referred to in the schedule being 4 sets of 5 bays adjustable botless steel pallet racking, vacuumatic counter and mettler toledo electronic scale and remote platform (for details of all other equipment charged, please refer to the MG01 document).
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 27 may 2011Registro de un cargo (MG01)
    Chattel mortgage
    Creado el 19 may 2011
    Entregado el 27 may 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of a specific first charge all right, title and interest in and to the equipment being 4 sets of 5 bays adjustable boltless steel pallet racking, vacuumatic counter and mettler toledo electronic scale and remote platform (for details of all other equipment charged, please refer to the MG01 document).
    Personas con derecho
    • Hsbc Equipment Finance (UK) Limited and Hsbc Asset Finance (UK) Limited
    Transacciones
    • 27 may 2011Registro de un cargo (MG01)
    Legal assignment
    Creado el 06 may 2011
    Entregado el 07 may 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and any discounting allowance due under the contract the benefit of all the other provisions of the contract and all securities in respect of that credit balance.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 07 may 2011Registro de un cargo (MG01)
    Chattel mortgage
    Creado el 16 jun 2004
    Entregado el 21 jun 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Heidelberg - five colour printing press / s/no: 537137; heidelberg - five colour printing press / s/no: 540261; heidelberg - five colour printing press / s/no: 537749; muller - saddle stitching machine / s/no: 91.06593/42.
    Personas con derecho
    • Lombard North Central PLC
    Transacciones
    • 21 jun 2004Registro de un cargo (395)
    • 11 abr 2005Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 29 jun 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Floating charge
    Creado el 05 dic 2003
    Entregado el 06 dic 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All the undertaking, all assets now owned or hereafter acquired including the stock in trdae and its uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD (the Security Holder)
    Transacciones
    • 06 dic 2003Registro de un cargo (395)
    Chattels mortgage
    Creado el 28 dic 2000
    Entregado el 28 dic 2000
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule hereto or any part thereof muller martini tempo saddle stitcher equipped with four type 416 feeders streatmfeeders 3738, card folder 344, rapido stacker into FW67/FJK41 filmwrapping line and cohiba palletiser s/n SAP368060.
    Personas con derecho
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited and Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transacciones
    • 28 dic 2000Registro de un cargo (395)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Creado el 14 feb 2000
    Entregado el 17 feb 2000
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under an agreement for the purchase of debts
    Breve descripción
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to the agreement (including the associated rights as defined in the agreement) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Personas con derecho
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD
    Transacciones
    • 17 feb 2000Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 11 feb 2000
    Entregado el 15 feb 2000
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 15 feb 2000Registro de un cargo (395)
    Mortgage
    Creado el 09 jun 1999
    Entregado el 15 jun 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £5,217,250 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    One new man roland and web offset printing press type lithoman iv serial no 27666 with all accessories and component parts and all improvements and renewals with all books manuals and handbooks technical data drawings schedules and other documentation.
    Personas con derecho
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transacciones
    • 15 jun 1999Registro de un cargo (395)
    • 24 ene 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creado el 13 ene 1995
    Entregado el 13 ene 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    One new heidelberg 102 speedmaster five colour offset press model 102F + l cp tronic controlled 72 x 102CM with coating system, complete with CPC1-03 alcolor dampening and CPC4 plate registration device, serial no: 537137 together with ancillary equipment. One new CPC3-s plate image reader serial no: 0057 together with ancillary equipment.
    Personas con derecho
    • Forward Trust Limited
    Transacciones
    • 13 ene 1995Registro de un cargo (395)
    • 29 jun 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Chattels mortgage
    Creado el 04 ene 1995
    Entregado el 04 ene 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule. One new heidelberg harris web offset press model M600, serial no:mc Y0057 no. 51, together with ancillary equipment, serial nos:0044 da, 0218 ma, 28 0006010, 180193, 197.01.0080& 550051 6/94. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Forward Trust Limited
    Transacciones
    • 04 ene 1995Registro de un cargo (395)
    • 29 jun 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creado el 09 jul 1991
    Entregado el 10 jul 1991
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 10 jul 1991Registro de una carga

    ¿Tiene PINDAR PLC algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    26 jul 2011Inicio de la administración
    15 ene 2013Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Mark Granville Firmin
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Profesional
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Profesional
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Profesional
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0