TRIMITE INTERNATIONAL COATINGS TECHNOLOGIES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | TRIMITE INTERNATIONAL COATINGS TECHNOLOGIES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02429401 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de TRIMITE INTERNATIONAL COATINGS TECHNOLOGIES LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra TRIMITE INTERNATIONAL COATINGS TECHNOLOGIES LIMITED?
| Dirección de la sede social | Unit 3, Silverdale Industrial Estate Silverdale Road UB3 3BL Hayes Middlesex England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TRIMITE INTERNATIONAL COATINGS TECHNOLOGIES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| TRIMITE (OVERSEAS) LIMITED | 07 nov 1989 | 07 nov 1989 |
| AFTERTAPE LIMITED | 05 oct 1989 | 05 oct 1989 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de TRIMITE INTERNATIONAL COATINGS TECHNOLOGIES LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para TRIMITE INTERNATIONAL COATINGS TECHNOLOGIES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2019 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2018 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Roy Pickvance como director el 19 jun 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Roy Pickvance como secretario el 19 jun 2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Philip John Westwood como director el 01 dic 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Notification de Trimte Bid Co Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 mar 2018 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Maurice Perera en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 mar 2018 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cessation de Adrian Olivero en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 mar 2018 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cessation de Subash Malkani en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 mar 2018 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cessation de James David Hassan en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 mar 2018 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cessation de David Denis Cuby en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 mar 2018 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cessation de William Cid De La Paz en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 mar 2018 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 6 páginas | MA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2017 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jonathan Paul Irwin como director el 30 sept 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2017 con actualizaciones | 10 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 mar 2016 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 mar 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de TRIMITE INTERNATIONAL COATINGS TECHNOLOGIES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTS, David Gareth | Director | Silverdale Road UB3 3BL Hayes Unit 3, Silverdale Industrial Estate Middlesex England | England | British | 173554710003 | |||||
| WESTWOOD, Philip John | Director | Silverdale Road UB3 3BL Hayes Unit 3, Silverdale Industrial Estate Middlesex England | England | British | 164395390001 | |||||
| BRENT, Lucy Elizabeth | Secretario | Templewood House Templewood Lane SL2 4AP Stoke Poges Berkshire | British | 5682530014 | ||||||
| PICKVANCE, Roy | Secretario | 5 Chesterton Drive CV37 7LG Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 114914470001 | ||||||
| BRENT, Lucy Elizabeth | Director | Templewood House Templewood Lane SL2 4AP Stoke Poges Berkshire | British | 5682530014 | ||||||
| BRENT, Michael Hamilton | Director | Templemead, Templewood Lane SL2 4AP Stoke Poges Bucks | British | 5682540002 | ||||||
| EDWARDS, Edwin Rowland | Director | Highlands SL0 0DZ Iver Heath Buckinghamshire | United Kingdom | British | 794220001 | |||||
| FRANCKEL, Mark Bernard, Mr. | Director | Road UB8 2SD Uxbridge Arundel Middx | United Kingdom | British | 137556900002 | |||||
| IRWIN, Jonathan Paul | Director | Silverdale Road UB3 3RL Hayes Unit 3, Silverdale Industrial Estate Middlesex England | England | British | 101583110002 | |||||
| PICKVANCE, Roy | Director | 5 Chesterton Drive CV37 7LG Stratford Upon Avon Warwickshire | United Kingdom | British | 114914470001 | |||||
| PLAIL, David William | Director | PO BOX 1443 Est Court 3310 Natal South Africa | British | 124410002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de TRIMITE INTERNATIONAL COATINGS TECHNOLOGIES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimte Bid Co Limited | 02 mar 2018 | Silverdale Road UB3 3BL Hayes Unit 3 Silverdale Industrial Estate England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr James David Hassan | 06 abr 2016 | 7b & 8b 50 Town Range Suites Gibraltar | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: Gibraltar | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Subash Malkani | 06 abr 2016 | 7b & 8b 50 Town Range Suites Gibraltar | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: Gibraltar | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Adrian Olivero | 06 abr 2016 | 7b & 8b 50 Town Range Suites Gibraltar | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: Gibraltar | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr David Denis Cuby | 06 abr 2016 | 7b & 8b 50 Town Range Suites Gibraltar | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: Gibraltar | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Maurice Perera | 06 abr 2016 | 7b & 8b 50 Town Range Suites Gibraltar | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: Gibraltar | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr William Cid De La Paz | 06 abr 2016 | 7b & 8b 50 Town Range Suites Gibraltar | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: Gibraltar | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene TRIMITE INTERNATIONAL COATINGS TECHNOLOGIES LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee and debenture | Creado el 09 mar 2011 Entregado el 18 mar 2011 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0