OFQUEST LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaOFQUEST LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02429501
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de OFQUEST LIMITED?

    • (3614) /

    ¿Dónde se encuentra OFQUEST LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Begbies Traynor 9th Floor
    Bond Court
    LS1 2JZ Leeds
    West Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de OFQUEST LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    DESKING SYSTEMS LIMITED17 oct 199117 oct 1991
    WELLPAY LIMITED05 oct 198905 oct 1989

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de OFQUEST LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 oct 2007

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para OFQUEST LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para OFQUEST LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    16 páginas4.72

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 28 jun 2014

    21 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 28 jun 2014

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 28 dic 2013

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 28 jun 2013

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 28 dic 2012

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 28 jun 2012

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 28 dic 2011

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 19 jul 2013

    18 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 28 jun 2012

    17 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 28 jun 2011

    5 páginas4.68

    Informe de progreso del administrador hasta 18 jun 2010

    16 páginas2.24B

    Aviso de cambio de la administración a la liquidación voluntaria de acreedores

    16 páginas2.34B

    Informe de progreso del administrador hasta 11 ene 2010

    14 páginas2.24B

    Aviso de extensión del período de la administración

    1 páginas2.31B

    Informe de progreso del administrador hasta 11 jul 2009

    11 páginas2.24B

    Declaración de asuntos con el formulario 2.14B

    12 páginas2.16B

    Resultado de la reunión de acreedores

    33 páginas2.23B

    Declaración de la propuesta del administrador

    32 páginas2.17B

    legacy

    2 páginas288b

    Nombramiento de un administrador

    1 páginas2.12B

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas288a

    ¿Quiénes son los directivos de OFQUEST LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BRAYSHAW, Neil Andrew
    3 Finchley Lane
    OX6 8AE Bicester
    Oxfordshire
    Director
    3 Finchley Lane
    OX6 8AE Bicester
    Oxfordshire
    EnglandBritish59805060001
    OFQUEST DIRECTOR LIMITED
    Irton House
    Warpsgrove Lane, Chalgrove
    OX44 7TH Oxford
    Director corporativo
    Irton House
    Warpsgrove Lane, Chalgrove
    OX44 7TH Oxford
    101569120002
    BARKER, James Edward
    The Old Vicarage
    Cragg Vale
    HX7 5TB Hebden Bridge
    West Yorkshire
    Secretario
    The Old Vicarage
    Cragg Vale
    HX7 5TB Hebden Bridge
    West Yorkshire
    British42890001
    BENNETT, Phillip James
    Grove House Daw Lane
    Horbury
    WF4 5DR Wakefield
    West Yorkshire
    Secretario
    Grove House Daw Lane
    Horbury
    WF4 5DR Wakefield
    West Yorkshire
    British113393520001
    KING, Lorna
    Slade Road
    Stokenchurch
    HP14 3QH High Wycombe
    34
    Buckinghamshire
    Secretario
    Slade Road
    Stokenchurch
    HP14 3QH High Wycombe
    34
    Buckinghamshire
    British130153660001
    GWB SECRETARY LIMITED
    Crossley House
    Hopwood Lane
    HX1 5EB Halifax
    West Yorkshire
    Secretario corporativo
    Crossley House
    Hopwood Lane
    HX1 5EB Halifax
    West Yorkshire
    83825250001
    OFQUEST SECRETARY LIMITED
    Irton House
    Warpsgrove Lane, Chalgrove
    OX44 7TH Oxford
    Secretario corporativo
    Irton House
    Warpsgrove Lane, Chalgrove
    OX44 7TH Oxford
    86085190002
    ALLEN, Christopher Taylor
    65 Seven Acres
    OX9 3JQ Thame
    Oxfordshire
    Director
    65 Seven Acres
    OX9 3JQ Thame
    Oxfordshire
    British45256100001
    ATKIN, John Dudley
    Manor Farm
    Marston St Lawrence
    OX17 2DA Banbury
    Oxfordshire
    Director
    Manor Farm
    Marston St Lawrence
    OX17 2DA Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritish47046270004
    BARKER, James Edward
    The Old Vicarage
    Cragg Vale
    HX7 5TB Hebden Bridge
    West Yorkshire
    Director
    The Old Vicarage
    Cragg Vale
    HX7 5TB Hebden Bridge
    West Yorkshire
    United KingdomBritish42890001
    BENNETT, Phillip James
    Grove House Daw Lane
    Horbury
    WF4 5DR Wakefield
    West Yorkshire
    Director
    Grove House Daw Lane
    Horbury
    WF4 5DR Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish113393520001
    DUFFY, Francis Patrick
    33 Tithebarn Road
    L34 0EU Knowsley Village
    Merseyside
    Director
    33 Tithebarn Road
    L34 0EU Knowsley Village
    Merseyside
    EnglandBritish151944930001
    GARTLAND, Anthony
    Broad Carr House
    Broad Carr Lane
    HX4 9BS Holywell Green
    Halifax
    Director
    Broad Carr House
    Broad Carr Lane
    HX4 9BS Holywell Green
    Halifax
    United KingdomBritish27652170001
    HADLEY, David John
    76 Old High Street The Slade
    Headington
    OX3 7HW Oxford
    Director
    76 Old High Street The Slade
    Headington
    OX3 7HW Oxford
    British55574880002
    HEATHER, Brian Hersee
    9 Gledhow Park Crescent
    Chapel Allerton
    LS7 4JY Leeds
    West Yorkshire
    Director
    9 Gledhow Park Crescent
    Chapel Allerton
    LS7 4JY Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish40164810001
    HEATHER, Brian Hersee
    9 Gledhow Park Crescent
    Chapel Allerton
    LS7 4JY Leeds
    West Yorkshire
    Director
    9 Gledhow Park Crescent
    Chapel Allerton
    LS7 4JY Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish40164810001
    HOYLE, Richard John
    Millstones Milner Lane
    Greetland
    HX4 8HP Halifax
    West Yorkshire
    Director
    Millstones Milner Lane
    Greetland
    HX4 8HP Halifax
    West Yorkshire
    EnglandBritish43591930001
    IRWIN, John David
    Seeleys Orchard 39 Penn Road
    HP9 2LN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    Seeleys Orchard 39 Penn Road
    HP9 2LN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish59361420001
    LAWSON, Ian Bruce
    15 Moorlands
    Westwood Drive
    LS29 9QZ Ilkley
    Yorkshire
    Director
    15 Moorlands
    Westwood Drive
    LS29 9QZ Ilkley
    Yorkshire
    EnglandBritish79170680001
    MCDOUGALL, Andrew
    The Old School
    School Lane
    NG13 9ES Whatton In The Vale
    Nottinghamshire
    Director
    The Old School
    School Lane
    NG13 9ES Whatton In The Vale
    Nottinghamshire
    EnglandBritish154053860001
    MILLS, Lawrence Anthony
    15 Mayfield Drive
    Brayton
    YO8 9JZ Selby
    North Yorkshire
    Director
    15 Mayfield Drive
    Brayton
    YO8 9JZ Selby
    North Yorkshire
    United KingdomBritish165378540001
    PENTLAND, Ian William
    Steadwell House
    Church End
    MK18 5NU Leckhampstead
    Buckinghamshire
    Director
    Steadwell House
    Church End
    MK18 5NU Leckhampstead
    Buckinghamshire
    British33480180001
    ROE, David
    12 St George's Street
    PE9 2BJ Stamford
    Lincolnshire
    Director
    12 St George's Street
    PE9 2BJ Stamford
    Lincolnshire
    United KingdomBritish80567360002
    STANTON, Michael John
    16 Duxford Close
    B97 5BY Redditch
    Worcestershire
    Director
    16 Duxford Close
    B97 5BY Redditch
    Worcestershire
    United KingdomBritish114566620001
    WARD, Alan John
    6 Donegal Close
    Caversham
    RG4 5DT Reading
    Berkshire
    Director
    6 Donegal Close
    Caversham
    RG4 5DT Reading
    Berkshire
    EnglandBritish70124690001
    WHALLEY, Jeffrey
    Broncroft Castle
    Broncroft
    SY7 9HL Craven Arms
    Shropshire
    Director
    Broncroft Castle
    Broncroft
    SY7 9HL Craven Arms
    Shropshire
    United KingdomBritish1955430002
    WOODALL, Michael David
    Glovers Cottage Reigate Hill
    RH2 9PN Reigate
    Surrey
    Director
    Glovers Cottage Reigate Hill
    RH2 9PN Reigate
    Surrey
    British4777030001
    ZAVOS, Theodore
    Under Hill House Hundon Road
    Barnardiston
    CB9 7TJ Haverhill
    Suffolk
    Director
    Under Hill House Hundon Road
    Barnardiston
    CB9 7TJ Haverhill
    Suffolk
    EnglandBritish50583170001

    ¿Tiene OFQUEST LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 30 abr 2008
    Entregado el 14 may 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    All property and assets.
    Personas con derecho
    • Gartland Whalley & Barker Limited
    Transacciones
    • 14 may 2008Registro de un cargo (395)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 06 mar 2007
    Entregado el 09 mar 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    All property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Gartland Whalley and Barker PLC
    Transacciones
    • 09 mar 2007Registro de un cargo (395)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 05 ago 2005
    Entregado el 24 ago 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    All property and assets.
    Personas con derecho
    • Gartland Whalley and Barker PLC
    Transacciones
    • 24 ago 2005Registro de un cargo (395)
    Equitable mortgage of shares
    Creado el 04 dic 2000
    Entregado el 14 dic 2000
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in connection with the corporate guarantee
    Breve descripción
    Shares in any relevant company and all dividends interest etc. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland(The "Security Trustee")
    Transacciones
    • 14 dic 2000Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 04 dic 2000
    Entregado el 09 dic 2000
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transacciones
    • 09 dic 2000Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 12 may 2000
    Entregado el 18 may 2000
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 18 may 2000Registro de un cargo (395)
    Chattel mortgage
    Creado el 07 abr 2000
    Entregado el 08 abr 2000
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    1 x new stefani edgebander s/no.AH1003262.
    Personas con derecho
    • Lombard North Central PLC
    Transacciones
    • 08 abr 2000Registro de un cargo (395)
    Guarantee & debenture
    Creado el 12 jun 1998
    Entregado el 16 jun 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies and liabilities due or to become due from the company and/or systems furniture limited and/or cooper & palmer limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 16 jun 1998Registro de un cargo (395)
    • 02 jun 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Single debenture
    Creado el 20 oct 1994
    Entregado el 08 nov 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 08 nov 1994Registro de un cargo (395)
    • 19 jun 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 02 oct 1992
    Entregado el 14 oct 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Premises off eastview terrace, north street, langley mill, derbyshire t/no. DY228442.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 14 oct 1992Registro de un cargo (395)
    • 20 may 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 02 oct 1992
    Entregado el 13 oct 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    See form 395 ref. M367C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 13 oct 1992Registro de un cargo (395)
    • 20 feb 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 09 oct 1991
    Entregado el 18 oct 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Crossley House Holdings Limited
    Transacciones
    • 18 oct 1991Registro de una carga
    • 20 may 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene OFQUEST LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    12 ene 2009Inicio de la administración
    29 jun 2010Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Rob Sadler
    Begbies Traynor
    9th Floor
    LS1 2JZ Bond Court
    Leeds
    Profesional
    Begbies Traynor
    9th Floor
    LS1 2JZ Bond Court
    Leeds
    Robert Alexander Henry Maxwell
    Begbies Traynor
    9th Floor
    Bond Court
    Leeds Ls1 2jz
    Profesional
    Begbies Traynor
    9th Floor
    Bond Court
    Leeds Ls1 2jz
    2
    FechaTipo
    29 jun 2010Inicio de la liquidación
    09 mar 2015Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Rob Sadler
    Begbies Traynor
    9th Floor
    LS1 2JZ Bond Court
    Leeds
    Profesional
    Begbies Traynor
    9th Floor
    LS1 2JZ Bond Court
    Leeds
    Robert Alexander Henry Maxwell
    9th Floor Bond Court
    LS1 2JZ Leeds
    Profesional
    9th Floor Bond Court
    LS1 2JZ Leeds

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0