TOWERITE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTOWERITE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02433029
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TOWERITE LIMITED?

    • Recolección, tratamiento y suministro de agua (36000) / Captación, depuración y distribución de agua; gestión de residuos; actividades de descontaminación y recuperación

    ¿Dónde se encuentra TOWERITE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    6 Stirling Park
    Laker Road
    ME1 3QR Rochester
    Kent
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TOWERITE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 ago 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TOWERITE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 31 oct 2016 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de 47 Riverside Medway City Estate Rochester Kent ME2 4DP a 6 Stirling Park Laker Road Rochester Kent ME1 3QR el 15 jun 2016

    1 páginasAD01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 ago 2015

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 oct 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital16 nov 2015

    Estado de capital el 16 nov 2015

    • Capital: GBP 6
    SH01

    Exercice comptable en cours prolongé du 31 mar 2015 au 31 ago 2015

    1 páginasAA01

    Nombramiento de Mr Hugh Francis Edmonds como secretario el 14 may 2015

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de John William Charles Charlton como director el 30 abr 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de John William Charles Charlton como secretario el 30 abr 2015

    1 páginasTM02

    Domicilio social registrado cambiado de Unit 2 Derwent Close Warndon Worcester WR4 9TY a 47 Riverside Medway City Estate Rochester Kent ME2 4DP el 01 abr 2015

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 31 oct 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital31 ene 2015

    Estado de capital el 31 ene 2015

    • Capital: GBP 6
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2014

    12 páginasAA

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2013

    12 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 oct 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital05 nov 2013

    Estado de capital el 05 nov 2013

    • Capital: GBP 6
    SH01

    Cancelación total de la carga 4

    4 páginasMR04

    Cese del nombramiento de John Dobson como director

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2012

    20 páginasAA

    Cese del nombramiento de John Prowse como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 31 oct 2012 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr John William Charles Charlton el 28 oct 2012

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 31 oct 2011 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr Richard Hodgson el 28 oct 2011

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2011

    18 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de TOWERITE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    EDMONDS, Hugh Francis
    Stirling Park
    Laker Road
    ME1 3QR Rochester
    6
    Kent
    England
    Secretario
    Stirling Park
    Laker Road
    ME1 3QR Rochester
    6
    Kent
    England
    197706110001
    HODGSON, Richard George
    Gunnersbury Crescent
    W3 9AA London
    13
    England
    Director
    Gunnersbury Crescent
    W3 9AA London
    13
    England
    EnglandBritish155847280001
    CHARLTON, John William Charles
    Neata Farm
    Greet
    GL54 5BL Cheltenham
    Rowan Lodge
    Gloucestershire
    England
    Secretario
    Neata Farm
    Greet
    GL54 5BL Cheltenham
    Rowan Lodge
    Gloucestershire
    England
    150983600001
    STEELE, Vanessa
    Elkington Road
    Welford
    NN6 9NT Northampton
    Top House Farm
    Northamptonshire
    Uk
    Secretario
    Elkington Road
    Welford
    NN6 9NT Northampton
    Top House Farm
    Northamptonshire
    Uk
    British96617370005
    TRINDER, Ruth Annette
    Glenrise 70 Ecton Lane
    Sywell
    NN6 0BA Northampton
    Northamptonshire
    Secretario
    Glenrise 70 Ecton Lane
    Sywell
    NN6 0BA Northampton
    Northamptonshire
    British19376450003
    BUTLER, Christopher John
    Roughwood Hill Farm
    Hassall
    CW11 4XX Sandbach
    Cheshire
    Director
    Roughwood Hill Farm
    Hassall
    CW11 4XX Sandbach
    Cheshire
    EnglandBritish94118060001
    CHARLTON, John William Charles
    Neata Farm
    Greet
    GL54 5BL Cheltenham
    Rowan Lodge
    Gloucestershire
    Director
    Neata Farm
    Greet
    GL54 5BL Cheltenham
    Rowan Lodge
    Gloucestershire
    EnglandBritish119598150002
    COOK, Richard Antony
    54 Wrawby Road
    DN20 8DT Brigg
    North Lincolnshire
    Director
    54 Wrawby Road
    DN20 8DT Brigg
    North Lincolnshire
    EnglandBritish96617510001
    DOBSON, John Teasdale
    Dukes Wood
    RG45 6NF Crowthorne
    27
    Berkshire
    England
    Director
    Dukes Wood
    RG45 6NF Crowthorne
    27
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish99903330001
    DOBSON, John Teasdale
    27 Dukes Wood
    RG45 6NF Crowthorne
    Berkshire
    Director
    27 Dukes Wood
    RG45 6NF Crowthorne
    Berkshire
    United KingdomBritish99903330001
    GRIFFITHS, Selwyn Jonathan
    71 Landcross Drive
    NN3 3LN Northampton
    Director
    71 Landcross Drive
    NN3 3LN Northampton
    United KingdomBritish59340440002
    GRIFFITHS, Selwyn Jonathan
    1 Brendon Close
    Abington Vale
    NN3 3AQ Northampton
    Northamptonshire
    Director
    1 Brendon Close
    Abington Vale
    NN3 3AQ Northampton
    Northamptonshire
    British49864730001
    HUNTER, Michael Robert
    26 Crutchley Road
    RG40 1XD Wokingham
    Berkshire
    Director
    26 Crutchley Road
    RG40 1XD Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritish64053950001
    PROWSE, John
    Ongar Road
    CM15 9HP Brentwood
    317
    Essex
    England
    Director
    Ongar Road
    CM15 9HP Brentwood
    317
    Essex
    England
    EnglandBritish96786510001
    TEBBUTT, John Edward Graham
    Fairlawne 59 Sywell Road
    Overstone
    NN6 0AG Northampton
    Northamptonshire
    Director
    Fairlawne 59 Sywell Road
    Overstone
    NN6 0AG Northampton
    Northamptonshire
    British11439780001
    TRINDER, Philip James
    Glenrise
    70 Ecton Lane, Sywell
    NN6 0BA Northampton
    Northamptonshire
    Director
    Glenrise
    70 Ecton Lane, Sywell
    NN6 0BA Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish74019280001
    TRINDER, Ruth Annette
    Glenrise 70 Ecton Lane
    Sywell
    NN6 0BA Northampton
    Northamptonshire
    Director
    Glenrise 70 Ecton Lane
    Sywell
    NN6 0BA Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish19376450003
    WILKINSON, Michael Guyon
    4 Pounds Farm Cottage
    East Garston
    RG16 7HU Newbury
    Director
    4 Pounds Farm Cottage
    East Garston
    RG16 7HU Newbury
    British36607460001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de TOWERITE LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Stirling Park, Laker Road
    ME1 3QR Rochester
    6
    Kent
    England
    06 abr 2016
    Stirling Park, Laker Road
    ME1 3QR Rochester
    6
    Kent
    England
    No
    Forma jurídicaPlc
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro01635609
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene TOWERITE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 30 abr 2010
    Entregado el 12 may 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 12 may 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 15 oct 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Assignment of keyman life policy, intimation dated 18 june 2004 and
    Creado el 18 jun 2004
    Entregado el 22 jun 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Company: scottish provident policy number: 13101232 date: 28/02/2003 sum: £225,000 life assured: philip james trinder together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 22 jun 2004Registro de un cargo (395)
    • 16 feb 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 05 dic 2002
    Entregado el 21 dic 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 21 dic 2002Registro de un cargo (395)
    • 30 abr 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creado el 23 ago 2000
    Entregado el 12 sept 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 12 sept 2000Registro de un cargo (395)
    • 16 feb 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0