TOWERITE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | TOWERITE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02433029 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de TOWERITE LIMITED?
- Recolección, tratamiento y suministro de agua (36000) / Captación, depuración y distribución de agua; gestión de residuos; actividades de descontaminación y recuperación
¿Dónde se encuentra TOWERITE LIMITED?
| Dirección de la sede social | 6 Stirling Park Laker Road ME1 3QR Rochester Kent England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de TOWERITE LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 ago 2015 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para TOWERITE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 oct 2016 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 47 Riverside Medway City Estate Rochester Kent ME2 4DP a 6 Stirling Park Laker Road Rochester Kent ME1 3QR el 15 jun 2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 ago 2015 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 oct 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 mar 2015 au 31 ago 2015 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Hugh Francis Edmonds como secretario el 14 may 2015 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John William Charles Charlton como director el 30 abr 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John William Charles Charlton como secretario el 30 abr 2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Unit 2 Derwent Close Warndon Worcester WR4 9TY a 47 Riverside Medway City Estate Rochester Kent ME2 4DP el 01 abr 2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 oct 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2014 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2013 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 oct 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cancelación total de la carga 4 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Dobson como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2012 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Prowse como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 oct 2012 avec liste complète des actionnaires | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr John William Charles Charlton el 28 oct 2012 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 oct 2011 avec liste complète des actionnaires | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Richard Hodgson el 28 oct 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2011 | 18 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de TOWERITE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDMONDS, Hugh Francis | Secretario | Stirling Park Laker Road ME1 3QR Rochester 6 Kent England | 197706110001 | |||||||
| HODGSON, Richard George | Director | Gunnersbury Crescent W3 9AA London 13 England | England | British | 155847280001 | |||||
| CHARLTON, John William Charles | Secretario | Neata Farm Greet GL54 5BL Cheltenham Rowan Lodge Gloucestershire England | 150983600001 | |||||||
| STEELE, Vanessa | Secretario | Elkington Road Welford NN6 9NT Northampton Top House Farm Northamptonshire Uk | British | 96617370005 | ||||||
| TRINDER, Ruth Annette | Secretario | Glenrise 70 Ecton Lane Sywell NN6 0BA Northampton Northamptonshire | British | 19376450003 | ||||||
| BUTLER, Christopher John | Director | Roughwood Hill Farm Hassall CW11 4XX Sandbach Cheshire | England | British | 94118060001 | |||||
| CHARLTON, John William Charles | Director | Neata Farm Greet GL54 5BL Cheltenham Rowan Lodge Gloucestershire | England | British | 119598150002 | |||||
| COOK, Richard Antony | Director | 54 Wrawby Road DN20 8DT Brigg North Lincolnshire | England | British | 96617510001 | |||||
| DOBSON, John Teasdale | Director | Dukes Wood RG45 6NF Crowthorne 27 Berkshire England | United Kingdom | British | 99903330001 | |||||
| DOBSON, John Teasdale | Director | 27 Dukes Wood RG45 6NF Crowthorne Berkshire | United Kingdom | British | 99903330001 | |||||
| GRIFFITHS, Selwyn Jonathan | Director | 71 Landcross Drive NN3 3LN Northampton | United Kingdom | British | 59340440002 | |||||
| GRIFFITHS, Selwyn Jonathan | Director | 1 Brendon Close Abington Vale NN3 3AQ Northampton Northamptonshire | British | 49864730001 | ||||||
| HUNTER, Michael Robert | Director | 26 Crutchley Road RG40 1XD Wokingham Berkshire | England | British | 64053950001 | |||||
| PROWSE, John | Director | Ongar Road CM15 9HP Brentwood 317 Essex England | England | British | 96786510001 | |||||
| TEBBUTT, John Edward Graham | Director | Fairlawne 59 Sywell Road Overstone NN6 0AG Northampton Northamptonshire | British | 11439780001 | ||||||
| TRINDER, Philip James | Director | Glenrise 70 Ecton Lane, Sywell NN6 0BA Northampton Northamptonshire | England | British | 74019280001 | |||||
| TRINDER, Ruth Annette | Director | Glenrise 70 Ecton Lane Sywell NN6 0BA Northampton Northamptonshire | England | British | 19376450003 | |||||
| WILKINSON, Michael Guyon | Director | 4 Pounds Farm Cottage East Garston RG16 7HU Newbury | British | 36607460001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de TOWERITE LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apc Technology Group Plc | 06 abr 2016 | Stirling Park, Laker Road ME1 3QR Rochester 6 Kent England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene TOWERITE LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 30 abr 2010 Entregado el 12 may 2010 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Assignment of keyman life policy, intimation dated 18 june 2004 and | Creado el 18 jun 2004 Entregado el 22 jun 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Company: scottish provident policy number: 13101232 date: 28/02/2003 sum: £225,000 life assured: philip james trinder together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 05 dic 2002 Entregado el 21 dic 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage debenture | Creado el 23 ago 2000 Entregado el 12 sept 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0