COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) LIMITED

COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCOUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02435766
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) LIMITED?

    • (7499) /

    ¿Dónde se encuentra COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) PLC24 oct 198924 oct 1989

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 may 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    24 páginas4.71

    Domicilio social registrado cambiado de One Kingdom Street Paddington London W2 6BL el 08 jun 2011

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 26 may 2011

    LRESSP

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 may 2010

    5 páginasAA

    Estado de capital el 14 feb 2011

    • Capital: GBP 840.00
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    £33400000 cancelled from share prem a/c 04/02/2011
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Déclaration annuelle établie au 30 sept 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Nombramiento de Thomas Edward Timothy Homer como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de James Cheesewright como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Nicholas Brian Farrimond como director

    6 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Richard Ham como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Misys Corporate Secretary Limited como secretario

    2 páginasAP04

    Cese del nombramiento de Gurbinder Bains como secretario

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 may 2009

    5 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MISYS CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    Secretario corporativo
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro07036299
    149985420001
    FARRIMOND, Nicholas Brian
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    England
    Director
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish75357260001
    HOMER, Thomas Edward Timothy
    Maidenhead Road
    Cookham
    SL6 9DF Berkshire
    Rosedale
    United Kingdom
    Director
    Maidenhead Road
    Cookham
    SL6 9DF Berkshire
    Rosedale
    United Kingdom
    EnglandBritish146605570001
    MISYS CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    1
    Director corporativo
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    1
    82836510002
    BAINS, Gurbinder
    Kingston Road
    UB2 4AP Southall
    36
    Middlesex
    United Kingdom
    Secretario
    Kingston Road
    UB2 4AP Southall
    36
    Middlesex
    United Kingdom
    Other138753780001
    DURRANT, Zoe Vivienne
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    Secretario
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    British68141090001
    GRAY, Elizabeth Andrea
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    Secretario
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    British98035800001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Secretario
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    British136433670001
    JACOBS, Trevor Arthur
    23 Crowson Way
    Deeping St James
    PE6 8EY Peterborough
    Cambridgeshire
    Secretario
    23 Crowson Way
    Deeping St James
    PE6 8EY Peterborough
    Cambridgeshire
    British5724050001
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    Secretario
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    British1439590001
    WATERS, Paul Christopher
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    Secretario
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    British67435560001
    BEAUMONT, Frederick Peter
    The Homestead
    The Playing Close Browns Lane
    OX7 3QP Chalbury
    Oxfordshire
    Director
    The Homestead
    The Playing Close Browns Lane
    OX7 3QP Chalbury
    Oxfordshire
    British17370420001
    CHEESEWRIGHT, James
    Horton Meadow
    Heyshott
    GU29 0DL Midhurst
    West Sussex
    Director
    Horton Meadow
    Heyshott
    GU29 0DL Midhurst
    West Sussex
    United KingdomBritish80646020001
    COOK, John
    Barnside
    GL20 7BP Tredington
    Gloucestershire
    Director
    Barnside
    GL20 7BP Tredington
    Gloucestershire
    EnglandBritish86208160001
    COPELAND, Philip Robert
    Crofton Sheldon Road
    Ickford
    HP18 9HY Aylesbury
    Buckinghamshire
    Director
    Crofton Sheldon Road
    Ickford
    HP18 9HY Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritish44954570001
    DAVIS, James Michael
    22 Meadow Road
    Market Deeping
    PE6 8PF Peterborough
    Cambridgeshire
    Director
    22 Meadow Road
    Market Deeping
    PE6 8PF Peterborough
    Cambridgeshire
    EnglandBritish17589470001
    EVANS, Howard
    Charlton Park House
    Charlton Park Gate
    GL53 7DJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    Charlton Park House
    Charlton Park Gate
    GL53 7DJ Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritish56986700002
    GRAHAM, Ross King
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Director
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritish61733920001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Director
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish136433670001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Director
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish136433670001
    JACOBS, Trevor Arthur
    12 Woodcroft Close
    PE6 8BT Market Deeping
    Lincs
    Director
    12 Woodcroft Close
    PE6 8BT Market Deeping
    Lincs
    British5724050002
    KING, Gary James
    The Coppice Brockhill Road
    WR14 4DL West Malvern
    Worcestershire
    Director
    The Coppice Brockhill Road
    WR14 4DL West Malvern
    Worcestershire
    British5724060004
    LOMAX, John Kevin
    Hawling Manor
    Hawling
    GL54 5TA Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    Hawling Manor
    Hawling
    GL54 5TA Cheltenham
    Gloucestershire
    British22190280002
    MCMAHON, Jasper Philip
    Ground Floor Flat
    33 Warrington Crescent
    W9 1EJ London
    Director
    Ground Floor Flat
    33 Warrington Crescent
    W9 1EJ London
    EnglandBritish45080250003
    MORGAN, Glyn Howell
    2a College Road
    WR14 3DD Malvern
    Worcestershire
    Director
    2a College Road
    WR14 3DD Malvern
    Worcestershire
    British10282920001
    MORGAN, Roger Hugh
    The Gables Grit Lane
    Leigh Sinton
    WR14 1UR Malvern
    Worcestershire
    Director
    The Gables Grit Lane
    Leigh Sinton
    WR14 1UR Malvern
    Worcestershire
    British17001000001
    O'LEARY, Michael Kevin
    Greenwood
    Wichenford
    WR6 6YB Worcester
    Worcestershire
    Director
    Greenwood
    Wichenford
    WR6 6YB Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritish129193560001
    SHAW, John Malcolm
    Willow Gate
    Southorpe
    PE9 3BX Stamford
    Lincolnshire
    Director
    Willow Gate
    Southorpe
    PE9 3BX Stamford
    Lincolnshire
    EnglandBritish12536610001
    SUSSENS, John Gilbert
    Blythe House 10 Grange Road
    Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    Director
    Blythe House 10 Grange Road
    Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    EnglandBritish1442450002
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    Director
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    British1439590001

    ¿Tiene COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off (olso) dated 3RD july 1995
    Creado el 19 dic 2006
    Entregado el 29 dic 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 29 dic 2006Registro de un cargo (395)
    • 20 may 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995
    Creado el 17 sept 2003
    Entregado el 01 oct 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 01 oct 2003Registro de un cargo (395)
    • 20 may 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3 july 1995
    Creado el 11 sept 2003
    Entregado el 24 sept 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 24 sept 2003Registro de un cargo (395)
    • 20 may 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and
    Creado el 29 jul 2003
    Entregado el 12 ago 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 12 ago 2003Registro de un cargo (395)
    • 20 may 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 (the letter)
    Creado el 23 oct 2002
    Entregado el 13 nov 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 13 nov 2002Registro de un cargo (395)
    • 20 may 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995
    Creado el 09 may 2002
    Entregado el 25 may 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 25 may 2002Registro de un cargo (395)
    • 20 may 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    ¿Tiene COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    15 may 2012Fecha de disolución
    26 may 2011Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    William Antony Batty
    Antony Batty & Co
    Third Floor
    WC1R 5EF 3 Field Court
    Gray'S Inn London
    Profesional
    Antony Batty & Co
    Third Floor
    WC1R 5EF 3 Field Court
    Gray'S Inn London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0