MP SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED

MP SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMP SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02436108
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MP SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra MP SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED?

    Dirección de la sede social
    8th Floor One Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MP SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    METAPATH SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED15 dic 199815 dic 1998
    MOBILE SYSTEMS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY04 ago 199204 ago 1992
    MOBILE SYSTEMS UK LIMITED25 oct 198925 oct 1989

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MP SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2021

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MP SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    19 páginasLIQ13
    YCUBEOZT

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 01 mar 2023

    17 páginasLIQ03
    YC2SA7AX

    Domicilio social registrado cambiado de Point 3 Haywood Road Warwick CV34 5AH a 8th Floor One Temple Row Birmingham B2 5LG el 11 mar 2022

    2 páginasAD01
    YAYZ3YMJ

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600
    YAYZ3XWR

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 02 mar 2022

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    6 páginasLIQ01
    YAYZ3YKA

    Estado de capital el 04 nov 2021

    • Capital: GBP 0.025
    3 páginasSH19
    YAGI945E

    legacy

    1 páginasSH20
    YAGI947E

    legacy

    1 páginasCAP-SS
    YAGI9496

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Cancellation of share premium account; cancellation of capital redemption reserve 02/11/2021
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2021

    16 páginasAA
    AAFR35W0

    Declaración de confirmación presentada el 28 abr 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    XA3H0I4Q

    Nombramiento de Mrs Heather Marie Green como director el 18 feb 2021

    2 páginasAP01
    X9YLSHFU

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2020

    15 páginasAA
    A9FULW9N

    Declaración de confirmación presentada el 28 abr 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    X943EH23

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2019

    13 páginasAA
    A8IQM4BM

    Declaración de confirmación presentada el 28 abr 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    X84I4L14

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2018

    13 páginasAA
    A7GF4A1T

    Declaración de confirmación presentada el 28 abr 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    X74YHPUX

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2017

    13 páginasAA
    A6F0HWTL

    Declaración de confirmación presentada el 28 abr 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01
    X65OR3WW

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2016

    12 páginasAA
    A5JF345M

    Déclaration annuelle établie au 28 abr 2016 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital29 abr 2016

    Estado de capital el 29 abr 2016

    • Capital: GBP 40,000,000
    SH01
    X55X7XUR

    Cese del nombramiento de Craig George Donaldson como secretario el 31 mar 2016

    1 páginasTM02
    X5461KZF

    ¿Quiénes son los directivos de MP SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GREEN, Heather Marie
    One Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    8th Floor
    Director
    One Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    8th Floor
    EnglandBritishChief Financial Officer106936580002
    WEBBERLEY, Mark Andrew
    One Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    8th Floor
    Director
    One Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    8th Floor
    EnglandBritishChartered Accountant162019130001
    BRITTON, Jeanette Eden
    32 Chestnut Avenue
    KT10 8JF Esher
    Surrey
    Secretario
    32 Chestnut Avenue
    KT10 8JF Esher
    Surrey
    British33976690001
    CARPENTER, Peter Jon
    3a King Edward Mansions
    No 8 Grape Street
    WC2H 8DY London
    Secretario
    3a King Edward Mansions
    No 8 Grape Street
    WC2H 8DY London
    British37632220001
    DONALDSON, Craig George
    Haywood Road
    CV34 5AH Warwick
    Point 3
    Secretario
    Haywood Road
    CV34 5AH Warwick
    Point 3
    British79026210001
    FADL, Hania, Dr
    15 Marlborough Place
    St Johns Wood
    NW8 0PG London
    Secretario
    15 Marlborough Place
    St Johns Wood
    NW8 0PG London
    British7644540001
    LONG, Jacqueline
    361 Hanworth Road
    TW12 3EJ Hampton
    Middlesex
    Secretario
    361 Hanworth Road
    TW12 3EJ Hampton
    Middlesex
    BritishCompany Secretary77617710001
    MEADES, Derek Leslie
    Alfriston House
    The Avenue
    SL5 7LY Ascot
    Berkshire
    Secretario
    Alfriston House
    The Avenue
    SL5 7LY Ascot
    Berkshire
    BritishAccountant8142960002
    SKELLY, Mary Angela
    44 Hartswood Road
    Stamford Brook
    W12 9NF London
    Secretario
    44 Hartswood Road
    Stamford Brook
    W12 9NF London
    British83455820001
    SMITH, Julian Matthew
    36 Ferndene Road
    Herne Hill
    SE24 0AB London
    Secretario
    36 Ferndene Road
    Herne Hill
    SE24 0AB London
    British110194190001
    ANDREEN, Marcus
    Flat 3 39 Matheson Road
    W14 8SN London
    Director
    Flat 3 39 Matheson Road
    W14 8SN London
    SwedishSolicitor44488170001
    BAJWA, Anwar Sharif, Dr
    7 Lavenda Close
    Hempstead
    ME7 3TB Gillingham
    Kent
    Director
    7 Lavenda Close
    Hempstead
    ME7 3TB Gillingham
    Kent
    United KingdomBritishTechnical Director32990830001
    BUTLER, Thomas Michael
    13 West Heath Road
    Hampstead
    NW3 7UU London
    Director
    13 West Heath Road
    Hampstead
    NW3 7UU London
    BritishDirector24904420001
    CARPENTER, Peter Jon
    3a King Edward Mansions
    No 8 Grape Street
    WC2H 8DY London
    Director
    3a King Edward Mansions
    No 8 Grape Street
    WC2H 8DY London
    BritishCompany Director37632220001
    CARRINGTON, John Christopher
    1 Anchor Brewhouse
    50 Shad Thames
    SE1 2LY London
    Director
    1 Anchor Brewhouse
    50 Shad Thames
    SE1 2LY London
    United KingdomBritishManaging Director79087670001
    COPELAND, James
    4808 Prestwick Drive
    Colleyville Texas
    76034
    United States
    Director
    4808 Prestwick Drive
    Colleyville Texas
    76034
    United States
    United States CitizenVice President Finance94697790001
    DAIN, Mark St.John
    316 Shobnall Road
    DE14 2BG Burton On Trent
    Staffordshire
    Director
    316 Shobnall Road
    DE14 2BG Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritishChartered Certified Accountant159246160001
    DAYA, Moez Rajabali Rahemtulla
    6 Christchurch Road
    CR8 2BY Purley
    Surrey
    Director
    6 Christchurch Road
    CR8 2BY Purley
    Surrey
    KenyaEngineering Consulta7644560001
    DONALDSON, Craig George
    Haywood Road
    CV34 5AH Warwick
    Point 3
    Director
    Haywood Road
    CV34 5AH Warwick
    Point 3
    United KingdomBritishChartered Secretary79026210001
    HANKINS, Kevin
    485 The Hermitage Drive
    FOREIGN Alpharetta
    30004 Georgia
    Us
    Director
    485 The Hermitage Drive
    FOREIGN Alpharetta
    30004 Georgia
    Us
    United States CitizenExecutive Vice President105639200001
    HARDYMON, Gene Felda
    22 Newton Street
    02193 Weston
    Massachusetts
    Usa
    Director
    22 Newton Street
    02193 Weston
    Massachusetts
    Usa
    AmericanPartner Venture Capital62278260001
    HARRIS, Paul
    29 Eastfields Road
    CR4 2LS Mitcham
    Surrey
    Director
    29 Eastfields Road
    CR4 2LS Mitcham
    Surrey
    BritishAccountant68547980001
    HOLT, Martin Alan
    13 Heath Rise
    NN8 5QN Wellingborough
    Director
    13 Heath Rise
    NN8 5QN Wellingborough
    BritishSales Director81023100001
    IBRAHIM, Mohamed Fathi Ahmed, Doctor
    20 Park Street
    W1K 2JA London
    Director
    20 Park Street
    W1K 2JA London
    BritishTelecommunications Consultant72245030003
    JULIN, Sven Tomas
    Magnebergsvagen 51
    12134 Enskededalen
    Stockholm
    Sweden
    Director
    Magnebergsvagen 51
    12134 Enskededalen
    Stockholm
    Sweden
    SwedishCompany Director47715430001
    KERN, Rene M
    151 East 92nd Street
    10128 New York
    New York
    Usa
    Director
    151 East 92nd Street
    10128 New York
    New York
    Usa
    GermanDirector71085180001
    LONG, Jacqueline
    361 Hanworth Road
    TW12 3EJ Hampton
    Middlesex
    Director
    361 Hanworth Road
    TW12 3EJ Hampton
    Middlesex
    BritishCompany Secretary77617710001
    MACGOWAN, Iain Angus William
    Flat2
    22 Saltoun Road
    SW2 1EP London
    Director
    Flat2
    22 Saltoun Road
    SW2 1EP London
    BritishSolicitor68985510001
    MEADES, Derek Leslie
    Alfriston House
    The Avenue
    SL5 7LY Ascot
    Berkshire
    Director
    Alfriston House
    The Avenue
    SL5 7LY Ascot
    Berkshire
    BritishAccountant8142960002
    MEYER, John Joseph
    3745 Sterling Road
    Downes Grove
    60515 Illinois
    U.S.A
    Director
    3745 Sterling Road
    Downes Grove
    60515 Illinois
    U.S.A
    AmericanTelecommunications34273260001
    PORTER, Norman Charles
    Farnham House 2 Beedingwood Drive
    Forest Road Colgate
    RH12 4TE Horsham
    West Sussex
    Director
    Farnham House 2 Beedingwood Drive
    Forest Road Colgate
    RH12 4TE Horsham
    West Sussex
    EnglandBritishCompany Secretary445360034
    REDDY, Sreenivasula Dhanireddy
    Ino 40 Coventry Drive
    60188 Wheaton
    Illinois
    Usa
    Director
    Ino 40 Coventry Drive
    60188 Wheaton
    Illinois
    Usa
    IndianDirector50894490001
    RHODES, Terence
    12 Dartmouth Row
    Greenwich
    SE10 8AN London
    Director
    12 Dartmouth Row
    Greenwich
    SE10 8AN London
    BritishBusiness Development Director72245020001
    ROBINSON, Colin Lloyd
    3717 Atrium Dr
    FOREIGN Plano Tx 75075 Usa
    U S A
    Director
    3717 Atrium Dr
    FOREIGN Plano Tx 75075 Usa
    U S A
    UsaCompany Director41651480001
    SCHICKLING, John Joseph
    Crawford Lodge Orchehill Avenue
    SL9 8QF Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    Crawford Lodge Orchehill Avenue
    SL9 8QF Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Accountant75042900002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de MP SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Telent Limited
    Haywood Road
    CV34 5AH Warwick
    Point 3
    England
    06 abr 2016
    Haywood Road
    CV34 5AH Warwick
    Point 3
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngand & Wales
    Número de registro67307
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene MP SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Security trust and intercreditor deed
    Creado el 19 may 2003
    Entregado el 05 jun 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    If any intra-group creditor receives any sum in relation to any intra-group liability other than pursuant to clause 9.5 of the deed, that sum shall be promptly paid to the security trustee for application in accordance with the terms of the deed, and pending such payment it shall be held on trust for the security trustee.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 05 jun 2003Registro de un cargo (395)
    • 16 nov 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    An australian asset fixed and floating charge
    Creado el 19 may 2003
    Entregado el 04 jun 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future indebtedness liabilities and obligations at any time of the company to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the secured creditors) or any of the other secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. as Security Trustee
    Transacciones
    • 04 jun 2003Registro de un cargo (395)
    • 16 nov 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A debenture between the companies (including the chargor) and the law debenture trust corporation P.L.C. as security trustee for the secured creditors
    Creado el 19 may 2003
    Entregado el 02 jun 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future indebtedness liabilities and obligations at any time of the company to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the secured creditors) or any of the other secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first fixed charge all of its right title and interest from time to time and to each of the following assets: the schedule 4 real property; the tangible moveable property; any goodwill; all rights in relation to the uncalled capital; the shares, all dividends, interest and other monies; all monetary claims. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. as Security Trustee
    Transacciones
    • 02 jun 2003Registro de un cargo (395)
    • 16 nov 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creado el 25 abr 2000
    Entregado el 11 may 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a bond in favour of centre d'etrudes et de recherches des telecommunications (cert) for us$37,270
    Breve descripción
    The sum of us$37,270 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 140-01-08153957.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 11 may 2000Registro de un cargo (395)
    • 12 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creado el 31 mar 2000
    Entregado el 10 abr 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a bond in favour of centre d'etrudes et de recherches des telecommunications (cert) for us $ 37,270
    Breve descripción
    The sum of $37,270 us dollars together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 140/01/08153957 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 10 abr 2000Registro de un cargo (395)
    • 12 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 25 oct 1999
    Entregado el 28 oct 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from metapath software international, inc., Metapath software international (bellevue), inc., Metapath software international (dallas), inc. And metapath software international limited to the chargee under a facility document as defined in the guarantee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Greyrock Capital
    Transacciones
    • 28 oct 1999Registro de un cargo (395)
    • 12 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creado el 22 oct 1999
    Entregado el 26 oct 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a performance bond in favour of bharti cellular limited $25,300 us dollars
    Breve descripción
    The sum of $25,300 us dollars together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 140/01/08123748 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 26 oct 1999Registro de un cargo (395)
    • 12 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creado el 22 oct 1999
    Entregado el 26 oct 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a performance bond in favour of singapore telecom mobile pte limited for s$345,576.65 Singapore dollars
    Breve descripción
    The sum of $249,700 us dollars together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 140/01/08123764 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 26 oct 1999Registro de un cargo (395)
    • 12 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creado el 19 oct 1999
    Entregado el 27 oct 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a performance bond in favour of et communications sdn bhd for us$109,475.40
    Breve descripción
    The sum of us$109,475.40 Together with interest accrued now or to be he national westminster bank PLC on an account numbered 140-01-08119538 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 27 oct 1999Registro de un cargo (395)
    • 12 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creado el 04 mar 1999
    Entregado el 11 mar 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The sum of £18,000 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 90182111.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 11 mar 1999Registro de un cargo (395)
    • 12 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creado el 30 mar 1998
    Entregado el 03 abr 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    $1,563,000 us dollars with interest accrued on account no. 140-01-06422160 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 03 abr 1998Registro de un cargo (395)
    • 12 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creado el 30 mar 1998
    Entregado el 03 abr 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    $1,953,000 us dollars with interest thereon on account no. 140-01-06422160 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 03 abr 1998Registro de un cargo (395)
    • 12 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 19 jun 1997
    Entregado el 24 jun 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 24 jun 1997Registro de un cargo (395)
    • 28 oct 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creado el 25 nov 1996
    Entregado el 04 dic 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a performance guarantee in favour of china resources (holdings) co LTD for hk$11,000,000
    Breve descripción
    The sum of £1,100,000 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 90122904 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 04 dic 1996Registro de un cargo (395)
    • 16 oct 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creado el 25 nov 1996
    Entregado el 03 dic 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The sum of £1,375,000 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 90123298 and earmarked or designated ny reference to the company.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 03 dic 1996Registro de un cargo (395)
    • 16 oct 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene MP SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    02 mar 2022Inicio de la liquidación
    10 abr 2024Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Mark Malone
    8th Floor One Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    Profesional
    8th Floor One Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    Gareth Prince
    8th Floor One Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    Profesional
    8th Floor One Temple Row
    B2 5LG Birmingham

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0