VIEWTON PROPERTIES LIMITED

VIEWTON PROPERTIES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaVIEWTON PROPERTIES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02436950
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de VIEWTON PROPERTIES LIMITED?

    • Construcción de edificios comerciales (41201) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra VIEWTON PROPERTIES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    2 Centro Place
    Pride Park
    DE24 8RF Derby
    Derbyshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de VIEWTON PROPERTIES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2022

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para VIEWTON PROPERTIES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2022

    5 páginasAA

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 20 jun 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 20 jun 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 20 jun 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020

    5 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 20 jun 2020 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 20 jun 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 20 jun 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 20 jun 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 08 jun 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital27 jun 2016

    Estado de capital el 27 jun 2016

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    5 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Ian Murdoch el 03 ago 2015

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 08 jun 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital08 jun 2015

    Estado de capital el 08 jun 2015

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Cese del nombramiento de Keith Manson Miller como director el 31 mar 2015

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 08 jun 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital30 jun 2014

    Estado de capital el 30 jun 2014

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    ¿Quiénes son los directivos de VIEWTON PROPERTIES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    JACKSON, Julie Mansfield
    Centro Place
    Pride Park
    DE24 8RF Derby
    2
    Derbyshire
    United Kingdom
    Director
    Centro Place
    Pride Park
    DE24 8RF Derby
    2
    Derbyshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish94193070001
    MURDOCH, Ian
    Centro Place
    Pride Park
    DE24 8RF Derby
    2
    Derbyshire
    United Kingdom
    Director
    Centro Place
    Pride Park
    DE24 8RF Derby
    2
    Derbyshire
    United Kingdom
    ScotlandBritish179717450001
    FELLOWES, Colin
    9 Thistlewood Drive
    Summerfields
    SK9 2RF Wilmslow
    Cheshire
    Secretario
    9 Thistlewood Drive
    Summerfields
    SK9 2RF Wilmslow
    Cheshire
    British800670001
    SMYTH, Pamela June
    6060 Knights Court, Solihull
    Parkway, Birmingham Business
    B37 7WY Park, Solihull
    Secretario
    6060 Knights Court, Solihull
    Parkway, Birmingham Business
    B37 7WY Park, Solihull
    British65057960002
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secretario corporativo
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    38508390004
    ANDERSON, Ewan Thomas
    6060 Knights Court, Solihull
    Parkway, Birmingham Business
    B37 7WY Park, Solihull
    Director
    6060 Knights Court, Solihull
    Parkway, Birmingham Business
    B37 7WY Park, Solihull
    ScotlandBritish71536430001
    BAK, Paul Mario
    Greenacres August Lane
    Farley Green
    GU5 9DP Guildford
    Surrey
    Director
    Greenacres August Lane
    Farley Green
    GU5 9DP Guildford
    Surrey
    British67836240002
    BASELEY, Stewart Antony
    Low Wood
    Westwood Road
    GU20 6LX Windlesham
    Surrey
    Director
    Low Wood
    Westwood Road
    GU20 6LX Windlesham
    Surrey
    EnglandBritish4809150002
    COX, Michael John
    Holly Tree House
    Brandy Bottom Yateley Common
    GU17 6BE Camberley
    Surrey
    Director
    Holly Tree House
    Brandy Bottom Yateley Common
    GU17 6BE Camberley
    Surrey
    British28998990001
    DEVINE, Stephen Colm
    4 Fernbank
    Finchampstead
    RG11 4XB Wokingham
    Berkshire
    Director
    4 Fernbank
    Finchampstead
    RG11 4XB Wokingham
    Berkshire
    Irish6552570001
    FOGDEN, Geoffrey Harold
    Rydencroft
    Preston New Road
    PR4 3RE Newton With Scales
    Lancashire
    Director
    Rydencroft
    Preston New Road
    PR4 3RE Newton With Scales
    Lancashire
    United KingdomBritish92179710001
    HAMPSON, John
    65 Kingsway
    WC2B 6QT London
    Director
    65 Kingsway
    WC2B 6QT London
    British25345860001
    HAWE, Malcolm Albert
    Greenbriar
    Dubside Wrea Green
    PR4 2WQ Preston
    Lancashire
    Director
    Greenbriar
    Dubside Wrea Green
    PR4 2WQ Preston
    Lancashire
    United KingdomBritish81788230001
    HOUGH, Timothy
    6060 Knights Court, Solihull
    Parkway, Birmingham Business
    B37 7WY Park, Solihull
    Director
    6060 Knights Court, Solihull
    Parkway, Birmingham Business
    B37 7WY Park, Solihull
    EnglandBritish80381140002
    ISAAC, Roger
    65 Kingsway
    WC2B 6QT London
    Director
    65 Kingsway
    WC2B 6QT London
    British7582000001
    JACKSON, Stanley Robertson
    74 Olivers Battery Road North
    SO22 4JB Winchester
    Hampshire
    Director
    74 Olivers Battery Road North
    SO22 4JB Winchester
    Hampshire
    British4689630002
    JACKSON, Stanley Robertson
    74 Olivers Battery Road North
    SO22 4JB Winchester
    Hampshire
    Director
    74 Olivers Battery Road North
    SO22 4JB Winchester
    Hampshire
    British4689630002
    MILLER, Keith Manson
    Centro Place
    Pride Park
    DE24 8RF Derby
    2
    Derbyshire
    United Kingdom
    Director
    Centro Place
    Pride Park
    DE24 8RF Derby
    2
    Derbyshire
    United Kingdom
    ScotlandBritish546650002
    MILLS, Stanley
    Whitegates
    Wixford
    B49 6DA North Alcester
    Warwickshire
    Director
    Whitegates
    Wixford
    B49 6DA North Alcester
    Warwickshire
    British573140004
    RICHARDS, John Steel
    Centro Place
    Pride Park
    DE24 8RF Derby
    2
    Derbyshire
    United Kingdom
    Director
    Centro Place
    Pride Park
    DE24 8RF Derby
    2
    Derbyshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish1318380002
    WOOD, Robert John
    Bramber House
    59 Lakewood Road, Chandlers Ford
    SO53 1EU Eastleigh
    Hants
    Director
    Bramber House
    59 Lakewood Road, Chandlers Ford
    SO53 1EU Eastleigh
    Hants
    British93812590001
    AMEC NOMINEES LIMITED
    Sandiway House
    Hartford
    CW8 2YA Northwich
    Cheshire
    Director corporativo
    Sandiway House
    Hartford
    CW8 2YA Northwich
    Cheshire
    32732300001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de VIEWTON PROPERTIES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Centro Place
    Pride Park
    DE24 8RF Derby
    2
    Derbyshire
    United Kingdom
    20 jun 2017
    Centro Place
    Pride Park
    DE24 8RF Derby
    2
    Derbyshire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro01987689
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene VIEWTON PROPERTIES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Security agreement
    Creado el 30 mar 2001
    Entregado el 12 abr 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or in respect of each senior document to which a chargor is a party
    Breve descripción
    Fixed charge over all investments owned by it or held by any nominee on it's behalf together with floating charge all the companies assets other than the investments. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Agent and Trustee for the Senior Lenders, the Facility Agent)
    Transacciones
    • 12 abr 2001Registro de un cargo (395)
    • 20 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Floating charge
    Creado el 23 mar 1990
    Entregado el 03 abr 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 03 abr 1990Registro de una carga
    • 19 abr 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 23 mar 1990
    Entregado el 03 abr 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Two parcels of f/h land at ovangle road morecombe.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 03 abr 1990Registro de una carga
    • 01 sept 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge on building agreement
    Creado el 23 mar 1990
    Entregado el 03 abr 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A building and management contract made 22-2-89. between fairclough homes limited & the company.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 03 abr 1990Registro de una carga
    • 01 sept 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 23 mar 1990
    Entregado el 24 mar 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to the debenture dated 22/12/89
    Breve descripción
    Fixed charge mortgage over two parcels of land at ovangle road, morecambe lancashire. Approx 39.75 acres. All buildings and fixtures. All plant and machinery. Vehicles computers and office equipment both present and future. (Please see form 395 for further details).
    Personas con derecho
    • Electra Property Finance Limited
    Transacciones
    • 24 mar 1990Registro de una carga
    • 01 sept 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment
    Creado el 22 dic 1989
    Entregado el 29 dic 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a facility agreement dated 22.12.89
    Breve descripción
    All rights title benefits & interest of the company in a building and management contract dated 18.12.89.
    Personas con derecho
    • Electra Property Finance Limited
    Transacciones
    • 29 dic 1989Registro de una carga
    • 19 abr 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 22 dic 1989
    Entregado el 29 dic 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (For full details refer to doc 395 ref M362C). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Electra Property Finance Limited
    Transacciones
    • 29 dic 1989Registro de una carga
    • 01 sept 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0