TEPNEL MEDICAL LIMITED

TEPNEL MEDICAL LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTEPNEL MEDICAL LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02437385
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TEPNEL MEDICAL LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra TEPNEL MEDICAL LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Heron House Oaks Businss Park
    Crewe Road
    M23 9HZ Wythenshawe
    Manchester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TEPNEL MEDICAL LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para TEPNEL MEDICAL LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TEPNEL MEDICAL LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cuentas preparadas hasta el 30 sept 2014

    6 páginasAA

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 25 nov 2014

    • Capital: GBP 1.00
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cese del nombramiento de Michael Keith Slater como secretario el 28 feb 2014

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de David Paul Harding como director el 30 jun 2014

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Glenn Patrick Muir como director el 30 jun 2014

    1 páginasTM01

    Cuentas preparadas hasta el 30 sept 2013

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 30 oct 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas preparadas hasta el 30 sept 2012

    7 páginasAA

    Nombramiento de Mr Mark Casey como director el 03 ene 2013

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr David Harding como director el 03 ene 2013

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Glenn Muir como director el 03 ene 2013

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Hans Michael Herbert Berrendorf como director el 03 ene 2013

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Carl William Hull como director el 15 feb 2013

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Antoine Lesage como director el 03 ene 2013

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 30 oct 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Michael Keith Slater como director el 01 ago 2012

    1 páginasTM01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2011

    7 páginasAA

    Cese del nombramiento de Herman Rosenman como director el 01 ago 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Robert William Bowen como director el 01 ago 2012

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de TEPNEL MEDICAL LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CASEY, Mark Joseph
    Heron House Oaks Businss Park
    Crewe Road
    M23 9HZ Wythenshawe
    Manchester
    Director
    Heron House Oaks Businss Park
    Crewe Road
    M23 9HZ Wythenshawe
    Manchester
    UsaAmerican176556400001
    LESAGE, Antoine Leon
    Heron House Oaks Businss Park
    Crewe Road
    M23 9HZ Wythenshawe
    Manchester
    Director
    Heron House Oaks Businss Park
    Crewe Road
    M23 9HZ Wythenshawe
    Manchester
    BelgiumBelgium176558770001
    CRAIG, Ian Alexander, Mr
    The Quinta
    Beechfield Road
    SK9 7AU Alderley Edge
    Cheshire
    Secretario
    The Quinta
    Beechfield Road
    SK9 7AU Alderley Edge
    Cheshire
    British17019070002
    CRAIG, Ian Alexander, Mr
    The Quinta
    Beechfield Road
    SK9 7AU Alderley Edge
    Cheshire
    Secretario
    The Quinta
    Beechfield Road
    SK9 7AU Alderley Edge
    Cheshire
    British17019070002
    FFOULKES DAVIES, Goronwy Philip
    Crossfield House
    Aston By Budworth
    CW9 6NG Northwich
    Cheshire
    Secretario
    Crossfield House
    Aston By Budworth
    CW9 6NG Northwich
    Cheshire
    British79348050002
    LEE, Jeremy Stephen William
    10 Hodge Fold
    SK14 6BL Broadbottom
    Cheshire
    Secretario
    10 Hodge Fold
    SK14 6BL Broadbottom
    Cheshire
    British98814590001
    SLATER, Michael Keith
    Heron House Oaks Businss Park
    Crewe Road
    M23 9HZ Wythenshawe
    Manchester
    Secretario
    Heron House Oaks Businss Park
    Crewe Road
    M23 9HZ Wythenshawe
    Manchester
    British127520220001
    WARBURTON, Anthony
    Ashfields
    Leigh Sinton
    WR13 5DH Malvern
    Secretario
    Ashfields
    Leigh Sinton
    WR13 5DH Malvern
    British22545650001
    BERRENDORF, Hans Michael Herbert
    Heron House Oaks Businss Park
    Crewe Road
    M23 9HZ Wythenshawe
    Manchester
    Director
    Heron House Oaks Businss Park
    Crewe Road
    M23 9HZ Wythenshawe
    Manchester
    GermanyGerman150998950001
    BOWEN, Robert William
    Heron House Oaks Businss Park
    Crewe Road
    M23 9HZ Wythenshawe
    Manchester
    Director
    Heron House Oaks Businss Park
    Crewe Road
    M23 9HZ Wythenshawe
    Manchester
    United StatesAmerican92112170002
    COLLEY, Terence
    45 Park Lane
    DY12 2EU Bewdley
    Worcestershire
    Director
    45 Park Lane
    DY12 2EU Bewdley
    Worcestershire
    British3802520001
    FFOULKES DAVIES, Goronwy Philip
    Crossfield House
    Aston By Budworth
    CW9 6NG Northwich
    Cheshire
    Director
    Crossfield House
    Aston By Budworth
    CW9 6NG Northwich
    Cheshire
    EnglandBritish79348050002
    HARDING, David Paul
    Heron House Oaks Businss Park
    Crewe Road
    M23 9HZ Wythenshawe
    Manchester
    Director
    Heron House Oaks Businss Park
    Crewe Road
    M23 9HZ Wythenshawe
    Manchester
    UsaAmerican149831430001
    HIGHFIELD, Peter Edmund, Dr
    Iona 28 Hollin Lane
    Styal
    SK9 4JH Wilmslow
    Cheshire
    Director
    Iona 28 Hollin Lane
    Styal
    SK9 4JH Wilmslow
    Cheshire
    British44440070002
    HULL, Carl William
    Heron House Oaks Businss Park
    Crewe Road
    M23 9HZ Wythenshawe
    Manchester
    Director
    Heron House Oaks Businss Park
    Crewe Road
    M23 9HZ Wythenshawe
    Manchester
    UsaUnited States137821960001
    MADDEN, Christopher John Frank
    Tall Trees
    Chipstead Lane Chipstead
    TN13 2RF Sevenoaks
    Kent
    Director
    Tall Trees
    Chipstead Lane Chipstead
    TN13 2RF Sevenoaks
    Kent
    British33509140001
    MARTIN, Anthony Francis, Doctor
    7 Tuckers Drive
    Holmer Green
    HP15 6SY High Wycombe
    Buckinghamshire
    Director
    7 Tuckers Drive
    Holmer Green
    HP15 6SY High Wycombe
    Buckinghamshire
    British41550470001
    MATZILEVICH, Ben
    156 Farm Street
    Dover
    Massachusetts Ma 2030
    Usa
    Director
    156 Farm Street
    Dover
    Massachusetts Ma 2030
    Usa
    UsaUsa90395410001
    MINTER, Steven John, Dr
    Moorlodge Farm
    Oven Hill Road New Mills
    SK12 4QL High Peak
    Derbyshire
    Director
    Moorlodge Farm
    Oven Hill Road New Mills
    SK12 4QL High Peak
    Derbyshire
    EnglandBritish70871580001
    MORLEY, Harold
    43 Riverside One Albion Wharf
    Hester Road
    SW11 4AN London
    Director
    43 Riverside One Albion Wharf
    Hester Road
    SW11 4AN London
    British23846940003
    MUIR, Glenn Patrick
    Heron House Oaks Businss Park
    Crewe Road
    M23 9HZ Wythenshawe
    Manchester
    Director
    Heron House Oaks Businss Park
    Crewe Road
    M23 9HZ Wythenshawe
    Manchester
    UsaAmerican127690730002
    NEWMAN, Anthony Ian
    2 Abberley Hall
    Chelford Road
    SK9 7TJ Alderley Edge
    Cheshire
    Director
    2 Abberley Hall
    Chelford Road
    SK9 7TJ Alderley Edge
    Cheshire
    United KingdomAustralian118879440001
    RAYMOND, Peter
    72 Grasmere Road
    Gatley
    SK8 4RS Cheadle
    Cheshire
    Director
    72 Grasmere Road
    Gatley
    SK8 4RS Cheadle
    Cheshire
    EnglandBritish14520770001
    ROSENMAN, Herman
    Heron House Oaks Businss Park
    Crewe Road
    M23 9HZ Wythenshawe
    Manchester
    Director
    Heron House Oaks Businss Park
    Crewe Road
    M23 9HZ Wythenshawe
    Manchester
    UsaUnited States137822190001
    SLATER, Michael Keith
    Heron House Oaks Businss Park
    Crewe Road
    M23 9HZ Wythenshawe
    Manchester
    Director
    Heron House Oaks Businss Park
    Crewe Road
    M23 9HZ Wythenshawe
    Manchester
    EnglandBritish206250680001
    TRIPPIER, David Austin, Sir
    Dowry Head
    Helmshore
    BB4 4AE Rossendale
    Lancashire
    Director
    Dowry Head
    Helmshore
    BB4 4AE Rossendale
    Lancashire
    British27871400001
    WARBURTON, Anthony
    Ashfields
    Leigh Sinton
    WR13 5DH Malvern
    Director
    Ashfields
    Leigh Sinton
    WR13 5DH Malvern
    British22545650001

    ¿Tiene TEPNEL MEDICAL LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 12 jun 2007
    Entregado el 21 jun 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 21 jun 2007Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 11 sept 1992
    Entregado el 21 sept 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The hollies 240 hale road hale altrincham cheshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transacciones
    • 21 sept 1992Registro de un cargo (395)
    • 07 ene 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0