VENTUREWORLD LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaVENTUREWORLD LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02439474
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de VENTUREWORLD LIMITED?

    • (9999) /

    ¿Dónde se encuentra VENTUREWORLD LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Lynton House
    Ackhurst Park
    PR7 1NY Foxhole Road Chorley
    Lancashire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de VENTUREWORLD LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para VENTUREWORLD LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2010

    12 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 03 nov 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital19 nov 2010

    Estado de capital el 19 nov 2010

    • Capital: GBP 2,302,272
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2009

    12 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 03 nov 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado

    1 páginasAD02

    Cambio de datos del secretario John Clement Kay el 26 nov 2009

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mr St John Stott el 26 nov 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director John Clement Kay el 26 nov 2009

    2 páginasCH01

    legacy

    10 páginas395

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    3 páginas403a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2008

    14 páginasAA

    legacy

    2 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2007

    15 páginasAA

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2006

    15 páginasAA

    legacy

    6 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    7 páginas363s

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2005

    14 páginasAA

    legacy

    7 páginas363s

    ¿Quiénes son los directivos de VENTUREWORLD LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    KAY, John Clement
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    United Kingdom
    Secretario
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    United Kingdom
    British27891540001
    KAY, John Clement
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    Director
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    EnglandBritish27891540001
    STOTT, St John
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    Director
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    United KingdomBritish83024660001
    LIVESEY, Frederick Joseph
    86d Whitley Crescent
    WN1 2PP Wigan
    Lancashire
    Secretario
    86d Whitley Crescent
    WN1 2PP Wigan
    Lancashire
    British32145610003
    LLOYD, Roger William
    1 Glen Park Close
    Chellaston
    DE73 5NT Derby
    Derbyshire
    Secretario
    1 Glen Park Close
    Chellaston
    DE73 5NT Derby
    Derbyshire
    British123160110001
    PENROSE, Ian Richard
    17 Chaucer Close
    Eccleston
    PR7 5UJ Chorley
    Lancashire
    Secretario
    17 Chaucer Close
    Eccleston
    PR7 5UJ Chorley
    Lancashire
    British32311080001
    STOTT, St John
    17 Uplands Chase
    Fulwood
    PR2 7AW Preston
    Secretario
    17 Uplands Chase
    Fulwood
    PR2 7AW Preston
    British83024660001
    BROOME, John Lawson
    Rednal Manor
    Rednal, West Felton
    SY11 4HT Oswestry
    Shropshire
    Director
    Rednal Manor
    Rednal, West Felton
    SY11 4HT Oswestry
    Shropshire
    British67181090001
    FRANCE-HAYHURST, James Robert
    Mayfield House
    Bunbury
    CW6 9SY Tarporley
    Cheshire
    Director
    Mayfield House
    Bunbury
    CW6 9SY Tarporley
    Cheshire
    EnglandBritish73943640003
    HEMMINGS, Craig John
    Charnock House Preston Road
    Charnock Richard
    PR7 5LH Chorley
    Lancashire
    Director
    Charnock House Preston Road
    Charnock Richard
    PR7 5LH Chorley
    Lancashire
    EnglandBritish180952730001
    HEMMINGS, Craig John
    Charnock House Preston Road
    Charnock Richard
    PR7 5LH Chorley
    Lancashire
    Director
    Charnock House Preston Road
    Charnock Richard
    PR7 5LH Chorley
    Lancashire
    EnglandBritish180952730001
    HEMMINGS, Peter Graham
    Shannon Court Bowring Road
    IM8 2LQ Ramsey
    Isle Of Man
    Director
    Shannon Court Bowring Road
    IM8 2LQ Ramsey
    Isle Of Man
    British16512550007
    HEMMINGS, Trevor James
    The Penthouse Retraite De La Mielle
    Route De La Haule St Brelade
    JE3 8BA Jersey
    Channel Islands
    Director
    The Penthouse Retraite De La Mielle
    Route De La Haule St Brelade
    JE3 8BA Jersey
    Channel Islands
    United KingdomBritish65090920001
    KILBY, Eric Melvyn
    The Coach House
    Didsbury
    M20 0DA Manchester
    Director
    The Coach House
    Didsbury
    M20 0DA Manchester
    British165870001
    PENROSE, Ian Richard
    17 Chaucer Close
    Eccleston
    PR7 5UJ Chorley
    Lancashire
    Director
    17 Chaucer Close
    Eccleston
    PR7 5UJ Chorley
    Lancashire
    British32311080001
    STOTT, St John
    17 Uplands Chase
    Fulwood
    PR2 7AW Preston
    Director
    17 Uplands Chase
    Fulwood
    PR2 7AW Preston
    United KingdomBritish83024660001
    SUNLEY, Anthony William
    22 East Grinstead Road
    RH7 6EP Lingfield
    Surrey
    Director
    22 East Grinstead Road
    RH7 6EP Lingfield
    Surrey
    British6467980001
    WIDDERS, Mark Lorimer
    12 Clovelly Drive
    Hillside
    PR8 3AJ Southport
    Merseyside
    Director
    12 Clovelly Drive
    Hillside
    PR8 3AJ Southport
    Merseyside
    EnglandBritish2272770002

    ¿Tiene VENTUREWORLD LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 27 oct 2006
    Entregado el 24 jul 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Guild Ventures Limited
    Transacciones
    • 24 jul 2009Registro de un cargo (395)
    1ST party commercial legal charge
    Creado el 15 ago 1997
    Entregado el 18 ago 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms and conditions as set out in this legal charge
    Breve descripción
    F/H land on the south east of pit lane shipley derbyshire t/n-DY137890.. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 18 ago 1997Registro de un cargo (395)
    • 03 abr 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 28 feb 1997
    Entregado el 06 mar 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 06 mar 1997Registro de un cargo (395)
    • 03 abr 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0