COSTAIN ENGINEERING & CONSTRUCTION LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | COSTAIN ENGINEERING & CONSTRUCTION LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02440829 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de COSTAIN ENGINEERING & CONSTRUCTION LIMITED?
- Construcción de carreteras y autopistas (42110) / Construcción
- Construcción de puentes y túneles (42130) / Construcción
- Construcción de proyectos de agua (42910) / Construcción
- Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.p. (42990) / Construcción
¿Dónde se encuentra COSTAIN ENGINEERING & CONSTRUCTION LIMITED?
| Dirección de la sede social | Seventh Floor 70 St Mary Axe EC3A 8BE London United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de COSTAIN ENGINEERING & CONSTRUCTION LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| COSTAIN E & C LIMITED | 10 ene 1990 | 10 ene 1990 |
| QUESTEARN LIMITED | 07 nov 1989 | 07 nov 1989 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de COSTAIN ENGINEERING & CONSTRUCTION LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para COSTAIN ENGINEERING & CONSTRUCTION LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 12 ene 2027 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 26 ene 2027 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 12 ene 2026 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para COSTAIN ENGINEERING & CONSTRUCTION LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 12 ene 2026 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Miss Catherine Warbrick el 21 oct 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 37 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 ene 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Miss Catherine Warbrick el 05 ago 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Modification des détails de Costain Group Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 05 ago 2024 | 2 páginas | PSC05 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Costain House Vanwall Business Park Maidenhead Berkshire SL6 4UB a Seventh Floor 70 st Mary Axe London EC3A 8BE el 05 ago 2024 | 1 páginas | AD01 | ||
Nombramiento de Paul Anthony Morris como director el 08 jul 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de David Roy Taylor como director el 08 jul 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 34 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 ene 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Ms Helen Margaret Willis el 03 ago 2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Nombramiento de Catherine Warbrick como director el 03 jul 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 39 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 ene 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Segunda presentación de la Declaración de confirmación fechada el 25 ene 2017 | 7 páginas | RP04CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 40 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Sharon Harris como secretario el 05 jul 2022 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Nicole Ann Geoghegan como secretario el 05 jul 2022 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Martin David Hunter como director el 18 mar 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 ene 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 39 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 ene 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Ms Helen Margaret Willis como director el 30 nov 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Anthony Oliver Bickerstaff como director el 30 nov 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de COSTAIN ENGINEERING & CONSTRUCTION LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEOGHEGAN, Nicole Ann | Secretario | 70 St Mary Axe EC3A 8BE London Seventh Floor United Kingdom | 298045520001 | |||||||
| DUFFY, Catherine | Director | 70 St Mary Axe EC3A 8BE London Seventh Floor United Kingdom | England | British | 188109790003 | |||||
| MORRIS, Paul Anthony | Director | 70 St Mary Axe EC3A 8BE London Seventh Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 325257280001 | |||||
| WILLIS, Helen Margaret | Director | 70 St Mary Axe EC3A 8BE London Seventh Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 277089380002 | |||||
| FRANKS, Clive Leonard | Secretario | Vanwall Business Park SL6 4UB Maidenhead Costain House Berkshire United Kingdom | British | 58221950001 | ||||||
| HARRIS, Sharon | Secretario | Vanwall Business Park SL6 4UB Maidenhead Costain House Berkshire | 273971010001 | |||||||
| RACE, Brian William | Secretario | 53 Clarendon Way BR7 6RG Chislehurst Kent | British | 1308240001 | ||||||
| SEYMOUR, Charmaine Alex | Secretario | Vanwall Business Park SL6 4UB Maidenhead Costain House Berkshire United Kingdom | British | 115685770001 | ||||||
| STARKEY, Paul Michael | Secretario | Vanwall Business Park SL6 4UB Maidenhead Costain House Berkshire | 171790980001 | |||||||
| WOOD, Tracey Alison | Secretario | Vanwall Business Park SL6 4UB Maidenhead Costain House Berkshire United Kingdom | British | 160820810001 | ||||||
| ADAMS, Peter Richard | Director | Sawrey Cottage Horsham Road RH5 4EH Mid Holmwood Surrey | United Kingdom | British | 127139890001 | |||||
| ARMITT, John Alexander | Director | The Manor House The Lee HP16 9NA Great Missenden Buckinghamshire | British | 52433440003 | ||||||
| ATKINSON, Stewart Martin | Director | Springwell 32 Bondend Road Upton St Leonards GL4 8DY Gloucester Gloucestershire | England | British | 100469640001 | |||||
| BEVAN, John David | Director | Long Meadow The Square Laleston CF32 0HT Bridgend Mid Glamorgan | Wales | British | 41075020003 | |||||
| BICKERSTAFF, Anthony Oliver | Director | Vanwall Business Park SL6 4UB Maidenhead Costain House Berkshire | England | British | 192694490001 | |||||
| BRUCE, Robert Kenneth James | Director | 49 Watchetts Drive GU15 2PQ Camberley Surrey | United Kingdom | British | 48066880001 | |||||
| CAMPBELL, John Richmond | Director | 2 Sutton Avenue SL3 7AW Slough Berkshire | British | 5137910001 | ||||||
| CHARLES, Colin Scott | Director | Pinewood 51 Oldfield Drive Heswall L60 6SS Wirral Merseyside | British | 6812300001 | ||||||
| CLARK, Ian Robertson | Director | 16 Pans Gardens GU15 1HY Camberley Surrey | British | 866920001 | ||||||
| DOUGHTY, Stuart John | Director | Bradley Farm House Kinlet DY12 3BU Bewdley Worcestershire | United Kingdom | British | 31394540001 | |||||
| GERRETSEN, Wolbert | Director | Stones Throw Pennypot Lane Chobham GU24 8DL Woking Surrey | Dutch | 44950250001 | ||||||
| HANDFORD, Alistair John | Director | Vanwall Business Park SL6 4UB Maidenhead Costain House Berkshire | United Kingdom | British | 58215600004 | |||||
| HUNTER, Martin David | Director | Vanwall Business Park SL6 4UB Maidenhead Costain House Berkshire | England | British | 5173500001 | |||||
| JONES, Roger Martyn | Director | 44 Park St Lane Park Street AL2 2JB St Albans Hertfordshire | British | 35757640001 | ||||||
| LEE, Stephen Warwick | Director | 6 Chapel Garth DL7 0QF Northallerton North Yorkshire | British | 84186060001 | ||||||
| LOVELL, Alan Charles | Director | The Palace House Bishops Lane SO32 1DP Bishops Waltham Hampshire | England | British | 149625410001 | |||||
| MAY, George Victor | Director | 23 Chessfield Park HP6 6RU Amersham Buckinghamshire | United Kingdom | British | 85090360001 | |||||
| MCCOLE, Charles Joseph | Director | Chimneys 9 Woodcote Place SL5 7JT Ascot Berkshire | England | British | 44623810003 | |||||
| MINASSIAN, Michael Minas | Director | 17 Grange Gardens Farnham Common SL2 3HL Slough Berkshire | British | 48631390001 | ||||||
| O'REILLY, Cormac John Jerome Conway | Director | Baileys Barn Laurel Farm NR11 8RB Gresham Norfolk | Irish | 12170140001 | ||||||
| QUIRKE, Michael John | Director | The Lodge The Hayes Leek Wootton CV35 7QU Warwick Warwickshire | British | 4772200002 | ||||||
| ROBERTS, Miles William | Director | 2 Grafton Place SG11 1LT Standon Hertfordshire | British | 57880630002 | ||||||
| SIVEY, Graham Paul | Director | 23 Amersham Road HP13 6QS High Wycombe Buckinghamshire | United Kingdom | British | 40935890001 | |||||
| SMETHURST, Ronald | Director | Hunters Moon Ballfield Road GU7 2HA Godalming Surrey | British | 5137930001 | ||||||
| SPERRY, William | Director | 16 Epple Road Fulham SW6 4DH London | British | 4772230002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de COSTAIN ENGINEERING & CONSTRUCTION LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costain Group Plc | 06 abr 2016 | 70 St Mary Axe EC3A 8BE London Seventh Floor United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0