HANSON QUARRY PRODUCTS VENTURES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | HANSON QUARRY PRODUCTS VENTURES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02448835 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de HANSON QUARRY PRODUCTS VENTURES LIMITED?
- Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra HANSON QUARRY PRODUCTS VENTURES LIMITED?
| Dirección de la sede social | Second Floor, Arena Court Crown Lane SL6 8QZ Maidenhead Berkshire England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HANSON QUARRY PRODUCTS VENTURES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| HANSON - ARC VENTURES LIMITED | 04 dic 1989 | 04 dic 1989 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de HANSON QUARRY PRODUCTS VENTURES LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2024 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2025 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para HANSON QUARRY PRODUCTS VENTURES LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 01 jun 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 15 jun 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 01 jun 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para HANSON QUARRY PRODUCTS VENTURES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2025 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 23 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Simon Lloyd Willis como director el 08 ene 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 23 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Modification des détails de Hanson Building Materials Europe Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 abr 2023 | 2 páginas | PSC05 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Hanson House 14 Castle Hill Maidenhead SL6 4JJ a Second Floor, Arena Court Crown Lane Maidenhead Berkshire SL6 8QZ el 03 abr 2023 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 24 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Carsten Matthias Wendt como director el 26 oct 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Alfredo Quilez Somolinos como director el 26 oct 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 22 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Dr Carsten Matthias Wendt el 01 jul 2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2019 | 24 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2020 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 25 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2019 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 23 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 22 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2017 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Dr Carsten Matthias Wendt como director el 01 dic 2016 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de David Jonathan Clarke como director el 01 dic 2016 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de HANSON QUARRY PRODUCTS VENTURES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROGERS, Wendy Fiona | Secretario | Crown Lane SL6 8QZ Maidenhead Second Floor, Arena Court Berkshire England | 206062070001 | |||||||
| BENNING-PRINCE, Nicholas Arthur Dawe, Mr. | Director | Crown Lane SL6 8QZ Maidenhead Second Floor, Arena Court Berkshire England | England | British | 182670630001 | |||||
| DOWLEY, Robert Charles | Director | Crown Lane SL6 8QZ Maidenhead Second Floor, Arena Court Berkshire England | England | British | 183842720001 | |||||
| GRETTON, Edward Alexander | Director | Crown Lane SL6 8QZ Maidenhead Second Floor, Arena Court Berkshire England | England | British | 130888540002 | |||||
| QUILEZ SOMOLINOS, Alfredo | Director | Crown Lane SL6 8QZ Maidenhead Second Floor, Arena Court Berkshire England | England | Spanish | 287317590001 | |||||
| WILLIS, Simon Lloyd | Director | Crown Lane SL6 8QZ Maidenhead Second Floor, Arena Court Berkshire England | England | British | 318051160001 | |||||
| DOUGAL, Andrew James Harrower | Secretario | 10 Westerdale Drive Frimley GU16 5RB Camberley Surrey | British | 42737230001 | ||||||
| DRANSFIELD, Graham | Secretario | Downs Hill BR3 5HB Beckenham 18 Kent | British | 4655640001 | ||||||
| FERNLEY, Simon Roger | Secretario | The Coach House Manor Drive Bathford BA1 7TY Bath | British | 33922880002 | ||||||
| PETERS, Ian Alan Duncan | Secretario | Rectory Stables Gay Street BA11 3PT Mells Somerset | British | 154498310001 | ||||||
| TUNNACLIFFE, Paul Derek | Secretario | 6 Ashburnham Park KT10 9TW Esher Surrey | British | 127202460001 | ||||||
| TYLER, Ian Paul | Secretario | Lime Tree House 3b Village Road, Cockayne Hatley SG19 2EE Sandy Bedfordshire | British | 66794160001 | ||||||
| TYSON, Roger Thomas Virley | Secretario | 14 Castle Hill SL6 4JJ Maidenhead Hanson House | British | 113777700001 | ||||||
| VARCOE, Richard Antony Bruce, Dr | Secretario | 105 Thingwall Park Fishponds BS16 2AR Bristol | British | 55610930001 | ||||||
| VIVIAN, Simon Neil | Secretario | Pond Farm Cottage Faulkland BA3 5YG Bath Somerset | British | 97479630001 | ||||||
| ASPINALL, David Charles | Director | Shingle Quay Manor Court, Hamble SO31 4GB Southampton Hampshire | British | 74352290001 | ||||||
| BOLTER, Andrew Christopher | Director | 110 North View Road Crouch End N8 7LP London | British | 90294620001 | ||||||
| CLARKE, David Jonathan | Director | 14 Castle Hill SL6 4JJ Maidenhead Hanson House Berkshire England | England | British | 160732500001 | |||||
| COTTON, Anthony Ross | Director | Apartment 2403 The York 5 York Street Sydney Nsw 2000 Australia | British | 809750001 | ||||||
| COULSON, Ruth | Director | Flat 4 14 Steeles Road NW3 4SE London | Australian | 109716390001 | ||||||
| DENNETT, Barry | Director | Cotes 1a Coldeast Way, Sarisbury Green SO31 7AT Southampton Hampshire | British | 55396760003 | ||||||
| DOUGAL, Andrew James Harrower | Director | 10 Westerdale Drive Frimley GU16 5RB Camberley Surrey | British | 42737230001 | ||||||
| DRANSFIELD, Graham | Director | Downs Hill BR3 5HB Beckenham 18 Kent | England | British | 4655640001 | |||||
| EGAN, David John | Director | Valley Road WD3 4BJ Rickmansworth 70 Hertfordshire | United Kingdom | British | 324778100001 | |||||
| FERNLEY, Simon Roger | Director | The Coach House Manor Drive Bathford BA1 7TY Bath | England | British | 33922880002 | |||||
| GIMMLER, Richard Robert | Director | Church Walk Ashton Keynes SN6 6PB Swindon Glebe House Wiltshire | England | British | 131676390004 | |||||
| GUYATT, Benjamin John | Director | 14 Castle Hill SL6 4JJ Maidenhead Hanson House | United Kingdom | British | 131516210001 | |||||
| LECLERCQ, Christian | Director | Court Drive SL6 8LX Maidenhead 2 Berkshire United Kingdom | England | Belgian | 130757120001 | |||||
| MCARDLE, Gary Charles | Director | 11a Grasmere Avenue AL5 5PT Harpenden Hertfordshire | British | 99776540001 | ||||||
| MEINS, John Charles | Director | 31 Butler's Court Road HP9 1SQ Beaconsfield Buckinghamshire | England | British | 59558870001 | |||||
| MENZIES-GOW, Robert Ian | Director | Ashwell Cottage Church Close Ashwell LE15 7LP Oakham Leicestershire | United Kingdom | British | 75693480001 | |||||
| PETERS, Ian Alan Duncan | Director | Rectory Stables Gay Street BA11 3PT Mells Somerset | England | British | 154498310001 | |||||
| PHILLIPS, Marilyn Jane | Director | 151 Chalvington Road Chandlers Ford SO53 3EL Eastleigh Hampshire | British | 34427090004 | ||||||
| PIRINCCIOGLU, Seyda | Director | 14 Castle Hill SL6 4JJ Maidenhead Hanson House | England | Turkish | 152863060001 | |||||
| RUSSELL, Simon John | Director | Hill Croft Hartley Road TN17 3QP Cranbrook Kent | British | 6470680001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de HANSON QUARRY PRODUCTS VENTURES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanson Building Materials Europe Limited | 06 abr 2016 | Crown Lane SL6 8QZ Maidenhead Second Floor, Arena Court Berkshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0