LSUK 2009 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaLSUK 2009 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02456232
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de LSUK 2009 LIMITED?

    • (5156) /
    • (5190) /

    ¿Dónde se encuentra LSUK 2009 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LSUK 2009 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    LITHO SUPPLIES (UK) LIMITED19 oct 199319 oct 1993
    LITHO SUPPLIES LIMITED05 feb 199105 feb 1991
    DRG LITHO SUPPLIES LIMITED26 ene 199026 ene 1990
    TESTRICH LIMITED29 dic 198929 dic 1989

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de LSUK 2009 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2008

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para LSUK 2009 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    14 páginas4.72

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 25 ago 2011

    19 páginas4.68

    Aviso de cambio de la administración a la liquidación voluntaria de acreedores

    24 páginas2.34B

    Informe de progreso del administrador hasta 21 jun 2010

    24 páginas2.24B

    Domicilio social registrado cambiado de 43-45 Portman Square London W1H 6LY el 28 jun 2010

    2 páginasAD01

    Resultado de la reunión de acreedores

    3 páginas2.23B

    Declaración de asuntos con el formulario 2.14B

    9 páginas2.16B

    Declaración de la propuesta del administrador

    81 páginas2.17B

    Declaración de la propuesta del administrador

    81 páginas2.17B

    Cese del nombramiento de Simon Wellings como secretario

    2 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Simon Wellings como director

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Edward Williams como director

    2 páginasTM01

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 30 dic 2009

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    Domicilio social registrado cambiado de Litho Supplies Longmoor Lane Breaston Derby Derbyshire DE72 3BQ Uk el 13 ene 2010

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un administrador

    3 páginas2.12B

    Nombramiento de un administrador

    1 páginas2.12B

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Facility agreement 03/12/2009
    RES13
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01

    legacy

    14 páginasMG01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2008

    38 páginasAA

    legacy

    3 páginas395

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    1 páginas288a

    ¿Quiénes son los directivos de LSUK 2009 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HAMMOND, Michael John
    Cover Point 195 Attenborough Lane
    Attenborough
    NG9 6AB Nottingham
    Director
    Cover Point 195 Attenborough Lane
    Attenborough
    NG9 6AB Nottingham
    EnglandBritish49566080001
    MITCHELL, John Gerald
    13 Old Sneed Road
    Stoke Bishop
    BS9 1ES Bristol
    Secretario
    13 Old Sneed Road
    Stoke Bishop
    BS9 1ES Bristol
    British48246470002
    RAMCHANDANI, Gulab Nanikram
    4 Off The Scop
    Lower Almondsbury
    BS12 4DU Bristol
    Secretario
    4 Off The Scop
    Lower Almondsbury
    BS12 4DU Bristol
    British15144500001
    WELLINGS, Simon James
    91 Holbrook Road
    Alvaston
    DE24 0LX Derby
    Derbyshire
    Secretario
    91 Holbrook Road
    Alvaston
    DE24 0LX Derby
    Derbyshire
    British76667130001
    BYFORD, John Peter
    The Orchard Hilfield Lane South
    WD23 4EL Bushey Heath
    Hertfordshire
    Director
    The Orchard Hilfield Lane South
    WD23 4EL Bushey Heath
    Hertfordshire
    British17458340001
    COOPER, Terence Francis Charles
    34 Castle Road
    BS21 7DE Clevedon
    Avon
    Director
    34 Castle Road
    BS21 7DE Clevedon
    Avon
    EnglandBritish102793570001
    MITCHELL, John Gerald
    13 Old Sneed Road
    Stoke Bishop
    BS9 1ES Bristol
    Director
    13 Old Sneed Road
    Stoke Bishop
    BS9 1ES Bristol
    EnglandBritish48246470002
    MULVANEY, Gerald Owen
    17 Mapperley Hall Drive
    Mapperley Park
    NG3 5EP Nottingham
    Director
    17 Mapperley Hall Drive
    Mapperley Park
    NG3 5EP Nottingham
    United KingdomBritish36169070001
    RAMCHANDANI, Gulab Nanikram
    4 Off The Scop
    Lower Almondsbury
    BS12 4DU Bristol
    Director
    4 Off The Scop
    Lower Almondsbury
    BS12 4DU Bristol
    British15144500001
    STOCKTON, James Wardlaw
    4 Oswald Walk
    Milngavie
    G62 6AY Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    4 Oswald Walk
    Milngavie
    G62 6AY Glasgow
    Lanarkshire
    British1381020001
    WELLINGS, Simon James
    91 Holbrook Road
    Alvaston
    DE24 0LX Derby
    Derbyshire
    Director
    91 Holbrook Road
    Alvaston
    DE24 0LX Derby
    Derbyshire
    EnglandBritish76667130001
    WILLIAMS, Edward Gordon
    Amberley 129 Nottingham Road
    Ravenshead
    NG15 9HJ Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    Amberley 129 Nottingham Road
    Ravenshead
    NG15 9HJ Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish100565740001

    ¿Tiene LSUK 2009 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee & debenture
    Creado el 07 dic 2009
    Entregado el 17 dic 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Db Invoice Finance 12 Limited
    Transacciones
    • 17 dic 2009Registro de un cargo (MG01)
    All asset debenture
    Creado el 30 abr 2009
    Entregado el 12 may 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Eurofactor (UK) Limited
    Transacciones
    • 12 may 2009Registro de un cargo (395)
    Guarantee and collateral debenture
    Creado el 14 ene 1991
    Entregado el 24 ene 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from h s holdings limited to the chargee under the terms of the mezzanine loan agreement dated 14/1/91.
    Breve descripción
    All property as described in schedule, the goodwill and uncalled capital bookdebts, see form 395 (ref 436) and schedule for full details.
    Personas con derecho
    • 3I Group Plcers as Definedfor Itself and as Agent and Trustee for the Lend
    Transacciones
    • 24 ene 1991Registro de una carga
    • 05 nov 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 14 ene 1991
    Entregado el 17 ene 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Unit 4 avon trading estate albert road st philips bristol avon T.no av 168492.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 17 ene 1991Registro de una carga
    • 13 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 14 ene 1991
    Entregado el 17 ene 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land and premises at dale street bilston wolverhampton west midlands t/no sf 103559, wm 164694 and sf 112396.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 17 ene 1991Registro de una carga
    • 05 nov 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Letter of offset
    Creado el 14 ene 1991
    Entregado el 17 ene 1991
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or l s holdings limited to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    Any sums now or hereafter standing to the credit of any account or accounts in the name of the company.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 17 ene 1991Registro de una carga
    Debenture
    Creado el 14 ene 1991
    Entregado el 17 ene 1991
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 17 ene 1991Registro de una carga
    • 05 nov 1997Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 13 jun 2007Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)

    ¿Tiene LSUK 2009 LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    22 dic 2009Inicio de la administración
    26 ago 2010Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Phillip Francis Duffy
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Profesional
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Andrew Gordon Stoneman
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Profesional
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    2
    FechaTipo
    26 ago 2010Inicio de la liquidación
    22 ago 2012Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Phillip Francis Duffy
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Profesional
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Andrew Gordon Stoneman
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Profesional
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0