BTG MANAGEMENT SERVICES LIMITED

BTG MANAGEMENT SERVICES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBTG MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02459087
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BTG MANAGEMENT SERVICES LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra BTG MANAGEMENT SERVICES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Chapman House
    Farnham Business Park
    GU9 8QL Farnham
    Surrey
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BTG MANAGEMENT SERVICES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PROTHERICS LIMITED04 dic 200804 dic 2008
    PROTHERICS PLC14 sept 199914 sept 1999
    PROTEUS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY18 abr 199018 abr 1990
    POWERFIRST PUBLIC LIMITED COMPANY12 ene 199012 ene 1990

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BTG MANAGEMENT SERVICES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2021

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BTG MANAGEMENT SERVICES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Notification de Btg Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 dic 2023

    2 páginasPSC02

    Cessation de Btg International (Holdings) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 dic 2023

    1 páginasPSC07

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada 280 Bishopsgate London EC2M 4RB

    1 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a 280 Bishopsgate London EC2M 4RB

    1 páginasAD02

    Domicilio social registrado cambiado de 100 New Bridge Street London EC4V 6JA a Chapman House Farnham Business Park Farnham Surrey GU9 8QL el 26 sept 2023

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 12 ene 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021

    24 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 12 ene 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020

    29 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 12 ene 2021 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019

    29 páginasAA

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 31 dic 2020

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Cancel share prem a/c 21/12/2020
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cese del nombramiento de Elaine Maureen Johnston como director el 28 feb 2020

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Timothy John Martel como director el 28 feb 2020

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Elaine Maureen Johnston como secretario el 28 feb 2020

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Jonathan Richard Monson como director el 28 feb 2020

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Vance Ronald Brown como secretario el 28 feb 2020

    2 páginasAP03

    Nombramiento de Vance Ronald Brown como director el 28 feb 2020

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de BTG MANAGEMENT SERVICES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BROWN, Vance Ronald
    Boston Scientific Way
    Marlborough
    300
    Ma 01752
    United States
    Secretario
    Boston Scientific Way
    Marlborough
    300
    Ma 01752
    United States
    267690890001
    ABOGADO NOMINEES LIMITED
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro1688036
    73539350001
    BROWN, Vance Ronald
    Boston Scientific Way
    Marlborough
    300
    Ma 01752
    United States
    Director
    Boston Scientific Way
    Marlborough
    300
    Ma 01752
    United States
    United StatesCanadian188829030001
    MONSON, Jonathan Richard
    Boston Scientific Way
    Marlborough
    300
    Ma 01752
    United States
    Director
    Boston Scientific Way
    Marlborough
    300
    Ma 01752
    United States
    United StatesAmerican263413340001
    DENSEM, Robert Gordon
    Old Hall Cottage
    Birtles
    SK10 4RS Macclesfield
    Cheshire
    Secretario
    Old Hall Cottage
    Birtles
    SK10 4RS Macclesfield
    Cheshire
    British2043980001
    JOHNSTON, Elaine Maureen
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    Secretario
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    254567130001
    JONES, Lygia Jane
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    Secretario
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    251229130001
    JONES, Lygia Jane
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    United Kingdom
    Secretario
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    United Kingdom
    166927260001
    MADDOX, Peter Geoffrey
    c/o C/O Btg Plc
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    United Kingdom
    Secretario
    c/o C/O Btg Plc
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    United Kingdom
    British53027030001
    MORRIS, David Charles
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    Secretario
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    216145290001
    RILEY, Barrington Marshall
    Cherry Tree House 35 Oldfield Way
    Heswall
    CH60 6RH Wirral
    Merseyside
    Secretario
    Cherry Tree House 35 Oldfield Way
    Heswall
    CH60 6RH Wirral
    Merseyside
    British17825510001
    VICKERS, Julie Alison
    57 White Park Close
    CW10 9GB Middlewich
    Cheshire
    Secretario
    57 White Park Close
    CW10 9GB Middlewich
    Cheshire
    British71031050003
    ANGGARD, Erik, Professor
    Penns
    Marsh Baldon
    OX44 9LS Oxford
    Director
    Penns
    Marsh Baldon
    OX44 9LS Oxford
    EnglandSwedish52176030001
    ATKINSON, Anthony, Professor
    The Apartments
    The Portway, Winterbourne Gunner
    SP4 6JL Salisbury
    Wiltshire
    Director
    The Apartments
    The Portway, Winterbourne Gunner
    SP4 6JL Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish33012570004
    BOYES, Robert Nichol, Dr
    6 Lancaster Road
    AL1 4ET St Albans
    Hertfordshire
    Director
    6 Lancaster Road
    AL1 4ET St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomCanadian378140001
    BROWN, John Robert, Dr
    C/O Bio Industry Association
    14-15 Belgrave Square
    SW1X 8PS London
    Director
    C/O Bio Industry Association
    14-15 Belgrave Square
    SW1X 8PS London
    United KingdomBritish43185450003
    BROWN, Martin
    6231 Hillsboro Road
    Nashville 37215
    Tennessee Usa
    Director
    6231 Hillsboro Road
    Nashville 37215
    Tennessee Usa
    Usa66554420001
    CHARD, Timothy
    171 Lauderdale Tower
    Barbican
    EC2Y 8BY London
    Director
    171 Lauderdale Tower
    Barbican
    EC2Y 8BY London
    English24354460002
    CHRISTIE, James Campbell
    6 Dene Way
    Speldhurst
    TN3 0NX Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    6 Dene Way
    Speldhurst
    TN3 0NX Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritish63090380001
    COTTERILL, Rodney Michael John
    Vibevangen 9
    Farum
    Dk-3520
    Denmark
    Director
    Vibevangen 9
    Farum
    Dk-3520
    Denmark
    Danish33110440001
    EVERITT, James Edmund
    Mayflower Lodge
    Roundstone Lane
    BN16 4AY Angmering
    West Sussex
    Director
    Mayflower Lodge
    Roundstone Lane
    BN16 4AY Angmering
    West Sussex
    United KingdomBritish37177220002
    FOTHERGILL, Geoffrey Peter
    Three Oaks
    The Ridgeway
    LE7 7LE Rothley
    Leicestershire
    Director
    Three Oaks
    The Ridgeway
    LE7 7LE Rothley
    Leicestershire
    British33618550001
    GATENBY, Michael Richard Brock
    11 Norland Square
    W11 4PX London
    Director
    11 Norland Square
    W11 4PX London
    EnglandBritish5246280001
    GILMORE, Kevin Michael
    Knavenhill House
    CV37 8PQ Alderminster
    Warwickshire
    Director
    Knavenhill House
    CV37 8PQ Alderminster
    Warwickshire
    British6161870001
    GONELLA, Jacques, Dr
    Dm2 Al Sahab - Unit 4002
    P.O.Box 211230
    Dubai Marina
    Uae
    Director
    Dm2 Al Sahab - Unit 4002
    P.O.Box 211230
    Dubai Marina
    Uae
    Swiss118826070001
    GRATION, David Whitnall
    Maple Corner Maple Lane
    Upper Basildon
    RG8 8PF Reading
    Berkshire
    Director
    Maple Corner Maple Lane
    Upper Basildon
    RG8 8PF Reading
    Berkshire
    British14238460001
    HEATH, Andrew John William, Dr
    Flat 2
    24 Sloane Gardens
    SW1W 8DJ London
    Director
    Flat 2
    24 Sloane Gardens
    SW1W 8DJ London
    United KingdomBritish66554500005
    JOHNSTON, Elaine Maureen
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    Director
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    United KingdomIrish241923740002
    JONES, Stephen Jeffrey
    48 Carlisle Avenue
    AL3 5LX St Albans
    Hertfordshire
    Director
    48 Carlisle Avenue
    AL3 5LX St Albans
    Hertfordshire
    British42966210001
    KELLEY, Peter Hudson Spence
    27 Dean Street
    Brewood
    ST19 9BU Stafford
    Staffordshire
    Director
    27 Dean Street
    Brewood
    ST19 9BU Stafford
    Staffordshire
    British66781200001
    KOMISAR, Saul
    5201 Franklin Pike
    Nashville
    Tn 37220
    Usa
    Director
    5201 Franklin Pike
    Nashville
    Tn 37220
    Usa
    American121534710001
    LEES, James Cooper
    Hillfield 4 Wentworth Road
    B74 2SG Sutton Coldfield
    West Midlands
    Director
    Hillfield 4 Wentworth Road
    B74 2SG Sutton Coldfield
    West Midlands
    British2290070001
    MAKIN, Pamela Louise, Dame
    5 Fleet Place
    EC4M 7RD London
    Btg Plc
    Director
    5 Fleet Place
    EC4M 7RD London
    Btg Plc
    EnglandBritish111491920002
    MARTEL, Timothy John
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    Director
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    EnglandBritish241968810001
    MILLER, John Allen, Dr
    18 South View Avenue
    Gawsworth
    SK11 9RZ Macclesfield
    Cheshire
    Director
    18 South View Avenue
    Gawsworth
    SK11 9RZ Macclesfield
    Cheshire
    British47308600003

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de BTG MANAGEMENT SERVICES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Farnham Business Park
    GU9 8QL Farnham
    Chapman House
    Surrey
    United Kingdom
    20 dic 2023
    Farnham Business Park
    GU9 8QL Farnham
    Chapman House
    Surrey
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalLaws Of England
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro02670500
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    United Kingdom
    06 abr 2016
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    United Kingdom
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUnited Kingdom
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro04012726
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene BTG MANAGEMENT SERVICES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 15 dic 2000
    Entregado el 29 dic 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The property known as blaenwaun, ffostrasol, ilanysul, ceredigion t/no: WA952044.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 29 dic 2000Registro de un cargo (395)
    • 27 sept 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 15 dic 2000
    Entregado el 21 dic 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 21 dic 2000Registro de un cargo (395)
    • 24 ene 2014Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    • 26 sept 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 01 may 1996
    Entregado el 14 may 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of legal mortgage all the freehold and (insofar as consent is not required to such mortgage by the landlord under the relevant lease) leasehold property of the company now vested in it whether or not the title thereto is registered at H. M. land regisrty (including trade and tenant's fixtures) on or at any time after the date of the debenture thereon and all plant and machinery annexed thereto for whatever purpose;. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Henry Ansbacher & Co Limited
    Transacciones
    • 14 may 1996Registro de un cargo (395)
    • 05 jun 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0