BTG MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | BTG MANAGEMENT SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02459087 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BTG MANAGEMENT SERVICES LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra BTG MANAGEMENT SERVICES LIMITED?
| Dirección de la sede social | Chapman House Farnham Business Park GU9 8QL Farnham Surrey |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BTG MANAGEMENT SERVICES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| PROTHERICS LIMITED | 04 dic 2008 | 04 dic 2008 |
| PROTHERICS PLC | 14 sept 1999 | 14 sept 1999 |
| PROTEUS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | 18 abr 1990 | 18 abr 1990 |
| POWERFIRST PUBLIC LIMITED COMPANY | 12 ene 1990 | 12 ene 1990 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BTG MANAGEMENT SERVICES LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2021 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BTG MANAGEMENT SERVICES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Notification de Btg Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 dic 2023 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||||||
Cessation de Btg International (Holdings) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 dic 2023 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada 280 Bishopsgate London EC2M 4RB | 1 páginas | AD03 | ||||||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a 280 Bishopsgate London EC2M 4RB | 1 páginas | AD02 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 100 New Bridge Street London EC4V 6JA a Chapman House Farnham Business Park Farnham Surrey GU9 8QL el 26 sept 2023 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 ene 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 24 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 ene 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 29 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 ene 2021 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 29 páginas | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
Estado de capital el 31 dic 2020
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Elaine Maureen Johnston como director el 28 feb 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Timothy John Martel como director el 28 feb 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Elaine Maureen Johnston como secretario el 28 feb 2020 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Nombramiento de Jonathan Richard Monson como director el 28 feb 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Vance Ronald Brown como secretario el 28 feb 2020 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||||||
Nombramiento de Vance Ronald Brown como director el 28 feb 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BTG MANAGEMENT SERVICES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROWN, Vance Ronald | Secretario | Boston Scientific Way Marlborough 300 Ma 01752 United States | 267690890001 | |||||||||||
| ABOGADO NOMINEES LIMITED | Secretario corporativo | New Bridge Street EC4V 6JA London 100 United Kingdom |
| 73539350001 | ||||||||||
| BROWN, Vance Ronald | Director | Boston Scientific Way Marlborough 300 Ma 01752 United States | United States | Canadian | 188829030001 | |||||||||
| MONSON, Jonathan Richard | Director | Boston Scientific Way Marlborough 300 Ma 01752 United States | United States | American | 263413340001 | |||||||||
| DENSEM, Robert Gordon | Secretario | Old Hall Cottage Birtles SK10 4RS Macclesfield Cheshire | British | 2043980001 | ||||||||||
| JOHNSTON, Elaine Maureen | Secretario | New Bridge Street EC4V 6JA London 100 | 254567130001 | |||||||||||
| JONES, Lygia Jane | Secretario | Fleet Place EC4M 7RD London 5 | 251229130001 | |||||||||||
| JONES, Lygia Jane | Secretario | Fleet Place EC4M 7RD London 5 United Kingdom | 166927260001 | |||||||||||
| MADDOX, Peter Geoffrey | Secretario | c/o C/O Btg Plc Fleet Place EC4M 7RD London 5 United Kingdom | British | 53027030001 | ||||||||||
| MORRIS, David Charles | Secretario | Fleet Place EC4M 7RD London 5 | 216145290001 | |||||||||||
| RILEY, Barrington Marshall | Secretario | Cherry Tree House 35 Oldfield Way Heswall CH60 6RH Wirral Merseyside | British | 17825510001 | ||||||||||
| VICKERS, Julie Alison | Secretario | 57 White Park Close CW10 9GB Middlewich Cheshire | British | 71031050003 | ||||||||||
| ANGGARD, Erik, Professor | Director | Penns Marsh Baldon OX44 9LS Oxford | England | Swedish | 52176030001 | |||||||||
| ATKINSON, Anthony, Professor | Director | The Apartments The Portway, Winterbourne Gunner SP4 6JL Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | 33012570004 | |||||||||
| BOYES, Robert Nichol, Dr | Director | 6 Lancaster Road AL1 4ET St Albans Hertfordshire | United Kingdom | Canadian | 378140001 | |||||||||
| BROWN, John Robert, Dr | Director | C/O Bio Industry Association 14-15 Belgrave Square SW1X 8PS London | United Kingdom | British | 43185450003 | |||||||||
| BROWN, Martin | Director | 6231 Hillsboro Road Nashville 37215 Tennessee Usa | Usa | 66554420001 | ||||||||||
| CHARD, Timothy | Director | 171 Lauderdale Tower Barbican EC2Y 8BY London | English | 24354460002 | ||||||||||
| CHRISTIE, James Campbell | Director | 6 Dene Way Speldhurst TN3 0NX Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | 63090380001 | |||||||||
| COTTERILL, Rodney Michael John | Director | Vibevangen 9 Farum Dk-3520 Denmark | Danish | 33110440001 | ||||||||||
| EVERITT, James Edmund | Director | Mayflower Lodge Roundstone Lane BN16 4AY Angmering West Sussex | United Kingdom | British | 37177220002 | |||||||||
| FOTHERGILL, Geoffrey Peter | Director | Three Oaks The Ridgeway LE7 7LE Rothley Leicestershire | British | 33618550001 | ||||||||||
| GATENBY, Michael Richard Brock | Director | 11 Norland Square W11 4PX London | England | British | 5246280001 | |||||||||
| GILMORE, Kevin Michael | Director | Knavenhill House CV37 8PQ Alderminster Warwickshire | British | 6161870001 | ||||||||||
| GONELLA, Jacques, Dr | Director | Dm2 Al Sahab - Unit 4002 P.O.Box 211230 Dubai Marina Uae | Swiss | 118826070001 | ||||||||||
| GRATION, David Whitnall | Director | Maple Corner Maple Lane Upper Basildon RG8 8PF Reading Berkshire | British | 14238460001 | ||||||||||
| HEATH, Andrew John William, Dr | Director | Flat 2 24 Sloane Gardens SW1W 8DJ London | United Kingdom | British | 66554500005 | |||||||||
| JOHNSTON, Elaine Maureen | Director | New Bridge Street EC4V 6JA London 100 | United Kingdom | Irish | 241923740002 | |||||||||
| JONES, Stephen Jeffrey | Director | 48 Carlisle Avenue AL3 5LX St Albans Hertfordshire | British | 42966210001 | ||||||||||
| KELLEY, Peter Hudson Spence | Director | 27 Dean Street Brewood ST19 9BU Stafford Staffordshire | British | 66781200001 | ||||||||||
| KOMISAR, Saul | Director | 5201 Franklin Pike Nashville Tn 37220 Usa | American | 121534710001 | ||||||||||
| LEES, James Cooper | Director | Hillfield 4 Wentworth Road B74 2SG Sutton Coldfield West Midlands | British | 2290070001 | ||||||||||
| MAKIN, Pamela Louise, Dame | Director | 5 Fleet Place EC4M 7RD London Btg Plc | England | British | 111491920002 | |||||||||
| MARTEL, Timothy John | Director | New Bridge Street EC4V 6JA London 100 | England | British | 241968810001 | |||||||||
| MILLER, John Allen, Dr | Director | 18 South View Avenue Gawsworth SK11 9RZ Macclesfield Cheshire | British | 47308600003 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de BTG MANAGEMENT SERVICES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Btg Limited | 20 dic 2023 | Farnham Business Park GU9 8QL Farnham Chapman House Surrey United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Btg International (Holdings) Limited | 06 abr 2016 | New Bridge Street EC4V 6JA London 100 United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene BTG MANAGEMENT SERVICES LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creado el 15 dic 2000 Entregado el 29 dic 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The property known as blaenwaun, ffostrasol, ilanysul, ceredigion t/no: WA952044. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 15 dic 2000 Entregado el 21 dic 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 01 may 1996 Entregado el 14 may 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción By way of legal mortgage all the freehold and (insofar as consent is not required to such mortgage by the landlord under the relevant lease) leasehold property of the company now vested in it whether or not the title thereto is registered at H. M. land regisrty (including trade and tenant's fixtures) on or at any time after the date of the debenture thereon and all plant and machinery annexed thereto for whatever purpose;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0