RIPAULT DRIVEX LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | RIPAULT DRIVEX LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02459539 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de RIPAULT DRIVEX LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra RIPAULT DRIVEX LIMITED?
| Dirección de la sede social | Roke Manor Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Hampshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RIPAULT DRIVEX LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BROOMCO (357) LIMITED | 15 ene 1990 | 15 ene 1990 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de RIPAULT DRIVEX LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 oct 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para RIPAULT DRIVEX LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 ene 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 oct 2017 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael James Flowers como director el 30 jun 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 ene 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 oct 2016 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Andrew Gregory Lewis como director el 19 ene 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 ene 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Sarah Louise Ellard el 03 ene 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Steven John Bowers como director el 30 sept 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 oct 2015 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 ene 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 oct 2014 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Michael James Flowers el 13 mar 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 ene 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del secretario Sarah Louise Ellard el 09 dic 2014 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cambio de datos del director Sarah Louise Ellard el 09 dic 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 oct 2013 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Michael James Flowers como director el 24 jul 2014 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Harry Papworth como director el 24 jul 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de * Roke Manor Old Salisbury Lane Romsey Hampshire SO51 0LZ United Kingdom* el 03 jul 2014 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de * Chemring House 1500 Parkway Whiteley Fareham Hampshire PO15 7AF* el 01 jul 2014 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Steven John Bowers como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de RIPAULT DRIVEX LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELLARD, Sarah Louise | Secretario | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | British | 43855640011 | ||||||
| ELLARD, Sarah Louise | Director | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | England | British | 43855640013 | |||||
| LEWIS, Andrew Gregory | Director | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire | United Kingdom | British | 222848510001 | |||||
| EDGE, Geoffrey | Secretario | Spindlewood Dog Kennel Hill Kiveton Park Station S26 6NG Sheffield South Yorkshire | British | 2055530001 | ||||||
| LEIGHTON, Iain Gordon Kerr | Secretario | 71 Rectory Grove Clapham Common SW4 0DS London | British | 42841660001 | ||||||
| VINE, Sylvia Elizabeth Faith | Secretario | Struan 65 Bell Hill GU32 2EA Petersfield Hampshire | British | 3801050001 | ||||||
| BILLINGTON, Philip Gordon | Director | 25 Carbis Close Port Solent Cosham PO6 4TW Portsmouth Hampshire | British | 18247670001 | ||||||
| BOWERS, Steven John | Director | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 176189250001 | |||||
| CLEARY, Michael John | Director | 22 Main Road Naphill HP14 4QB High Wycombe Buckinghamshire | British | 1525670001 | ||||||
| EDGE, Geoffrey | Director | Spindlewood Dog Kennel Hill Kiveton Park Station S26 6NG Sheffield South Yorkshire | British | 2055530001 | ||||||
| FLOWERS, Michael James | Director | Old Salisbury Lane SO51 0LZ Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | United Kingdom | Australian | 188873370002 | |||||
| GIBBS, Raymond John | Director | Bridge House 7 Uxbridge Close SO31 7LP Sarisbury Soton Hampshire | British | 85421380001 | ||||||
| HINCHCLIFFE, Alan | Director | Manor Cottage Tapton S43 1QQ Chesterfield | England | British | 86931130002 | |||||
| LEIGHTON, Iain Gordon Kerr | Director | 71 Rectory Grove Clapham Common SW4 0DS London | United Kingdom | British | 42841660001 | |||||
| PAPWORTH, Mark Harry | Director | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | England | British | 103085690002 | |||||
| PRICE, David John | Director | 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Chemring House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 75259760004 | |||||
| RAYNER, Paul Adrian | Director | 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Chemring House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 45628680002 | |||||
| VINE, Sylvia Elizabeth Faith | Director | Struan 65 Bell Hill GU32 2EA Petersfield Hampshire | British | 3801050001 | ||||||
| WHITEHORN, Justin Michael | Director | Lower Farm House Upper Milton Milton Under Wychwood OX7 6EX Chipping Norton Oxfordshire | England | British | 42825970001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de RIPAULT DRIVEX LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kembrey Electronics Limited | 30 jun 2016 | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene RIPAULT DRIVEX LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Charge | Creado el 11 oct 1993 Entregado el 13 oct 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 29 sept 1990 Entregado el 09 oct 1990 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Fixed and floating charge | Creado el 13 jun 1990 Entregado el 19 jun 1990 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed charge over all book debts & other debts owing to the company. Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0