ROUGHLY RED LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaROUGHLY RED LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02460533
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ROUGHLY RED LIMITED?

    • (9999) /

    ¿Dónde se encuentra ROUGHLY RED LIMITED?

    Dirección de la sede social
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ROUGHLY RED LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    RACING GREEN LIMITED23 ene 199823 ene 1998
    HEMINGWAY LIMITED22 mar 199022 mar 1990
    HOCKBRIDGE LIMITED17 ene 199017 ene 1990

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ROUGHLY RED LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 ene 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ROUGHLY RED LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    18 páginas4.72

    Restauración por orden judicial

    3 páginasAC92

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    11 páginas4.72

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 04 ene 2012

    15 páginas4.68

    Domicilio social registrado cambiado de * Toronto Square Toronto Street Leeds LS1 2HJ* el 26 may 2011

    2 páginasAD01

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    3 páginasF10.2

    Declaración de asuntos con el formulario adjunto 4.19

    4 páginas4.20

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación

    LRESEX

    Domicilio social registrado cambiado de * Toronto Square Toronto Street Leeds LS1 2HJ* el 19 ene 2011

    2 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de * Granary Building 1 Canal Wharf Leeds West Yorkshire LS11 5BB* el 11 ene 2011

    2 páginasAD01

    Nombramiento de Scott Keith Carpenter como director

    3 páginasAP01

    Nombramiento de Gavin Michael George como secretario

    3 páginasAP03

    Nombramiento de Mr Gavin Michael George como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Richard Paul como secretario

    2 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Baird Group Ltd como director

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Peter Lucas como director

    2 páginasTM01

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 ene 2010

    5 páginasAA

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed racing green LIMITED\certificate issued on 19/10/10
    2 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name19 oct 2010

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 12 oct 2010

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    ¿Quiénes son los directivos de ROUGHLY RED LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GEORGE, Gavin Michael
    Stratton Street
    W1J 8LQ London
    15
    Secretario
    Stratton Street
    W1J 8LQ London
    15
    British156135760001
    CARPENTER, Scott Keith
    Stratton Street
    W1J 8LQ London
    15
    England
    Director
    Stratton Street
    W1J 8LQ London
    15
    England
    United StatesAmerican145987830001
    GEORGE, Gavin Michael
    Stratton Street
    W1J 8LQ London
    15
    Director
    Stratton Street
    W1J 8LQ London
    15
    United KingdomBritish148227120001
    BRICK, Alexander Paul
    12 The Bishops Avenue
    N2 0AN London
    Secretario
    12 The Bishops Avenue
    N2 0AN London
    British122889900001
    CASH, Daphne Valerie
    20 Chichester Mews
    SE27 0NS London
    Secretario
    20 Chichester Mews
    SE27 0NS London
    British59646330004
    COCKIN, Anna Margaret
    16 Manor House Estate
    HA7 4BH Stanmore
    Middlesex
    Secretario
    16 Manor House Estate
    HA7 4BH Stanmore
    Middlesex
    British95030040001
    HIGHT-WARBURTON, Jonathan Howard
    50 Cowper Road
    AL5 5NG Harpenden
    Hertfordshire
    Secretario
    50 Cowper Road
    AL5 5NG Harpenden
    Hertfordshire
    British62797170001
    HODGES, John
    The Old Orchard Burney Road
    Westhumble
    RH5 6AU Dorking
    Surrey
    Secretario
    The Old Orchard Burney Road
    Westhumble
    RH5 6AU Dorking
    Surrey
    British3666240001
    JACKMAN, Ian Peter
    Flat 11 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 5LR London
    Secretario
    Flat 11 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 5LR London
    British71660800001
    JACKMAN, Ian Peter
    Flat 11 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 5LR London
    Secretario
    Flat 11 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 5LR London
    British71660800001
    LIPTON, Richard Geoffrey
    67 Green Lane
    HA8 7PZ Edgware
    Middlesex
    Secretario
    67 Green Lane
    HA8 7PZ Edgware
    Middlesex
    British32995330001
    PAUL, Richard Neil
    21 Almsford Avenue
    HG2 8HD Harrogate
    North Yorkshire
    Secretario
    21 Almsford Avenue
    HG2 8HD Harrogate
    North Yorkshire
    British43099210003
    SPERRY, Ian Nicholas
    8 St. Thomas Place
    Wheathampstead
    AL4 8BG St. Albans
    Hertfordshire
    Secretario
    8 St. Thomas Place
    Wheathampstead
    AL4 8BG St. Albans
    Hertfordshire
    British106924330002
    STEVENSON, Rebecca Jayne
    49 Rivulet Road
    Tottenham
    N17 7JT London
    Secretario
    49 Rivulet Road
    Tottenham
    N17 7JT London
    British71917770002
    ALLAN, Fraser Stuart
    Village Farm Barn
    The Broadway, Charlton On Otmoor
    OX5 2UB Kidlington
    Oxfordshire
    Director
    Village Farm Barn
    The Broadway, Charlton On Otmoor
    OX5 2UB Kidlington
    Oxfordshire
    British64559730001
    BEHARRELL, Russell Clive
    2 The Grange
    Wimbledon
    SW19 4PT London
    Director
    2 The Grange
    Wimbledon
    SW19 4PT London
    EnglandBritish6730570001
    BLOMGREN, Britta Katarina
    31a Ospringe Road
    NW5 2JB London
    Director
    31a Ospringe Road
    NW5 2JB London
    Swedish35948360001
    BRICK, Alexander Paul
    12 The Bishops Avenue
    N2 0AN London
    Director
    12 The Bishops Avenue
    N2 0AN London
    EnglandBritish122889900001
    BRICK, Anthony Allan
    11 Pangbourne Drive
    HA7 4QS Stanmore
    Middlesex
    Director
    11 Pangbourne Drive
    HA7 4QS Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritish34122180001
    BRICK, Brian Denis
    28 Aylmer Drive
    HA7 3EG Stanmore
    Middlesex
    Director
    28 Aylmer Drive
    HA7 3EG Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritish9649690002
    BROWN, David Nigel
    116 Clarence Road
    AL1 4NW St Albans
    Hertfordshire
    Director
    116 Clarence Road
    AL1 4NW St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish40354400003
    BUDGE, Paul Everard
    16 Overland Crescent
    Apperley Bridge
    BD10 9TG Bradford
    Director
    16 Overland Crescent
    Apperley Bridge
    BD10 9TG Bradford
    United KingdomBritish88851520002
    CHALLEN, Philippa Helen
    1 Myrtle House
    Sulgrave Road
    W6 7QG London
    Director
    1 Myrtle House
    Sulgrave Road
    W6 7QG London
    British39567180001
    CHAPPELOW, Peter Raymond
    Settlebeck 109 Curly Hill
    LS29 0DT Ilkley
    West Yorkshire
    Director
    Settlebeck 109 Curly Hill
    LS29 0DT Ilkley
    West Yorkshire
    EnglandBritish71153170002
    CHEESEMAN, Gordon William
    Tawny End
    Earleswood
    KT11 2BZ Cobham
    Surrey
    Director
    Tawny End
    Earleswood
    KT11 2BZ Cobham
    Surrey
    British17467970001
    DUCKELS, Colin Peter
    25 Woodlea Drive
    Meanwood
    LS6 4SQ Leeds
    West Yorkshire
    Director
    25 Woodlea Drive
    Meanwood
    LS6 4SQ Leeds
    West Yorkshire
    British44237310003
    FAY, Janet Anne
    Gable Cottage
    Church Lane Avenue
    CR5 3RT Coulsdon
    Surrey
    Director
    Gable Cottage
    Church Lane Avenue
    CR5 3RT Coulsdon
    Surrey
    British35948290002
    FREEDMAN, Jonathan Sydney
    9 Eastglade
    HA5 3AN Pinner
    Middlesex
    Director
    9 Eastglade
    HA5 3AN Pinner
    Middlesex
    British5232410001
    GIPSON, Stephen
    The Engine House
    2 Leigh Court Barns
    WR6 5LB Leigh
    Worcestershire
    Director
    The Engine House
    2 Leigh Court Barns
    WR6 5LB Leigh
    Worcestershire
    Great BritainBritish98785200001
    GOLDMAN, Adam Alexander
    4 Jenner Way
    Clarendon Park
    KT19 7LJ Epsom
    Surrey
    Director
    4 Jenner Way
    Clarendon Park
    KT19 7LJ Epsom
    Surrey
    EnglandBritish28466260004
    HALLETT, Peter John
    Goldfields Glenhill Farm
    Glendon Road
    NN14 1QE Kettering
    Northamptonshire
    Director
    Goldfields Glenhill Farm
    Glendon Road
    NN14 1QE Kettering
    Northamptonshire
    United KingdomBritish20621770002
    HICK, Paul Arney
    Millcourt Mill Road
    SL7 1QB Marlow
    Buckinghamshire
    Director
    Millcourt Mill Road
    SL7 1QB Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritish47699120005
    HIGGINSON, Andrew Thomas
    Little Wood Wood End
    SL7 2HW Marlow
    Buckinghamshire
    Director
    Little Wood Wood End
    SL7 2HW Marlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish57637410001
    HODGES, John
    The Old Orchard Burney Road
    Westhumble
    RH5 6AU Dorking
    Surrey
    Director
    The Old Orchard Burney Road
    Westhumble
    RH5 6AU Dorking
    Surrey
    British3666240001
    JACKMAN, Ian Peter
    Flat 11 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 5LR London
    Director
    Flat 11 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 5LR London
    British71660800001

    ¿Tiene ROUGHLY RED LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 14 sept 2007
    Entregado el 27 sept 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Gresham LLP (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transacciones
    • 27 sept 2007Registro de un cargo (395)
    • 22 oct 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Supplement deed
    Creado el 25 may 2006
    Entregado el 09 jun 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any group company to the security trustee and/or the other secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties
    Transacciones
    • 09 jun 2006Registro de un cargo (395)
    • 22 oct 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 25 nov 2005
    Entregado el 13 dic 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any group company to the chargee and or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 13 dic 2005Registro de un cargo (395)
    • 22 oct 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 27 feb 1996
    Entregado el 29 feb 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 29 feb 1996Registro de un cargo (395)
    • 05 oct 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 17 ago 1993
    Entregado el 21 ago 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transacciones
    • 21 ago 1993Registro de un cargo (395)
    • 05 oct 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 18 dic 1991
    Entregado el 20 dic 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital plus patents.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 20 dic 1991Registro de un cargo (395)
    • 03 dic 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creado el 08 may 1991
    Entregado el 15 may 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All the tenants obligations under a lease dated 8 may 1991 and under the terms of the charge
    Breve descripción
    £ 18,750 (see 395 for full detail).
    Personas con derecho
    • Colebrook Estates Limited
    Transacciones
    • 15 may 1991Registro de una carga
    • 01 oct 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene ROUGHLY RED LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    11 jul 2017Fecha de disolución
    05 ene 2011Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Stuart Charles Edward Mackellar
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Profesional
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Simon Jonathan Appell
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Profesional
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0