AERON VALLEY HOLDINGS LIMITED

AERON VALLEY HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaAERON VALLEY HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02460547
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de AERON VALLEY HOLDINGS LIMITED?

    • (1551) /

    ¿Dónde se encuentra AERON VALLEY HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    C/O BDO LLP
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS1 5RU Leeds
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de AERON VALLEY HOLDINGS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    DAVID J. ELLIS (1989) LIMITED17 ene 199017 ene 1990

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de AERON VALLEY HOLDINGS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2008

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para AERON VALLEY HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 01 nov 2010

    5 páginas4.68

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    3 páginas4.71

    Domicilio social registrado cambiado de Thames House, Portsmouth Road Esher Surrey KT10 9AD el 14 dic 2009

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 24 nov 2009

    LRESSP

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2008

    14 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas288c

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2007

    10 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    1 páginas287

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2006

    10 páginasAA

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas288a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2005

    10 páginasAA

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas403a

    legacy

    1 páginas288b

    ¿Quiénes son los directivos de AERON VALLEY HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SLC REGISTRARS LIMITED
    Thames House
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Surrey
    Secretario corporativo
    Thames House
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Surrey
    34893920004
    GLOVER, Matthew
    20 Laigh Row
    Port Logan
    DG9 9NG Stranraer
    Dumfries Galloway
    Director
    20 Laigh Row
    Port Logan
    DG9 9NG Stranraer
    Dumfries Galloway
    United KingdomBritish101699160002
    O'LEARY, Kevin Francis
    24 Bellever Hill
    GU15 2HD Camberley
    Surrey
    Director
    24 Bellever Hill
    GU15 2HD Camberley
    Surrey
    United KingdomBritish120490440001
    SMITH, Andrew James
    Quayside
    6 Waters Edge
    ME15 6SG Maidstone
    Kent
    Director
    Quayside
    6 Waters Edge
    ME15 6SG Maidstone
    Kent
    EnglandBritish102736440001
    BESWICK, Paul William
    Evesbatch Court
    Bishops Frome
    WR6 5BD Worcester
    Secretario
    Evesbatch Court
    Bishops Frome
    WR6 5BD Worcester
    British22089870010
    DAVIS, Spencer Michael
    Larkswood
    Eardington
    WV16 5JT Bridgnorth
    Secretario
    Larkswood
    Eardington
    WV16 5JT Bridgnorth
    British79976250001
    IRVINE, Douglas Forbes
    Alloway Cottage
    Doonholm Road
    KA7 4QQ Alloway
    Ayr
    Secretario
    Alloway Cottage
    Doonholm Road
    KA7 4QQ Alloway
    Ayr
    British104622570001
    LOONEY, Eamonn Anthony
    Annagannihy
    IRISH Rylane
    Co Cork
    Secretario
    Annagannihy
    IRISH Rylane
    Co Cork
    British77078290001
    PAUL, Susan Gay
    Top Flat 111 Gate Road
    Penygroes
    SA14 7RN Llanelli
    Carmarthenshire
    Secretario
    Top Flat 111 Gate Road
    Penygroes
    SA14 7RN Llanelli
    Carmarthenshire
    British46894270001
    PHILLIPS, Emyr Maldwyn
    2 Cysgod Y Bryn
    SY23 4LR Aberystwyth
    Secretario
    2 Cysgod Y Bryn
    SY23 4LR Aberystwyth
    British111536480001
    PHILLIPS, Emyr Maldwyn
    2 Cysgod Y Bryn
    SY23 4LR Aberystwyth
    Secretario
    2 Cysgod Y Bryn
    SY23 4LR Aberystwyth
    British111536480001
    POWELL COOK, Neale Alan
    23 Kingswood Grange
    Babylon Lane
    KT20 6UY Lower Kingswood
    Surrey
    Secretario
    23 Kingswood Grange
    Babylon Lane
    KT20 6UY Lower Kingswood
    Surrey
    British102814000002
    REED, Donald Francis
    25 Victoria Avenue
    Canton
    CF5 1ET Cardiff
    South Glamorgan
    Secretario
    25 Victoria Avenue
    Canton
    CF5 1ET Cardiff
    South Glamorgan
    British3333260001
    WILLIAMS, David Anthony James
    87 Bath Road
    WR5 3AE Worcester
    Secretario
    87 Bath Road
    WR5 3AE Worcester
    British57267910001
    BALTESZ, Jonathan Nicolas
    10 Napier Road
    Redland
    BS6 6RT Bristol
    Avon
    Director
    10 Napier Road
    Redland
    BS6 6RT Bristol
    Avon
    EnglandBritish39361490001
    BARRETH, Ray Jack
    42 Millwood
    Lisvane
    CF4 5TL Cardiff
    South Glamorgan
    Director
    42 Millwood
    Lisvane
    CF4 5TL Cardiff
    South Glamorgan
    British3333280001
    BARRETH, Ray Jack
    42 Millwood
    Lisvane
    CF4 5TL Cardiff
    South Glamorgan
    Director
    42 Millwood
    Lisvane
    CF4 5TL Cardiff
    South Glamorgan
    British3333280001
    BESWICK, Paul William
    Evesbatch Court
    Bishops Frome
    WR6 5BD Worcester
    Director
    Evesbatch Court
    Bishops Frome
    WR6 5BD Worcester
    British22089870010
    CRONIN, Denis
    Barrinclay Dromahane
    Mallow
    IRISH Cork
    Ireland
    Director
    Barrinclay Dromahane
    Mallow
    IRISH Cork
    Ireland
    Irish71735140001
    DARE, Andrew Rodney
    Whitegates
    Mathon Road Colwall
    WR13 6ER Malvern
    Worcestershire
    Director
    Whitegates
    Mathon Road Colwall
    WR13 6ER Malvern
    Worcestershire
    EnglandBritish36710550002
    DAVIES, David Edwin
    Fferm Ty Newydd Brynog
    Lampeter
    SA48 8AG Ceredigion
    Dyfed
    Director
    Fferm Ty Newydd Brynog
    Lampeter
    SA48 8AG Ceredigion
    Dyfed
    British44188970001
    DAVIS, Richard John
    Turvey Road
    Carlton
    MK43 7LH Bedford
    Church Farm
    Bedfordshire
    Director
    Turvey Road
    Carlton
    MK43 7LH Bedford
    Church Farm
    Bedfordshire
    United KingdomBritish128975790001
    DOYLE, James Augustus
    2 High Grove
    The Spinney
    SY11 2YF Oswestry
    Shropshire
    Director
    2 High Grove
    The Spinney
    SY11 2YF Oswestry
    Shropshire
    British76240980001
    DOYLE, James Augustus
    2 High Grove
    The Spinney
    SY11 2YF Oswestry
    Shropshire
    Director
    2 High Grove
    The Spinney
    SY11 2YF Oswestry
    Shropshire
    British76240980001
    DUNCAN, John
    Castlehill Farm
    KA19 8JT Maybole
    Ayrshire
    Director
    Castlehill Farm
    KA19 8JT Maybole
    Ayrshire
    British36674290001
    ELLIS, David John, Mr.
    Spring Cottage
    Pen Y Turnpike Road
    CF64 4HG Dinas Powys
    South Glamorgan
    Director
    Spring Cottage
    Pen Y Turnpike Road
    CF64 4HG Dinas Powys
    South Glamorgan
    WalesBritish3333270001
    EVANS, Roger Malcolm
    Brunslow
    SY7 8AD Lydbury North
    Shropshire
    Director
    Brunslow
    SY7 8AD Lydbury North
    Shropshire
    United KingdomBritish76298080001
    FAULKNER, Stephen Paul
    17 Arnprior Place
    Alloway
    KA7 4PT Ayr
    Scotland
    Director
    17 Arnprior Place
    Alloway
    KA7 4PT Ayr
    Scotland
    ScotlandBritish80470330001
    FORMAN, Robert John
    7 Laleston Court
    Laleston
    CF32 0HG Bridgend
    Mid Glamorgan
    Director
    7 Laleston Court
    Laleston
    CF32 0HG Bridgend
    Mid Glamorgan
    British36312060002
    IRVINE, Douglas Forbes
    Alloway Cottage
    Doonholm Road
    KA7 4QQ Alloway
    Ayr
    Director
    Alloway Cottage
    Doonholm Road
    KA7 4QQ Alloway
    Ayr
    British104622570001
    IRVINE, John Alastair
    The Coyle House
    KA6 5JY Sundrum
    Ayr
    Director
    The Coyle House
    KA6 5JY Sundrum
    Ayr
    British104622710001
    JONES, David
    52 Amis Avenue
    New Haw
    KT15 3ET Addlestone
    Surrey
    Director
    52 Amis Avenue
    New Haw
    KT15 3ET Addlestone
    Surrey
    United KingdomBritish67756150001
    LOONEY, Eamonn Anthony
    Annagannihy
    IRISH Rylane
    Co Cork
    Director
    Annagannihy
    IRISH Rylane
    Co Cork
    British77078290001
    LUCEY, Denis
    Woodview
    Knockgriffin
    Middleton
    Cork
    Ireland
    Director
    Woodview
    Knockgriffin
    Middleton
    Cork
    Ireland
    Irish33417540001
    MACFARLANE, Neil
    87 School Lane
    KT15 1TA Addlestone
    Surrey
    Director
    87 School Lane
    KT15 1TA Addlestone
    Surrey
    British26838970001

    ¿Tiene AERON VALLEY HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 22 jul 2005
    Entregado el 30 jul 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 30 jul 2005Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 17 dic 2003
    Entregado el 29 dic 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 29 dic 2003Registro de un cargo (395)
    • 06 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 05 jul 1995
    Entregado el 18 jul 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • David John Ellis
    Transacciones
    • 18 jul 1995Registro de un cargo (395)
    • 13 nov 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene AERON VALLEY HOLDINGS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    2
    FechaTipo
    24 nov 2009Inicio de la liquidación
    17 feb 2011Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    James Bernard Stephen
    Bdo Llp, 4 Atlantic Quay, 70 York Street
    G2 8JX Glasgow
    Profesional
    Bdo Llp, 4 Atlantic Quay, 70 York Street
    G2 8JX Glasgow

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0