SIXCO LEASING LIMITED.
Visión general
| Nombre de la empresa | SIXCO LEASING LIMITED. |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02461016 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SIXCO LEASING LIMITED.?
- Intermediación financiera no clasificada en otra parte (64999) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra SIXCO LEASING LIMITED.?
| Dirección de la sede social | 15 Canada Square E14 5GL London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SIXCO LEASING LIMITED.?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| JHS LEASING (6/98) LIMITED | 08 jul 1997 | 08 jul 1997 |
| SLTM (4) LIMITED | 18 ene 1990 | 18 ene 1990 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SIXCO LEASING LIMITED.?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SIXCO LEASING LIMITED.?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 6 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Kenyon Thomas como director el 30 nov 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Winchester House 1 Great Winchester Street London EC2N 2DB a 15 Canada Square London E14 5GL el 23 oct 2018 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2018 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Notification de Db Uk Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 may 2017 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 11 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 11 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 ene 2016 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Adam Paul Rutherford como secretario el 14 ago 2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 ene 2015 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Chris Snailham como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Misceláneos Section 519 | 3 páginas | MISC | ||||||||||
Misceláneos S.519 companies act 2006 | 2 páginas | MISC | ||||||||||
Misceláneos Section 519 | 2 páginas | MISC | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 ene 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Mr David Kenyon Thomas el 24 feb 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012 | 11 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de SIXCO LEASING LIMITED.?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGSHAW, Joanne Louise | Secretario | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House United Kingdom | 180380490001 | |||||||
| BARTLETT, Andrew William | Secretario | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House | British | 73852930003 | ||||||
| SNAILHAM, Christopher Charles | Director | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House United Kingdom | United Kingdom | British | 202149290001 | |||||
| BRITTON, Ralph Thomas | Secretario | 22 Manor Park Drive HA2 6HS Harrow Middlesex | British | 4558060001 | ||||||
| BURTON, Jennifer Sandra | Secretario | 39b Butler Avenue HA1 4EJ West Harrow Middlesex | British | 100622570001 | ||||||
| FLETCHER, Edward Michael | Secretario | 3 Aldrich Terrace SW18 3PU Earlsfield | British | 78572640002 | ||||||
| JOHNSON, Ian | Secretario | 2 Wheatsheaf Close GU21 4BP Woking Surrey | British | 114245990001 | ||||||
| RUTHERFORD, Adam Paul | Secretario | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House | British | 70451850004 | ||||||
| ADDISON, Jeffrey Patrick | Director | 1 Garden Close Halton Village HP22 5PE Aylesbury Buckinghamshire | British | 4558090001 | ||||||
| AUSTIN, Clive Alan | Director | 33 Heathfield Road GU31 4DG Petersfield Hampshire | British | 86696710001 | ||||||
| COOPER, Susan Elizabeth | Director | 27 Park Lane Kemsing TN15 6NX Sevenoaks Kent | British | 75014460001 | ||||||
| GOLDSBROUGH, Christopher Andrew John | Director | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House United Kingdom | United Kingdom | British/New Zealand | 153832500002 | |||||
| HENBREY, Eric John | Director | 40 Corringway Ealing W5 3AA London | British | 42827500001 | ||||||
| HOYLE, Stephen Lewis | Director | 2 Haslemere Road N8 9QX London | United Kingdom | British | 96838010001 | |||||
| JAQUES, Peter Charles | Director | 12 Broadfield Way IG9 5AG Buckhurst Hill Essex | British | 41695880001 | ||||||
| JONES, Brian Martin | Director | 7 Acacia Road TW12 3DP Hampton Middlesex | England | British | 33070880002 | |||||
| KINSELLA, John Desmond | Director | 7 Winthorpe Road SW15 2LW London | British | 46966940001 | ||||||
| LAWSON, Peter Bryan | Director | 19 Woodlands Road WD2 2LS Bushey Hertfordshire | England | British | 4558100001 | |||||
| MACFARLANE, Stuart Edward | Director | 6 Lynmouth Road East Finchley N2 9LS London | Australian | 125721120002 | ||||||
| MACKIE, William Graham | Director | 106 Abbeville Road SW4 9LU London | British | 44120490001 | ||||||
| MCGIDDY, Mark Andrew | Director | Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House 1 | Australian | 114990900003 | ||||||
| PRESS, Matthew | Director | 106 Ledbury Road W11 2AH London | Australian | 104610910001 | ||||||
| ROCK, John William | Director | Squires Cottage 5 Front Road TN26 3QF Woodchurch Kent | British | 35071080001 | ||||||
| SHAH, Rumit | Director | 32 The Drive HA6 1HP Northwood Middlesex | England | British | 101964890001 | |||||
| SIVANITHY, Rajanbabu | Director | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House | United Kingdom | British | 63268810003 | |||||
| SYKES, Andrew Francis | Director | 7 Oakhill Road SW15 2QJ London | England | British | 26855270003 | |||||
| TEMPLEMAN, Michael | Director | St Leonards House 9 Priory Close MK43 8BG Turvey Bedfordshire | England | British | 37433420002 | |||||
| THOMAS, David Kenyon | Director | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House England England | United Kingdom | British | 59397060006 | |||||
| THOMPSON, Peter Gordon | Director | 8 Wagtail Walk Langley Park BR3 3XG Beckenham Kent | British | 61570160003 | ||||||
| VASUDEVA, Nicholas Shashi | Director | 57 Linden Gardens W2 4HJ London Flat 1 | British/Australian | 79508880002 | ||||||
| WILSON, Michael Joseph Patrick | Director | Chapel Hill Cretingham IP13 7DN Woodbridge Shrubbery Farm Suffolk United Kingdom | Irish | 136929170001 | ||||||
| WORTHY, Judith Margaret Ann | Director | 16 Newton Mansions Queens Club Gardens W14 9RR London | England | British | 73975400001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SIXCO LEASING LIMITED.?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Db Uk Holdings Limited | 10 may 2017 | Great Winchester Street EC2P 2AX London 23 London United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Kradavimd Uk Lease Holdings Limited | 06 abr 2016 | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene SIXCO LEASING LIMITED. alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| An account charge | Creado el 30 nov 2007 Entregado el 10 dic 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company or deutsche morgan grenfell group PLC (the guarantor) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All right title and interest in and to the account and the collateral. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene SIXCO LEASING LIMITED. algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0