BL HC INVIC LEISURE LIMITED

BL HC INVIC LEISURE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBL HC INVIC LEISURE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02464159
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BL HC INVIC LEISURE LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra BL HC INVIC LEISURE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BL HC INVIC LEISURE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    INVICTA LEISURE LIMITED26 ene 199026 ene 1990

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BL HC INVIC LEISURE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2022

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BL HC INVIC LEISURE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 23 feb 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cessation de Bl Hc Health and Fitness Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 nov 2022

    1 páginasPSC07

    Notification de Bl Retail Warehousing Holding Company Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 nov 2022

    2 páginasPSC02

    Cese del nombramiento de Katherine Fyfe como director el 17 oct 2022

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Mrs Katherine Fyfe el 20 jul 2022

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mrs Katherine Fyfe como director el 20 jul 2022

    2 páginasAP01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    23 may 2023Other The address of any individual marked (#) was replaced with a service address or partially redacted on 23rd May 2023 under section 1088 of the Companies Act 2006

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2022

    5 páginasAA

    Estado de capital el 21 abr 2022

    • Capital: GBP 1.00
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cese del nombramiento de Charles John Middleton como director el 31 mar 2022

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Gavin Bergin como director el 18 mar 2022

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Sarah Morrell Barzycki como director el 18 mar 2022

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Jonathan Charles Mcnuff como director el 18 mar 2022

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Nick Taunt como director el 18 mar 2022

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Nigel Mark Webb como director el 18 mar 2022

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Paul Stuart Macey como director el 18 mar 2022

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 23 feb 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2021

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 23 feb 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de BL HC INVIC LEISURE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro8992198
    187856670001
    BERGIN, Gavin
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish251327820001
    TAUNT, Nicholas Henry
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish275050860001
    BALL, Michael David
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    Secretario
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    British58961410002
    EKPO, Ndiana
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secretario
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    162246380001
    FALLOWS, Michael Joseph
    11 Greville Drive
    Edgbaston
    B15 2UU Birmingham
    Secretario
    11 Greville Drive
    Edgbaston
    B15 2UU Birmingham
    British58345490001
    SCALES, Eugene Patrick
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Secretario
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Other124193970001
    TYSON, Roger Thomas Virley
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    Secretario
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    British113777700001
    WEATHERLEY, Kenneth Frank
    8 Langtons Court
    Sun Lane
    SO24 9UE Alresford
    Hampshire
    Secretario
    8 Langtons Court
    Sun Lane
    SO24 9UE Alresford
    Hampshire
    British50477690001
    WONG, Wai Chung
    Flat 3 Rowsley Lodge
    72a Lady Margaret Road
    N19 5EL London
    Secretario
    Flat 3 Rowsley Lodge
    72a Lady Margaret Road
    N19 5EL London
    British123616460002
    BALL, Michael David
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    Director
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    United KingdomBritish58961410002
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish32809050044
    BRAINE, Anthony
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish32809000002
    CARTER, Simon Geoffrey
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish170891060001
    CHARLTON, Stephen Paul
    9 Rowan Close
    L40 4LP Burscough
    Lancashire
    Director
    9 Rowan Close
    L40 4LP Burscough
    Lancashire
    EnglandBritish96743210001
    CLELAND, Jonathan Bradley
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Director
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish146698270001
    CONNON, Daniel Francis
    Elmhurst Dundle Road
    Matfield
    TN12 7HD Tonbridge
    Kent
    Director
    Elmhurst Dundle Road
    Matfield
    TN12 7HD Tonbridge
    Kent
    British35128740001
    COUPE, David John
    1 Chelsea House
    13 Edith Grove
    SW10 0JZ London
    Director
    1 Chelsea House
    13 Edith Grove
    SW10 0JZ London
    United KingdomBritish125432970002
    CREED, Stuart John
    Jade House The Avenue
    Claverton Down
    BA2 7AX Bath
    Director
    Jade House The Avenue
    Claverton Down
    BA2 7AX Bath
    United KingdomBritish3716600001
    CURRY, John Arthur Hugh
    Stokewood Park House Sheardley Lane
    Droxford
    SO32 3QY Southampton
    Director
    Stokewood Park House Sheardley Lane
    Droxford
    SO32 3QY Southampton
    EnglandBritish2968140002
    DAVIES, Rhian Lynn
    32 Caldervale Road
    SW4 9LZ Clapham
    London
    Director
    32 Caldervale Road
    SW4 9LZ Clapham
    London
    British48466920001
    DHODY, Jog
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Director
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish104269910002
    DICKSON, Peter Alan
    Pointer House Farm
    Langley Lane Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    Director
    Pointer House Farm
    Langley Lane Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    British13332510001
    FALLOWS, Michael Joseph
    11 Greville Drive
    Edgbaston
    B15 2UU Birmingham
    Director
    11 Greville Drive
    Edgbaston
    B15 2UU Birmingham
    EnglandBritish58345490001
    FORSHAW, Christopher Michael John
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish1898090001
    FYFE, Katherine
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish293284010001
    GIBSON, Clive Patrick, The Honourable
    Monmouth House
    29a Hyde Park Gate
    SW7 5DJ London
    Director
    Monmouth House
    29a Hyde Park Gate
    SW7 5DJ London
    British45468220001
    GILLIS, Neil Duncan
    Lodge Farm
    High Street, Thelnetham
    IP22 1JL Diss
    Norfolk
    Director
    Lodge Farm
    High Street, Thelnetham
    IP22 1JL Diss
    Norfolk
    EnglandBritish69204500003
    GRIFFITHS, Paul Richard
    21 Manor Way
    Blackheath
    SE3 9EF London
    Director
    21 Manor Way
    Blackheath
    SE3 9EF London
    British54611260001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish146546000001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish146546000001
    GUYER, Paul John
    Oakwood House
    29 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    Director
    Oakwood House
    29 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    British100971720002
    HALL, Andrew James
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish30306840002
    LEATHERBARROW, David Jon
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Director
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritish135618280002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de BL HC INVIC LEISURE LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Bl Retail Warehousing Holding Company Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    25 nov 2022
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland
    Número de registro06002154
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    Bl Hc Health And Fitness Holdings Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06 abr 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.

    ¿Tiene BL HC INVIC LEISURE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Fixed and floating security document
    Creado el 18 jun 2009
    Entregado el 26 jun 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Societe Generale as Security Agent for the Benefit of the Secured Parties
    Transacciones
    • 26 jun 2009Registro de un cargo (395)
    • 29 jul 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Assignment of receivables
    Creado el 18 jun 2009
    Entregado el 26 jun 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Right title and interest in and to the receivables see image for full details.
    Personas con derecho
    • Esporta Financial Services Limited
    Transacciones
    • 26 jun 2009Registro de un cargo (395)
    • 07 jul 2009
    • 08 feb 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Group debenture
    Creado el 08 feb 2006
    Entregado el 18 feb 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for the Secured Parties)(in Such Capacity the "Security Agent")
    Transacciones
    • 18 feb 2006Registro de un cargo (395)
    • 01 mar 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 27 ene 2004
    Entregado el 07 feb 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the borrower, the charging group and/or any other member of the group to the note finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Electra Partners Europe Limited as Noteholders' Agent and Noteholders' Security Trustee Andnoteholders Security Trust (The "Noteholders' Security Trustee")
    Transacciones
    • 07 feb 2004Registro de un cargo (395)
    • 03 nov 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 27 ene 2004
    Entregado el 03 feb 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the borrower, the charging group and/or any member of the group (meaning the borrower or its subsidiaries from time to time) to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Dukes meadow chiswick hounslow t/no NGL147830; imperial way croydon surrey t/no SGL454522; llandarcy neath swansea t/no CYM43829 and WA953690 for details of further properties charged please refer to form 395 unscheduled property, rental income, fixed or other plant and machinery, insurances, licences on land, reights as tenant, book and other debts, bank accounts, charged securities, uncalled capital , goodwill, intellectual property, licences, credit agreements, contracts floating charge undertaking property rights and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 03 feb 2004Registro de un cargo (395)
    • 07 mar 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental charge
    Creado el 09 sept 2003
    Entregado el 12 sept 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    L/H premises together with buildings erected on them k/a the bridgend health & fitness club, waterton park, waterton lane, bridgend, mid glamorgan together with all buildings and fixtures thereon and the proceeds of sale or any part thereon, all other estates or interests in the property and any rights under any licence or other agreement fixed charge present and future book and other debts, all equipment owned present and future , the benefit of all licences, permissions, consents and authorisations present and future, benefits of all insurance by way of assignment all its right, title and interest in and to all contracts and insurances.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Security Trustee for the Finance Parties
    Transacciones
    • 12 sept 2003Registro de un cargo (395)
    • 03 mar 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 05 sept 2002
    Entregado el 09 sept 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from the issuer and by each charging company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first legal mortgage all properties now owned by or vested in each charging company including t/n HS293663 humberston country club, humberston avenue, grimsby. T/n HS293701 humberston country club, humberston avenue, grimsby and leasehold unit 9C, upper winbury farm, wingrave, aylesbury, buckinghamshire. By way of first fixed mortgage the securities, first fixed charge all properties thereafter acquired, all present and future interests in or over freehold or leasehold property; all present and future rights, licences, guarantees, rents, deposits, contracts, covenants and warranties relating to the properties.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Electra Partners Europe Limited (As Noteholders' Agent and Noteholders' Security Agent for Thenote Finance Parties)
    Transacciones
    • 09 sept 2002Registro de un cargo (395)
    • 14 ene 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deposit deed
    Creado el 14 jun 2001
    Entregado el 28 jun 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £100,000 including all monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    The deposit and all rights titles and benefits whatsoever present and future therein.
    Personas con derecho
    • Arrowcroft Leisure Limited
    Transacciones
    • 28 jun 2001Registro de un cargo (395)
    • 15 mar 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deposit deed
    Creado el 18 abr 2000
    Entregado el 26 abr 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £100,000 due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Charge over the deposit of £100,000.
    Personas con derecho
    • Arrowcroft Leisure Limited
    Transacciones
    • 26 abr 2000Registro de un cargo (395)
    • 15 mar 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 15 oct 1999
    Entregado el 28 oct 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent and security trustee for the finance parties (as therein defined)) on any account whatsoever, under or in connection with the financing documents (including, without limitation, the guarantee and debenture)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Coutts & Company
    Transacciones
    • 28 oct 1999Registro de un cargo (395)
    • 03 mar 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 10 mar 1999
    Entregado el 24 mar 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land and buildings lying to the north of humberston avenue humberston north east lincolnshire t/no;-HS228117 together with goodwill of any business carried on at the property and all right title and interest in and to the "acquisition documents" (as defined in the charge). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Kingsway Nominees Limitedas Trustee on Behalf of Electra Fleming Privateequity Partners (The Lender)
    Transacciones
    • 24 mar 1999Registro de un cargo (395)
    • 03 mar 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 08 mar 1999
    Entregado el 23 mar 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    191 humberston avenue grimsby t/no ;-HS256419 together with land at the rear with title number HS228117 (part) and goodwill of any business carried on at the property and all the company's interest in and to the acquisition documents. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Coutts & Company
    Transacciones
    • 23 mar 1999Registro de un cargo (395)
    • 03 mar 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 30 may 1996
    Entregado el 10 jun 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • Coutts & Company
    Transacciones
    • 10 jun 1996Registro de un cargo (395)
    • 26 jul 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 30 may 1996
    Entregado el 07 jun 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or any group member to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Kingsway Nominees Limitedas Trustee on Behalf of Electra Fleming Privateequity Partners
    Transacciones
    • 07 jun 1996Registro de un cargo (395)
    • 03 mar 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 01 jul 1994
    Entregado el 20 jul 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £150000 due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    Land to south of batlet road west end hampshire t/n HP471547.
    Personas con derecho
    • The Lawn Tennis Association
    Transacciones
    • 20 jul 1994Registro de un cargo (395)
    • 07 mar 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of amendment
    Creado el 13 feb 1992
    Entregado el 20 feb 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    As specified in previous debenture see form 395 m/66/l for full details.
    Personas con derecho
    • Coutts & Co.
    Transacciones
    • 20 feb 1992Registro de un cargo (395)
    • 26 jul 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment of life policies
    Creado el 07 ene 1992
    Entregado el 15 ene 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility agreement dated 16/9/91 and/or this charge
    Breve descripción
    The policies as defined below and all moneys thereby assured which may become payable thereunder and all the full benefit thereof please see form 395 5 16/1 for full details.
    Personas con derecho
    • Coutts & Co.
    Transacciones
    • 15 ene 1992Registro de un cargo (395)
    • 26 jul 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 16 sept 1991
    Entregado el 23 sept 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 16 sept, 1991 and the charge
    Breve descripción
    (See form 395 and continuation sheets relevant to this charge). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Coutts & Co.
    Transacciones
    • 23 sept 1991Registro de una carga
    • 26 jul 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0