SAATCHI & SAATCHI LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | SAATCHI & SAATCHI LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02464197 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SAATCHI & SAATCHI LIMITED?
- Agencias de publicidad (73110) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra SAATCHI & SAATCHI LIMITED?
| Dirección de la sede social | Took Court 40 Chancery Lane WC2A 1JA London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SAATCHI & SAATCHI LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| TEAM SAATCHI LIMITED | 03 mar 1995 | 03 mar 1995 |
| CHAFMA CONSULTANTS LIMITED | 17 abr 1990 | 17 abr 1990 |
| GEMGROVE SERVICES LIMITED | 26 ene 1990 | 26 ene 1990 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SAATCHI & SAATCHI LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SAATCHI & SAATCHI LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 5 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Nicola Raj como secretario el 15 feb 2019 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 26 ene 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Estado de capital el 24 oct 2018
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 3 páginas | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 3 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Justin Kenneth Billingsley como director el 02 jul 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 17 páginas | AA | ||||||||||||||
Nombramiento de Ms Annette King como director el 29 jun 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 26 ene 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 20 páginas | AA | ||||||||||||||
Nombramiento de Ms Nicola Raj como secretario el 07 jun 2017 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Justin Kenneth Billingsley como director el 31 mar 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Alex Bekkerman como director el 31 mar 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 26 ene 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado Took Court 40 Chancery Lane London WC2A 1JA | 1 páginas | AD04 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 80 Charlotte Street London W1 1AQ a Took Court 40 Chancery Lane London WC2A 1JA el 26 ene 2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Raj Basran como secretario el 18 ene 2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 17 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 26 ene 2016 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Alan Harker como director el 03 jul 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Alex Bekkerman como director el 26 jun 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de SAATCHI & SAATCHI LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNIS, Joanne | Secretario | Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building England | 196593550001 | |||||||
| CARRIGAN, James Joseph, Mr. | Director | Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building England | England | British | 127439710001 | |||||
| ETIENNE, Jean-Michel Michel | Director | Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building England | France | French | 171031220001 | |||||
| KING, Annette | Director | 40 Chancery Lane WC2A 1JA London Took Court England | United Kingdom | British | 152540840001 | |||||
| BAILEY, Sarah Anne | Secretario | Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building England | 185350280002 | |||||||
| BASRAN, Raj | Secretario | 80 Charlotte Street London W1 1AQ | 170042360001 | |||||||
| DAVIS, Robert | Secretario | Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building | British | 155474590001 | ||||||
| EARL, Elizabeth Louise Kiernan | Secretario | 9 Helena Road SL4 1JN Windsor Berkshire | British | 105197540001 | ||||||
| EVANS, Fiona Maria | Secretario | 85 Ravensmede Way Chiswick W4 1TQ London | British | 49259690002 | ||||||
| EWING, Susanna | Secretario | 72f Sinclair Road W14 0NJ London | British | 122102410001 | ||||||
| GONZALEZ-GOMEZ, Minna Katariina | Secretario | Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building England | Finnish | 119965730001 | ||||||
| HOWELL, Peter Graham | Secretario | 76 Kings Road SW19 8QW London | British | 62634010001 | ||||||
| JANS, Annamaria | Secretario | 20 Underhill Road East Dulwich SE22 0AH London | British | 1085040008 | ||||||
| KURTZ, Catherine Elizabeth Strathmore | Secretario | 6 Berkeley Road TN1 1YR Tunbridge Wells Kent | British | 54236170003 | ||||||
| RAJ, Nicola | Secretario | Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building United Kingdom | 233357470001 | |||||||
| WALLS ECKLEY, Gillian | Secretario | 80 Charlotte Street London W1 1AQ | 160074860001 | |||||||
| WYLLIE, Alison | Secretario | Flat 2 186 Ladbroke Grove W10 5LZ London | British | 107811220001 | ||||||
| BEKKERMAN, Alex | Director | 40 Chancery Lane WC2A 1JA London Took Court England | England | American | 198886380001 | |||||
| BILLINGSLEY, Justin Kenneth | Director | Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building England | England | Australian | 228671340001 | |||||
| BINDING, David Wyn | Director | 48 Midhurst Avenue Muswell Hill N10 3EN London | British | 5994480001 | ||||||
| BUNTON, Christopher John | Director | 12 The Chowns AL5 2BN Harpenden Hertfordshire | United Kingdom | British | 1321820001 | |||||
| CARPENTER, Candice | Director | 799 Park Avenue 20b New York 10021 Usa | American | 70189600001 | ||||||
| COCHRANE, William Henry | Director | 26 Sloping Hill Terrace 07470 Wayne New Jersey United States Of America | American | 54779490001 | ||||||
| COURET, Philippe Francois Pierre | Director | Flat 9 1 Prince Of Wales Terrace W8 5PG London | French | 68861790003 | ||||||
| EVANS, Fiona Maria | Director | 85 Ravensmede Way Chiswick W4 1TQ London | British | 49259690002 | ||||||
| GRAHAM, Alec | Director | Linden Lea, Packhorse Road Bessels Green TN13 2QP Sevenoaks Kent | British | 73621260001 | ||||||
| HARKER, Alan | Director | Avonmore Road Kensington Village W14 8DG London Pembroke Building England | England | British | 174823410001 | |||||
| HOWELL, Peter Graham | Director | 76 Kings Road SW19 8QW London | Uk | British | 62634010001 | |||||
| IRVINE, Ian Alexander Noble | Director | 14 Tregunter Road SW10 9LR London | British | 53758680001 | ||||||
| JANS, Annamaria | Director | 20 Underhill Road East Dulwich SE22 0AH London | British | 1085040008 | ||||||
| LEVY, Maurice | Director | 55 Rue De Lille Paris 75007 France | French | 76746640001 | ||||||
| MORIN, Jean-Paul Philippe Edmond | Director | 3 Villa Guibert FOREIGN Paris 75016 France | French | 77019930002 | ||||||
| OLSHAN, Kenneth Sheldon | Director | 72 Sandford Town Road 06896 Redding Connecticut Usa | American | 56648570001 | ||||||
| ROBERTS, Kevin John | Director | 57 Portland Road Auckland New Zealand | New Zealand | New Zealander | 257435380001 | |||||
| SCOTT, Charles Thomas | Director | 36 Kensington Heights 97 Campden Hill Road W8 7BD London | British | 57006540001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SAATCHI & SAATCHI LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mms Uk Holdings Limited | 06 abr 2016 | Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene SAATCHI & SAATCHI LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 15 dic 1997 Entregado el 24 dic 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the agreement dated 30TH september 1997 (as defined) and/or the security documents (as defined) when the same become due for payment or discharge | |
Breve descripción By way of first legal mortgage the property (if any); by way of first fixed charge all present and future f/h and l/h property wheresoever situate; all plant machinery and other equipment; all book and other debts; the goodwill and uncalled capital; by way of first floating charge its undertaking and all its property assets and rights whatsoever and wheresoever both present and future.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 16 abr 1993 Entregado el 04 may 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a guarantee and standby facility agreement as defined | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of charge | Creado el 06 feb 1991 Entregado el 18 feb 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an advance agreement of even date. | |
Breve descripción First fixed charge all right, title and interest in, and all sums standings from title to time to the credit of the accounts and all interest thereon and right, benefits and proceeds thereof or of any renewal or and designation thereof (together the "assets") as a continiuing security for the payment and discharge of all the assets. (Please see doc 395/m/37/l/19/2) for complete details). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0