TAVERNER (1) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTAVERNER (1) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02466749
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TAVERNER (1) LIMITED?

    • fabricación de artículos de plástico para la construcción (22230) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra TAVERNER (1) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    C/O Fibresec Holdings Ltd
    Snaygill Ind Estate
    BD23 2QR Keighley Road, Skipton
    North Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TAVERNER (1) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    FOAM TECHNOLOGY LIMITED10 mar 199410 mar 1994
    ENGINEERING COMPOSITES LIMITED10 abr 199010 abr 1990
    SIMCO 311 LIMITED05 feb 199005 feb 1990

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TAVERNER (1) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2012

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para TAVERNER (1) LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TAVERNER (1) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 04 feb 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital09 abr 2014

    Estado de capital el 09 abr 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed foam technology LIMITED\certificate issued on 30/10/13
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name30 oct 2013

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 06 oct 2013

    RES15

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 02 oct 2013

    • Capital: GBP 1.00
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2012

    2 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 04 feb 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2011

    2 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 04 feb 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr Martin Paul Heath el 18 oct 2011

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Ian Peter Thompson el 15 mar 2012

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Mrs Ann Jacqueline Preston el 15 mar 2012

    1 páginasCH03

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2010

    2 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 04 feb 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2009

    2 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 04 feb 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Ian Peter Thompson el 04 mar 2010

    2 páginasCH01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2008

    2 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2007

    2 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    ¿Quiénes son los directivos de TAVERNER (1) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PRESTON, Ann Jacqueline
    C/O Fibresec Holdings Ltd
    Snaygill Ind Estate
    BD23 2QR Keighley Road, Skipton
    North Yorkshire
    Secretario
    C/O Fibresec Holdings Ltd
    Snaygill Ind Estate
    BD23 2QR Keighley Road, Skipton
    North Yorkshire
    British110426760001
    HEATH, Martin Paul
    C/O Fibresec Holdings Ltd
    Snaygill Ind Estate
    BD23 2QR Keighley Road, Skipton
    North Yorkshire
    Director
    C/O Fibresec Holdings Ltd
    Snaygill Ind Estate
    BD23 2QR Keighley Road, Skipton
    North Yorkshire
    United KingdomBritish20585800006
    THOMPSON, Ian Peter
    C/O Fibresec Holdings Ltd
    Snaygill Ind Estate
    BD23 2QR Keighley Road, Skipton
    North Yorkshire
    Director
    C/O Fibresec Holdings Ltd
    Snaygill Ind Estate
    BD23 2QR Keighley Road, Skipton
    North Yorkshire
    EnglandBritish46127620002
    JENNINGS, Michael
    Unit 2
    Snaygill Industrial Estate
    Keighley Road
    Skipton
    North Yorkshire
    Secretario
    Unit 2
    Snaygill Industrial Estate
    Keighley Road
    Skipton
    North Yorkshire
    British30584730001
    LEESING, Brian
    Limestones Back Lane
    Old Edlington
    DN12 1QA Doncaster
    South Yorkshire
    Secretario
    Limestones Back Lane
    Old Edlington
    DN12 1QA Doncaster
    South Yorkshire
    British19080600002
    THOMPSON, Ian Peter
    Merrimead
    Constable Road
    LS29 8RW Ben Rhydding Ilkley
    West Yorkshire
    Secretario
    Merrimead
    Constable Road
    LS29 8RW Ben Rhydding Ilkley
    West Yorkshire
    British46127620002
    WATSON, Keith
    18 Harrowby Road
    LS16 5HX Leeds
    West Yorkshire
    Secretario
    18 Harrowby Road
    LS16 5HX Leeds
    West Yorkshire
    British33828510001
    CROSSLAND, John Stuart
    Park House Bankwell
    Giggleswick
    BD24 0AP Settle
    North Yorkshire
    Director
    Park House Bankwell
    Giggleswick
    BD24 0AP Settle
    North Yorkshire
    EnglandBritish83891300001
    JENNINGS, Michael
    Mickleden Ladder Banks Lane
    Baildon Shipley
    Bradford
    West Yorkshire
    Director
    Mickleden Ladder Banks Lane
    Baildon Shipley
    Bradford
    West Yorkshire
    British1951910001
    KEMP, Steven
    11 Coppy Road
    Addingham
    LS29 Ilkley
    West Yorkshire
    Director
    11 Coppy Road
    Addingham
    LS29 Ilkley
    West Yorkshire
    British39217900002
    LEESING, Brian
    Limestones Back Lane
    Old Edlington
    DN12 1QA Doncaster
    South Yorkshire
    Director
    Limestones Back Lane
    Old Edlington
    DN12 1QA Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritish19080600002
    PARDOE, Trevor William
    Woodstock House Bleach Mill Lane
    Menston
    LS29 6AN Ilkley
    West Yorkshire
    Director
    Woodstock House Bleach Mill Lane
    Menston
    LS29 6AN Ilkley
    West Yorkshire
    British3465590001
    TURNER, David Deacon
    Swinnow Hill York Road
    LS22 5EL Wetherby
    West Yorkshire
    Director
    Swinnow Hill York Road
    LS22 5EL Wetherby
    West Yorkshire
    British3465600001
    TURNER, John Deacon
    15 Bracken Park
    Scarcroft
    LS14 3HZ Leeds
    West Yorkshire
    Director
    15 Bracken Park
    Scarcroft
    LS14 3HZ Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish1140750002

    ¿Tiene TAVERNER (1) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Composite debenture & guarantee
    Creado el 11 sept 1992
    Entregado el 29 sept 1992
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of theother companies named therein to the chargee under the terms of the loanstock agreement(as defined) and this charge
    Breve descripción
    See form 395 ref M439C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Bayford & Co.Limitedas Agent for the Stockholder
    Transacciones
    • 29 sept 1992Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 11 sept 1992
    Entregado el 24 sept 1992
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    For full details see form 395 tc ref: M346C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 24 sept 1992Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 24 ene 1991
    Entregado el 06 feb 1991
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 06 feb 1991Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0