ONE STOP CONVENIENCE STORES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ONE STOP CONVENIENCE STORES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02467178 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ONE STOP CONVENIENCE STORES LIMITED?
- Venta al por menor en establecimientos no especializados predominando la venta de alimentos, bebidas o tabaco (47110) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
¿Dónde se encuentra ONE STOP CONVENIENCE STORES LIMITED?
| Dirección de la sede social | Apex Road Brownhills WS8 7HU Walsall West Midlands United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ONE STOP CONVENIENCE STORES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MISSELBROOK & WESTON LIMITED | 15 mar 1990 | 15 mar 1990 |
| FORGESIZE LIMITED | 05 feb 1990 | 05 feb 1990 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ONE STOP CONVENIENCE STORES LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 28 feb 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 nov 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 22 feb 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para ONE STOP CONVENIENCE STORES LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 12 oct 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 26 oct 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 12 oct 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ONE STOP CONVENIENCE STORES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 12 oct 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 22 feb 2025 | 4 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Sara Thomson como director el 04 jul 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Mark Edward Everitt como director el 05 mar 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Paul Thompson como director el 06 feb 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Tesco Services Limited como director el 20 dic 2024 | 2 páginas | AP02 | ||
Nombramiento de Sara Thomson como director el 20 dic 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Robert John Welch como director el 17 dic 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 12 oct 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 24 feb 2024 | 4 páginas | AA | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 25 feb 2023 | 4 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 12 oct 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 12 oct 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 26 feb 2022 | 3 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Jonny Mcquarrie como director el 05 ene 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Tesco Services Limited como director el 05 ene 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Sharon Kyte como director el 05 ene 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 27 feb 2021 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 12 oct 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 12 oct 2020 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 29 feb 2020 | 12 páginas | AA | ||
legacy | 176 páginas | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
Notification de One Stop Stores Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 ene 2020 | 2 páginas | PSC02 | ||
¿Quiénes son los directivos de ONE STOP CONVENIENCE STORES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESCO SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Shire Park Kestrel Way AL7 1GA Welwyn Garden City Tesco House United Kingdom |
| 182118090001 | ||||||||||
| THOMPSON, Paul | Director | Brownhills WS8 7HU Walsall Apex Road West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 332267260001 | |||||||||
| TESCO SERVICES LIMITED | Director corporativo | Shire Park Kestrel Way AL7 1GA Welwyn Garden City Tesco House United Kingdom |
| 175259630001 | ||||||||||
| BURROWS, Patrick James | Secretario | Gardeners Cottage The Lordship SG10 6HN Much Hadham Hertfordshire | British | 86778310001 | ||||||||||
| COWELL, Martin William | Secretario | 32 Beverston Road Perton WV6 7UG Wolverhampton West Midlands | British | 1614020001 | ||||||||||
| DOLAN, Malcolm George | Secretario | 30 Ferndown Close Bloxwich WS3 3XH Walsall West Midlands | British | 73207060001 | ||||||||||
| DOLAN, Malcolm George | Secretario | 30 Ferndown Close Bloxwich WS3 3XH Walsall West Midlands | British | 73207060001 | ||||||||||
| EVERITT, Mark Edward | Secretario | Brownhills WS8 7HU Walsall Apex Road West Midlands United Kingdom | British | 204754740001 | ||||||||||
| PUTNAM, Nicholas Stewart | Secretario | 11 The Parkway Bassett SO16 3NZ Southampton Hampshire | British | 26014170003 | ||||||||||
| SANKAR, Nadine Amanda | Secretario | 90 Ebury Road WD17 2SB Watford | British | 72917320001 | ||||||||||
| AGER, Rowley Stuart | Director | Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | United Kingdom | British | 72555850002 | |||||||||
| ASKHAM, Francis Guy Lewis | Director | Spinney Corner Church Lane Braishfield SO51 0QH Romsey Hampshire | United Kingdom | British | 15237500001 | |||||||||
| BLAIR, Steven | Director | Brownhills WS8 7HU Walsall Apex Road West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 239167430001 | |||||||||
| BURROWS, Patrick James | Director | Gardeners Cottage The Lordship SG10 6HN Much Hadham Hertfordshire | British | 86778310001 | ||||||||||
| CLEMENTS, Tracey | Director | Brownhills WS8 7HU Walsall Apex Road West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 198102550001 | |||||||||
| CRELLIN, David | Director | 191 Worcester Road Hagley DY9 0PR Stourbridge West Midlands | British | 31677030002 | ||||||||||
| EVERITT, Mark Edward | Director | Brownhills WS8 7HU Walsall Apex Road West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 107529830027 | |||||||||
| GASTON, Peter Jonas | Director | Pinetops 7 Belle Vue Walk West Parley BH22 8QB Ferndown Dorset | British | 26014200001 | ||||||||||
| GIBBONS, Jasper Desmond | Director | 35 Peterscroft Avenue Ashurst SO40 7AB Southampton Hampshire | British | 9592570001 | ||||||||||
| GORDON, Timothy Leigh | Director | 2 Sandown Drive Halebarns WA15 0BA Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 2900860001 | |||||||||
| HIGGINSON, Andrew Thomas | Director | New Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | England | British | 57637410003 | |||||||||
| HOLMES, Colin Peter | Director | 66 Tolmers Road EN6 4JY Cuffley Hertfordshire | United Kingdom | British | 86778500001 | |||||||||
| KING, Andrew Paul | Director | Brownhills WS8 7HU Walsall Apex Road West Midlands United Kingdom | England | British | 200246970001 | |||||||||
| KYTE, Sharon | Director | Brownhills WS8 7HU Walsall Apex Road West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 256836140001 | |||||||||
| LAPAGE, Nigel James | Director | 29 Chetwynd Drive SO16 3HY Southampton Hampshire | British | 66920500001 | ||||||||||
| LLOYD, Jonathan Mark | Director | New Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | United Kingdom | British | 160028560001 | |||||||||
| MAGUIRE, Graham | Director | 5 The Oaks GU13 8HQ Fleet Hampshire | British | 46749690001 | ||||||||||
| MAWBY, Kim Janet | Director | Plot 2 The Bush Newtown Road Awbridge SO51 0GG Romsey Hampshire | British | 51992050003 | ||||||||||
| MCCARTHY, James John | Director | Broadview House 34 Avenue Road CV37 6UN Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 2426350005 | ||||||||||
| MCQUARRIE, Jonny | Director | Brownhills WS8 7HU Walsall Apex Road West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 239167420001 | |||||||||
| MITCHELL HYND, Leslie Christopher | Director | Fairweather Cottage, Laurel Close Morley St. Botolph NR18 9VV Wymondham Norfolk | British | 26014220002 | ||||||||||
| MOORE, Dean | Director | Bleak House Oaks Road LE67 5UP Whitwick Leicestershire | British | 94541520001 | ||||||||||
| MURRELLS, Steven Geoffrey | Director | Willow Farm Further Street CO10 5LD Assington Suffolk | British | 98194710001 | ||||||||||
| NEVILLE-ROLFE, Lucy Jeanne, Ms. | Director | New Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | United Kingdom | British | 148079740001 | |||||||||
| O'NEILL, William Patrick | Director | Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | British | 106806380001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ONE STOP CONVENIENCE STORES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Stop Stores Limited | 22 ene 2020 | Brownhills WS8 7HU Walsall Apex Road West Midlands United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| M & W Limited | 06 abr 2016 | Brownhills WS8 7TS Walsall Apex Road West Midlands United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0