PROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED

PROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02467508
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED?

    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra PROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED?

    Dirección de la sede social
    11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    8 páginas4.71

    Domicilio social registrado cambiado de 1 Admiral Way Doxford International Business Park Sunderland Tyne & Wear SR3 3XP el 14 sept 2012

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 04 sept 2012

    LRESSP

    Nombramiento de Mr Kenneth Mcintyre Carlaw como director el 28 ago 2012

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Nigel Paul Featham como director el 28 ago 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Richard Anthony Bowler como director el 28 ago 2012

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    6 páginasAA

    Cambio de datos del secretario Ms Elizabeth Anne Thorpe el 26 may 2012

    1 páginasCH03

    Déclaration annuelle établie au 14 dic 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital16 dic 2011

    Estado de capital el 16 dic 2011

    • Capital: GBP 220,002
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    6 páginasAA

    Nombramiento de Nigel Paul Featham como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Jonathan May como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 14 dic 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 14 dic 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cambio de datos del secretario Ms Elizabeth Anne Thorpe el 14 dic 2009

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mr Jonathan Paul May el 14 dic 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Richard Anthony Bowler el 14 dic 2009

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2008

    9 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2007

    9 páginasAA

    legacy

    1 páginas288c

    ¿Quiénes son los directivos de PROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    DAVIES, Elizabeth Anne
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Secretario
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    British102907000002
    CARLAW, Kenneth Mcintyre
    Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11
    Director
    Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11
    EnglandBritish161250030001
    CAMPBELL, David Gerard
    47 Ridgely Drive
    Ponteland
    NE20 9BJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Secretario
    47 Ridgely Drive
    Ponteland
    NE20 9BJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British8159840001
    JONES, Michael Adrian
    5 Sandycroft
    Warsash
    SO31 9AA Southampton
    Hampshire
    Secretario
    5 Sandycroft
    Warsash
    SO31 9AA Southampton
    Hampshire
    British36134870001
    TURNER, David Paul
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    Secretario
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    British48937720001
    BRITISH BUS (COMPANY SECRETARIES) LIMITED
    54 Endless Street
    SP1 3UH Salisbury
    Wiltshire
    Secretario corporativo
    54 Endless Street
    SP1 3UH Salisbury
    Wiltshire
    42985760001
    BAYFIELD, Stephen
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    Director
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    British42058550001
    BOWLER, Richard Anthony
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Director
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish35116070001
    FEATHAM, Nigel Paul
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Director
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish161124990001
    FICKLING, John Matthew
    62 Gainsborough Close
    NE25 9XB Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Director
    62 Gainsborough Close
    NE25 9XB Whitley Bay
    Tyne & Wear
    British40818470001
    JONES, Michael Adrian
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    Director
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish77984700001
    KENNAN, Anthony Denis
    13 The Poplars
    Gosforth
    NE3 4AE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    13 The Poplars
    Gosforth
    NE3 4AE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British8159860001
    LONSDALE, Stephen Philip
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    Director
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    United KingdomBritish4971910001
    MARTIN, David Robert
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Director
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish6874440001
    MARTIN, David Robert
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Director
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish6874440001
    MAY, Jonathan Paul
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Director
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish125675730002
    MONAGHAN, David Bell
    43 Well Ridge Close
    Redhouse Farm
    NE25 9PN Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Director
    43 Well Ridge Close
    Redhouse Farm
    NE25 9PN Whitley Bay
    Tyne & Wear
    British35862500001
    NOBLE, Stephen Leslie
    Brewery Close
    Stamfordham
    NE18 0PQ Northumberland
    Close House
    United Kingdom
    Director
    Brewery Close
    Stamfordham
    NE18 0PQ Northumberland
    Close House
    United Kingdom
    United KingdomBritish128655430001
    RAY, John Alfred
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    Director
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    British58415290001
    WATT, Gordon George
    Alderbury Holt
    Southampton Road,Clarendon
    SP5 3DG Salisbury
    Wiltshire
    Director
    Alderbury Holt
    Southampton Road,Clarendon
    SP5 3DG Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritish67622780002
    WILLIAMS, Dawson Thomas
    Chately Wood House
    Rockford
    BH24 3LZ Ringwood
    Hampshire
    Director
    Chately Wood House
    Rockford
    BH24 3LZ Ringwood
    Hampshire
    British2719600006

    ¿Tiene PROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Chattel mortgage
    Creado el 29 dic 1994
    Entregado el 29 dic 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from kentish bus & coach company limited and northumbria - motor services limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All and singular the vehicles as described in the schedule to the form 395 including 17 x leyland olympian double decker buses and 2 x optare delta buses. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Forward Trust Limited
    Transacciones
    • 29 dic 1994Registro de un cargo (395)
    • 20 oct 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Letter of charge and set-off over credit balances
    Creado el 15 ago 1994
    Entregado el 31 ago 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the working capital facility letter dated 15TH august 1994
    Breve descripción
    All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company in the bank's books.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 31 ago 1994Registro de un cargo (395)
    • 06 jul 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 11 ago 1994
    Entregado el 26 ago 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the loan agreement dated 4TH may 1994, any interest rate agreement, or any of the security documents (as defined in the charge)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The First National Bank of Boston"the Agent"
    Transacciones
    • 26 ago 1994Registro de un cargo (395)
    • 01 may 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creado el 13 jul 1990
    Entregado el 23 jul 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever (see form 395 for further details)
    Breve descripción
    (See form 395 for further details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Standard Chartered Bank
    Transacciones
    • 23 jul 1990Registro de una carga
    • 06 jul 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 13 jul 1990
    Entregado el 23 jul 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for standard chartered bank and dresdner bank A.G. pursuant to a loan agreement of even date and under the terms of the charge
    Breve descripción
    (See form 395 for further details of specific property). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Standard Chartered Bank(As Agent and Trustee)
    Transacciones
    • 23 jul 1990Registro de una carga
    • 06 jul 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene PROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    08 abr 2013Fecha de disolución
    04 sept 2012Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Rob Sadler
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Profesional
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Andrew Timothy Clay
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Profesional
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0