NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED

NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaNEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02470056
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    140 Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GLE PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED14 feb 199014 feb 1990

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 28 jul 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2020

    19 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 28 jul 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Steven Carl Wright como director el 08 nov 2019

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Christopher Arthur Rushton como director el 11 dic 2019

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2019

    17 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 28 jul 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 9

    1 páginasMR04

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2018

    18 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 28 jul 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Steven Carl Wright como director el 14 nov 2017

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2017

    20 páginasAA

    Modification des détails de Greater London Enterprise Investments Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 oct 2016

    2 páginasPSC05

    Declaración de confirmación presentada el 28 jul 2017 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de 40 Aldersgate Street London EC1A 4HY England a 140 Aldersgate Street London EC1A 4HY el 25 abr 2017

    1 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de 10-12 Queen Elizabeth Street London SE1 2JN England a 40 Aldersgate Street London EC1A 4HY el 24 abr 2017

    1 páginasAD01

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name07 oct 2016

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 07 oct 2016

    RES15

    Domicilio social registrado cambiado de 5th Floor Valiant Building 14 South Parade Leeds LS1 5QS a 10-12 Queen Elizabeth Street London SE1 2JN el 06 oct 2016

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2016

    24 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 28 jul 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Michael Hofman como secretario el 31 may 2016

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Michael Bernard Walsh como secretario el 31 may 2016

    1 páginasTM02

    ¿Quiénes son los directivos de NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HOFMAN, Michael
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    Secretario
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    209188220001
    MANSON, Christopher John
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    Director
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    United KingdomBritish175493670001
    WALSH, Michael Bernard
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    Director
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    EnglandBritish74086660002
    CHAPMAN, Paul Stephen
    13 Southbourne
    Hayes
    BR2 7NJ Bromley
    Kent
    Secretario
    13 Southbourne
    Hayes
    BR2 7NJ Bromley
    Kent
    British1403010005
    GERVASIO, James Ernest Peter
    Chapeltown Road
    LS7 4HZ Leeds
    Saint Martins House 210-212
    West Yorkshire
    Secretario
    Chapeltown Road
    LS7 4HZ Leeds
    Saint Martins House 210-212
    West Yorkshire
    British2093810001
    NOEL, Dawn
    6 Cantley Road
    Hanwell
    W7 2BQ London
    Secretario
    6 Cantley Road
    Hanwell
    W7 2BQ London
    British79021070001
    WALSH, Michael Bernard
    14 South Parade
    LS1 5QS Leeds
    5th Floor Valiant Building
    England
    Secretario
    14 South Parade
    LS1 5QS Leeds
    5th Floor Valiant Building
    England
    159189680001
    WOODALL, Michael David
    Glovers Cottage Reigate Hill
    RH2 9PN Reigate
    Surrey
    Secretario
    Glovers Cottage Reigate Hill
    RH2 9PN Reigate
    Surrey
    British4777030001
    COMPTON, Colin Richard
    Kingsland House Kingsland Lane
    Leavenheath
    CO6 4PD Colchester
    Essex
    Director
    Kingsland House Kingsland Lane
    Leavenheath
    CO6 4PD Colchester
    Essex
    British12075710001
    LARGE, Martin Gerald
    14 South Parade
    LS1 5QS Leeds
    5th Floor Valiant Building
    England
    Director
    14 South Parade
    LS1 5QS Leeds
    5th Floor Valiant Building
    England
    EnglandBritish44118740003
    ROGERS, Mary
    Basement Flat
    46 Gordon Square
    WC1H 0PD London
    Director
    Basement Flat
    46 Gordon Square
    WC1H 0PD London
    British85165800001
    RUSHTON, Christopher Arthur
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    Director
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    EnglandBritish44369580002
    WRIGHT, Steven Carl
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    Director
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    EnglandBritish232556880001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Newable Uk Holdings Limited
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    06 abr 2016
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland And Wales Companies Register
    Número de registro5547054
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Assignment of share sale agreement
    Creado el 25 sept 2001
    Entregado el 15 oct 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The company with full title guarantee assigns to the bank by way of charge all that an agreement relating inter alia to the sale by the company of it's shares in gle property developments (kingston) limited dated 02 february 2001... see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transacciones
    • 15 oct 2001Registro de un cargo (395)
    • 23 feb 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment of building contract
    Creado el 25 sept 2001
    Entregado el 15 oct 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The company with full title guarantee assigns to the bank by way of charge all that the agreement dated 05 june 2001 and the full benefit thereof and the benefit of any claims or compensation whatsoever arising thereunder... See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transacciones
    • 15 oct 2001Registro de un cargo (395)
    • 23 feb 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge on shares
    Creado el 25 sept 2001
    Entregado el 15 oct 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All of the company's obligations to the chargee (or any company which is a member of the same group of companies of the bank) of any kind and in any currency
    Breve descripción
    The one ordinary share held by the company in gle property developments (kingston) limited (which constitutes the entire issued share capital of that company) together with all other stocks, shares, bonds, or other securities at any time deposited with or transferred to the bank or its nominee by the company.
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transacciones
    • 15 oct 2001Registro de un cargo (395)
    • 23 feb 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment of building contract
    Creado el 28 feb 2001
    Entregado el 14 mar 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Building contract means the agreement dated the 6 february 2001 made between the customer and the contractor and includes the drawings specifications and attachments referred to therein contractor means buxton building contractors limited c/number 2261235 of cedar house 91 high street caterham surrey CR3 5UH. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transacciones
    • 14 mar 2001Registro de un cargo (395)
    • 01 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 28 feb 2001
    Entregado el 14 mar 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transacciones
    • 14 mar 2001Registro de un cargo (395)
    • 23 feb 2002Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 20 feb 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of legal charge
    Creado el 28 feb 2001
    Entregado el 14 mar 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The property k/a land and premises at st georges square (west) gore street deptford london SE8 t/n TGL182465.
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transacciones
    • 14 mar 2001Registro de un cargo (395)
    • 01 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 24 may 1994
    Entregado el 26 may 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H-part of number 90 and the wholes of numbers 92 to 104 (even) newington butts kennington london. Fixed charge over the plant machinery and fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils of the company and the present or future goodwill of any business.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 26 may 1994Registro de un cargo (395)
    • 14 feb 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 06 dic 1993
    Entregado el 13 dic 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    112,114,116,118,120,122,124 newington butts and 76/77 holyoak road kenniongton t/ns ln 13388 sgl 298102. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 13 dic 1993Registro de un cargo (395)
    • 14 feb 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 19 nov 1993
    Entregado el 24 nov 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H-land lying to the north east of therapia lane L.B. of sutton land and buildings to the north east of therapia lane L.B. of sutton and land on the south east side of the south east of the junction of therapia lane and beddington lane beddington L.B. of sutton greater london t/n-SGL532994, SGL556142, SGL213815.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 24 nov 1993Registro de un cargo (395)
    • 14 feb 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 19 ago 1993
    Entregado el 26 ago 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge
    Breve descripción
    F/H- parcels of land in boot street hoxton market shoreditch london N1 t/n-EGL287091. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transacciones
    • 26 ago 1993Registro de un cargo (395)
    • 04 feb 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Letter
    Creado el 18 ago 1993
    Entregado el 01 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the letter
    Breve descripción
    Cash sum of £4,000.
    Personas con derecho
    • Snowcem Pmc Limited
    Transacciones
    • 01 sept 1993Registro de un cargo (395)
    • 14 feb 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 31 ene 1992
    Entregado el 20 feb 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £200,000
    Breve descripción
    F/H land containing 5.81 acres or thereabouts at therapia lane off beddington lane L.B. of sutton.
    Personas con derecho
    • Blue Circle Industries PLC
    Transacciones
    • 20 feb 1992Registro de un cargo (395)
    • 03 mar 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 31 ene 1992
    Entregado el 20 feb 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land containing 5.81 acres or thereabouts at therapia lane off beddington lane L.B. of sutton together with all buildings and fixtures fixed charge on all attached plant and machinery and other chattels floatings charge over all unattached plant and machinery and other chattels.
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transacciones
    • 20 feb 1992Registro de un cargo (395)
    • 13 oct 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0