DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL

DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaDONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad privada sin límite de capital
    Número de empresa 02475089
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL?

    • (6712) /

    ¿Dónde se encuentra DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL?

    Dirección de la sede social
    One Cabot Square
    London
    E14 4QJ
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    DLJ (UK) LIMITED09 jul 199009 jul 1990
    HACKREMCO (NO.575) LIMITED28 feb 199028 feb 1990

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 23 feb 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital23 feb 2011

    Estado de capital el 23 feb 2011

    • Capital: USD 1.5
    SH01

    Resoluciones

    Resolutions
    8 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Nombramiento de Susannah Louise Aliker como director

    3 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    20 páginasAA

    Cese del nombramiento de David Long como director

    1 páginasTM01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Déclaration annuelle établie au 28 feb 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Nombramiento de Paul Edward Hare como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Kevin Studd como director

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Costas Michaelides el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Costas Michaelides el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director David Long el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Paul Edward Hare el 01 oct 2009

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Kevin Lester Studd el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2008

    21 páginasAA

    legacy

    5 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2007

    21 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    3 páginas288a

    Resoluciones

    Resolutions
    9 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum y/o Artículos de Asociación

    RES01

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2006

    20 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HARE, Paul Edward
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    United Kingdom
    Secretario
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    United Kingdom
    British23220350004
    ALIKER, Susannah Louise
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    1
    Director
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    1
    United KingdomBritish99766410001
    HARE, Paul Edward
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    Director
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    United KingdomBritish23220350004
    MICHAELIDES, Costas, Chair Of The Board Of Directors
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    United Kingdom
    Director
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    United Kingdom
    United KingdomAmerican,Cypriot73091230001
    HARRIMAN, John Patrick William
    Flat 3 6 Tedworth Square
    SW3 4DY London
    Secretario
    Flat 3 6 Tedworth Square
    SW3 4DY London
    British49828030001
    HORNSEY, Nicholas John
    Eremue
    8 The Avenue
    TW12 3RS Hampton
    Middlesex
    Secretario
    Eremue
    8 The Avenue
    TW12 3RS Hampton
    Middlesex
    British50650950002
    SIEGLER, Thomas Edmund
    39 Wildwood Drive
    Dix Hills
    New York 11746
    Usa
    Secretario
    39 Wildwood Drive
    Dix Hills
    New York 11746
    Usa
    American47358850001
    AITCHINSON, Carolyn Jane
    126 Palace Gardens Terrace
    W8 4RT London
    Director
    126 Palace Gardens Terrace
    W8 4RT London
    British62873110004
    ALEXANDRE, James Lawrence
    33 Blomfield Road
    W9 1AA London
    Director
    33 Blomfield Road
    W9 1AA London
    American63091430001
    BRETTON, Nigel Paul
    Blue Clay
    33 Rose Walk
    AL4 9AA St Albans
    Hertfordshire
    Director
    Blue Clay
    33 Rose Walk
    AL4 9AA St Albans
    Hertfordshire
    British75188550001
    BURROWES, Kevin James
    Samuelson House
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LP Cobham
    Surrey
    Director
    Samuelson House
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LP Cobham
    Surrey
    British105411790001
    CATANIA, Alejandro Miguel
    90 Palace Gardens Terrace
    W8 4RF London
    Director
    90 Palace Gardens Terrace
    W8 4RF London
    Itialian74299160001
    DISLEY, Kevin John
    18 Larksway
    CM23 4DG Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Director
    18 Larksway
    CM23 4DG Bishops Stortford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish147923330001
    GORMLEY, Peter Vincent
    Pinehill
    Sunning Avenue
    SL5 9PW Sunningdale
    Berkshire
    Director
    Pinehill
    Sunning Avenue
    SL5 9PW Sunningdale
    Berkshire
    Usa52530740001
    GREEN, Darryl John
    Wychden
    Wildernesse Avenue
    TN15 0EA Sevenoaks
    Kent
    Director
    Wychden
    Wildernesse Avenue
    TN15 0EA Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish60672010001
    HALE, Charles Martin
    33 Lyall Mews
    SW1X 8DJ London
    Director
    33 Lyall Mews
    SW1X 8DJ London
    United KingdomBritish105772830001
    HARRIMAN, John Patrick William
    Flat 3 6 Tedworth Square
    SW3 4DY London
    Director
    Flat 3 6 Tedworth Square
    SW3 4DY London
    British49828030001
    HART, Mark
    39 Gilhams Avenue
    SM7 1QW Banstead
    Surrey
    Director
    39 Gilhams Avenue
    SM7 1QW Banstead
    Surrey
    British67366820001
    HIARD, Michael Henry
    Foxes
    High Wych Road
    CM21 OHH Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Director
    Foxes
    High Wych Road
    CM21 OHH Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    British18403810002
    HOHMANN III, Frank Lynn
    242 Hendrickson Drive
    Princeton Junction
    New Jersey 08550
    Usa
    Director
    242 Hendrickson Drive
    Princeton Junction
    New Jersey 08550
    Usa
    American33491720001
    KAWKABANI, Nagi Robert
    47 Lennox Gardens
    SW1 London
    Director
    47 Lennox Gardens
    SW1 London
    United KingdomCanadian33491730003
    LONG, David
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    United Kingdom
    Director
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    United Kingdom
    United KingdomBritish126956520001
    MASMEJEAN, Pierre Olivier
    66 Redcliffe Road
    SW10 9NQ London
    Director
    66 Redcliffe Road
    SW10 9NQ London
    French49032650001
    PETRILLI, Anthony Mario
    18 Icklingham Road
    KT11 2NQ Cobham
    Surrey
    Director
    18 Icklingham Road
    KT11 2NQ Cobham
    Surrey
    British54390740001
    PIKE, Catherine Elizabeth
    75 Noel Road
    N1 8HE London
    Director
    75 Noel Road
    N1 8HE London
    British45313610002
    RATTNER, Steven Charles
    408 Grace Church Street
    Rye
    New York
    Ny 10580
    Usa
    Director
    408 Grace Church Street
    Rye
    New York
    Ny 10580
    Usa
    American70635020001
    ROBINSON, Nicholas Ian
    Beechwood Little Orchards
    Salvington Hill
    BN13 3BD Worthing
    West Sussex
    Director
    Beechwood Little Orchards
    Salvington Hill
    BN13 3BD Worthing
    West Sussex
    British44793820001
    ROE, Steven Robin Charles
    10 Eastwood
    Bridgewater Road
    KT13 0EG Weybridge
    Surrey
    Director
    10 Eastwood
    Bridgewater Road
    KT13 0EG Weybridge
    Surrey
    British34616850002
    SANTS, Hector William Hepburn
    Court Farm
    Worminghall
    HP18 9LD Aylesbury
    Buckinghamshire
    Director
    Court Farm
    Worminghall
    HP18 9LD Aylesbury
    Buckinghamshire
    British1576920001
    SEET, Joe Lip Poh
    6 Padbrook
    RH8 0DW Oxted
    Surrey
    Director
    6 Padbrook
    RH8 0DW Oxted
    Surrey
    British52359050001
    SMITH, Martin, Sir
    4 Essex Villas
    W8 7BN London
    Director
    4 Essex Villas
    W8 7BN London
    United KingdomBritish35552480001
    STUDD, Kevin Lester
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    United Kingdom
    Director
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    United Kingdom
    United KingdomBritish86302520001
    WRIGHT, Geraldine Helen
    30 High Gables
    1 Scotts Avenue
    BR2 0NB Bromley
    Kent
    Director
    30 High Gables
    1 Scotts Avenue
    BR2 0NB Bromley
    Kent
    British83599210001

    ¿Tiene DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Collateral agreement governing secured borrowings by participants in the euroclear system
    Creado el 06 sept 1996
    Entregado el 11 sept 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All borrowings (meaning overdraft, fixed term advances or securities borrowing, or any other extension of credit by morgan guaranty trust company of new york to the borrower, in whatever form, that relates to or results from the borrower's use of the euroclear system, as well as any fees or accrued interest with respect thereto), and other obligations, in whatever form, that relate to or result from the borrower's use of the euroclear system, now outstanding or which may be outstanding at any time in the future to morgan guaranty brussels and to any other office of morgan guaranty trust company of new york
    Breve descripción
    All "collateral" including in particular cash and securities clearance accounts opened in connection with the euroclear system by the brussels office of morgan guaranty on its books in the name of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transacciones
    • 11 sept 1996Registro de un cargo (395)
    • 23 jul 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 22 sept 1992
    Entregado el 07 oct 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    All shares, stock and other securities of any description which are for the time being designated by the stock exchange as talisman securities, together with all benefits arising therefrom and not transferred or delivered by or at the direction of the stock exchange to the company.
    Personas con derecho
    • The International Stock Exchange of the United Kingdom and Republic of Ireland Limited
    Transacciones
    • 07 oct 1992Registro de un cargo (395)
    • 07 sept 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0