NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD.

NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD.

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaNEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD.
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02475402
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD.?

    • (7222) /

    ¿Dónde se encuentra NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD.?

    Dirección de la sede social
    2nd Floor
    79 Knightsbridge
    SW1X 7RB London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD.?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CAMBRIDGE ANIMATION SYSTEMS LIMITED22 mar 199022 mar 1990
    FELTONIAN LIMITED28 feb 199028 feb 1990

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD.?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2008

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD.?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 jun 2008

    9 páginasAA

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 jun 2007

    7 páginasAA

    legacy

    8 páginas363a

    legacy

    6 páginas363a

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed cambridge animation systems LIMITED\certificate issued on 19/01/09
    3 páginasCERTNM

    Resumen de ingresos y gastos del supervisor del acuerdo voluntario hasta 08 ene 2009

    2 páginas1.3

    Notificación de finalización del acuerdo voluntario

    5 páginas1.4

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas403a

    legacy

    2 páginas403a

    Resumen de ingresos y gastos del supervisor del acuerdo voluntario hasta 22 sept 2008

    9 páginas1.3

    Resumen de ingresos y gastos del supervisor del acuerdo voluntario hasta 22 sept 2007

    10 páginas1.3

    legacy

    7 páginas363s

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 jun 2006

    9 páginasAA

    Misceláneos

    Supervisor's report
    5 páginasMISC

    Resumen de ingresos y gastos del supervisor del acuerdo voluntario hasta 22 sept 2006

    2 páginas1.3

    legacy

    7 páginas363s

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 jun 2005

    11 páginasAA

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    2 páginas288b

    Resumen de ingresos y gastos del supervisor del acuerdo voluntario hasta 22 sept 2005

    3 páginas1.3

    ¿Quiénes son los directivos de NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD.?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PS LAW SECRETARIES LIMITED
    Knightsbridge
    SW1X 7RB London
    79
    Secretario corporativo
    Knightsbridge
    SW1X 7RB London
    79
    81576980001
    SLEVIN, Cormac Brian
    62 Brampton Road
    CB1 3HL Cambridge
    Cambridgeshire
    Director
    62 Brampton Road
    CB1 3HL Cambridge
    Cambridgeshire
    Irish98972470001
    FLORENCE, Peter Charles
    34 Grafton Street
    CB1 1DS Cambridge
    Secretario
    34 Grafton Street
    CB1 1DS Cambridge
    British50715100001
    HOLLAND, Stephen John William
    35 Woodlands Park
    CB3 0QB Girton
    Cambridgeshire
    Secretario
    35 Woodlands Park
    CB3 0QB Girton
    Cambridgeshire
    British79873930001
    MCCALL, Ruth
    18 Milman Road
    Queens Park
    NW6 6EJ London
    Secretario
    18 Milman Road
    Queens Park
    NW6 6EJ London
    British51783880001
    O'CONNOR, Christopher Patrick, Mr.
    Willow Cottage
    School Lane
    CB23 4ND Boxworth
    Cambridgeshire
    Secretario
    Willow Cottage
    School Lane
    CB23 4ND Boxworth
    Cambridgeshire
    British3751430003
    SHIRREN, Gerry
    Kiltale
    IRISH Dunsany
    Co Meath
    Ireland
    Secretario
    Kiltale
    IRISH Dunsany
    Co Meath
    Ireland
    Irish97685400001
    VIS, Annemarie Mirjam Frederique
    37 Martingale Close
    CB4 3TA Cambridge
    Secretario
    37 Martingale Close
    CB4 3TA Cambridge
    British52939100001
    WOOLLEY, Alastair John Lomond
    Charity Farmhouse
    Brinkley
    CB8 0SE Newmarket
    Suffolk
    Secretario
    Charity Farmhouse
    Brinkley
    CB8 0SE Newmarket
    Suffolk
    British89506550001
    PS LAW SECRETARIES LIMITED
    2nd Floor
    79 Knightsbridge
    SW1X 7RB London
    Secretario corporativo
    2nd Floor
    79 Knightsbridge
    SW1X 7RB London
    81576980001
    ABBOTT, Raymond James
    44 Coillesdene Avenue
    EH15 2JR Edinburgh
    Director
    44 Coillesdene Avenue
    EH15 2JR Edinburgh
    British65699620002
    BAHNS, Robert Harold
    40a Parkhill Road
    NW3 2YP London
    Director
    40a Parkhill Road
    NW3 2YP London
    British64794090001
    BARRETT, Philip James, Dr
    16 Kings Road
    PE19 1LD St. Neots
    Cambridgeshire
    Director
    16 Kings Road
    PE19 1LD St. Neots
    Cambridgeshire
    EnglandBritish198025600001
    BEREND, Andrew Louis Charles
    145 King Henrys Road
    NW3 3RD London
    Director
    145 King Henrys Road
    NW3 3RD London
    British24724970005
    CARRIGAN, Thomas Jay
    464 Notre Dame Road
    91711 Claremont
    Los Angeles
    Usa
    Director
    464 Notre Dame Road
    91711 Claremont
    Los Angeles
    Usa
    American60077320001
    FERRIS, Gavin Robert, Dr
    29c Shanrod Road
    Katebridge
    BT32 5PG Banbridge
    County Down
    Northern Ireland
    Director
    29c Shanrod Road
    Katebridge
    BT32 5PG Banbridge
    County Down
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish107911580001
    FLORENCE, Peter Charles
    34 Mornington Crescent
    NW1 7RE London
    Director
    34 Mornington Crescent
    NW1 7RE London
    United KingdomBritish50715100002
    FLORENCE, Peter Charles
    34 Grafton Street
    CB1 1DS Cambridge
    Director
    34 Grafton Street
    CB1 1DS Cambridge
    British50715100001
    HAYMAN, Anne Carolyn
    36 Lawford Road
    NW5 2LN London
    Director
    36 Lawford Road
    NW5 2LN London
    EnglandBritish32391350001
    HOLLAND, Stephen John William
    35 Woodlands Park
    CB3 0QB Girton
    Cambridgeshire
    Director
    35 Woodlands Park
    CB3 0QB Girton
    Cambridgeshire
    British79873930001
    JACKSON, John Bernard Haysom
    Summit House
    Red Lion Square
    WC1R 4QB London
    Director
    Summit House
    Red Lion Square
    WC1R 4QB London
    United KingdomBritish98731480001
    KELLY, William
    10 Peak Lane
    Portola Valley
    94028 California
    Usa
    Director
    10 Peak Lane
    Portola Valley
    94028 California
    Usa
    American46464350001
    KORDA, Alexander Vincent
    Flat 7 8 St Quintin Avenue
    W10 6NU London
    Director
    Flat 7 8 St Quintin Avenue
    W10 6NU London
    United KingdomBritish110996140001
    MCCALL, Ruth
    18 Milman Road
    Queens Park
    NW6 6EJ London
    Director
    18 Milman Road
    Queens Park
    NW6 6EJ London
    British51783880001
    MITCHELL, John Ross, Dr
    123a London Road
    SG18 8EF Biggleswade
    Bedfordshire
    Director
    123a London Road
    SG18 8EF Biggleswade
    Bedfordshire
    British54883260001
    O'CONNOR, Christopher Patrick, Mr.
    Willow Cottage
    School Lane
    CB23 4ND Boxworth
    Cambridgeshire
    Director
    Willow Cottage
    School Lane
    CB23 4ND Boxworth
    Cambridgeshire
    EnglandBritish3751430003
    OSBORN, Peter Gordon
    Northchurch Farm Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Director
    Northchurch Farm Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    British28389710001
    PETTMAN, Michael George
    The Ranch
    High Street
    SL6 5LT Hurley
    Bucks
    Director
    The Ranch
    High Street
    SL6 5LT Hurley
    Bucks
    British23702430001
    RAMSAY, Michael
    13060 Alta Lane North
    Los Altos Hills
    California 94022
    Usa
    Director
    13060 Alta Lane North
    Los Altos Hills
    California 94022
    Usa
    UsaBritish72705850001
    SCOGGINS, Ian Maxwell
    High Thicket
    Dockenfield
    GU10 4HB Farnham
    Surrey
    Director
    High Thicket
    Dockenfield
    GU10 4HB Farnham
    Surrey
    British54583190001
    SOMPER, Nicholas John
    55 Brookland Rise
    NW11 6DT London
    Director
    55 Brookland Rise
    NW11 6DT London
    British59505050001
    STEEL, Andrew Dewar
    Flat 2 3 Dean Path
    EH4 3BG Edinburgh
    Midlothian
    Director
    Flat 2 3 Dean Path
    EH4 3BG Edinburgh
    Midlothian
    British14788330002
    SWINSTEAD, Philip Edgar
    Flat 5
    60-61 Cheyne Walk
    SW3 5LX London
    Director
    Flat 5
    60-61 Cheyne Walk
    SW3 5LX London
    British101634050001
    TYLER, Brian David
    64 Cavendish Avenue
    CB1 7UT Cambridge
    Cambridgeshire
    Director
    64 Cavendish Avenue
    CB1 7UT Cambridge
    Cambridgeshire
    EnglandBritish76611270001
    WATT, Mark
    14 Beaufort Place
    Thompsons Lane
    CB5 8AG Cambridge
    Cambridgeshire
    Director
    14 Beaufort Place
    Thompsons Lane
    CB5 8AG Cambridge
    Cambridgeshire
    British56960450001

    ¿Tiene NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD. alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 11 abr 2001
    Entregado el 18 abr 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 18 abr 2001Registro de un cargo (395)
    • 03 dic 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 13 mar 1997
    Entregado el 19 mar 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 13TH march 1997 and the debenture
    Breve descripción
    All of the assets and undertakings of the company except interest in leaseholds as at 13/3/97; shares in animax animation consortium limited and charges in respect of rent deposits not exceeding £50,000.
    Personas con derecho
    • Ivory & Sime Enterprise Capital PLC
    Transacciones
    • 19 mar 1997Registro de un cargo (395)
    • 05 sept 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creado el 11 mar 1997
    Entregado el 28 mar 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £3,000 due from the company to the chargee
    Breve descripción
    £3,000 plus interest.
    Personas con derecho
    • Leonard Robert Martin
    Transacciones
    • 28 mar 1997Registro de un cargo (395)
    • 31 mar 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of rent deposit
    Creado el 14 sept 1995
    Entregado el 15 sept 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease made 14TH september 1995
    Breve descripción
    The sum of £8,800.00 being the initial deposit placed in a deposit account by cambridge homes limited under the terms of the deed.
    Personas con derecho
    • Cambridge Homes Limited
    Transacciones
    • 15 sept 1995Registro de un cargo (395)
    • 31 mar 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Convertible loan stock debenture
    Creado el 16 feb 1994
    Entregado el 19 feb 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £50,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland (Stanlife) London Nominees Limited
    Transacciones
    • 19 feb 1994Registro de un cargo (395)
    • 11 ago 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Convertible loan stock debenture
    Creado el 16 feb 1994
    Entregado el 19 feb 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £20,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Monument Trust Company Limited
    Transacciones
    • 19 feb 1994Registro de un cargo (395)
    • 11 ago 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Convertible loan stock debenture
    Creado el 16 feb 1994
    Entregado el 19 feb 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £55,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Ivory & Sime Enterprise Capital PLC
    Transacciones
    • 19 feb 1994Registro de un cargo (395)
    • 11 ago 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Convertible loan stock debenture
    Creado el 16 feb 1994
    Entregado el 19 feb 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £5,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • John Jackson
    Transacciones
    • 19 feb 1994Registro de un cargo (395)
    • 11 ago 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Convertible loan stock debenture
    Creado el 16 feb 1994
    Entregado el 19 feb 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £5,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Colin West
    Transacciones
    • 19 feb 1994Registro de un cargo (395)
    • 11 ago 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Convertible loan stock debenture
    Creado el 16 feb 1994
    Entregado el 19 feb 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £15,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Walbrook Trustees (Guernsey) Limited
    Transacciones
    • 19 feb 1994Registro de un cargo (395)
    • 11 ago 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Convertible loan stock debenture
    Creado el 16 feb 1994
    Entregado el 19 feb 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £50,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Korda Seed Capital Fund Limited Partnership
    Transacciones
    • 19 feb 1994Registro de un cargo (395)
    • 11 ago 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 07 jul 1993
    Entregado el 20 jul 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 20 jul 1993Registro de un cargo (395)
    • 31 mar 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creado el 18 sept 1992
    Entregado el 26 sept 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease of even date and this charge
    Breve descripción
    £14,900 and any other amount standing to the credit of the account.
    Personas con derecho
    • The Oceana Consolidated Company PLC
    Transacciones
    • 26 sept 1992Registro de un cargo (395)
    • 03 dic 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD. algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    23 sept 2002Fecha de la reunión para aprobar el CVA
    08 ene 2009Fecha de finalización o terminación del CVA
    Acuerdo voluntario de reestructuración empresarial (CVA)
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    James Alfred Lettice
    Peters Elworthy & Moore
    Salisbury House
    CB1 2LA Station Road
    Cambridge
    Profesional
    Peters Elworthy & Moore
    Salisbury House
    CB1 2LA Station Road
    Cambridge

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0