BRITISH COMMERCIAL VEHICLE MUSEUM TRUST
Visión general
| Nombre de la empresa | BRITISH COMMERCIAL VEHICLE MUSEUM TRUST |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited' |
| Número de empresa | 02475754 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BRITISH COMMERCIAL VEHICLE MUSEUM TRUST?
- Educación cultural (85520) / Educación
- Actividades de archivos (91012) / Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
- Actividades de museos (91020) / Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
¿Dónde se encuentra BRITISH COMMERCIAL VEHICLE MUSEUM TRUST?
| Dirección de la sede social | King Street Leyland PR25 2LE Preston Lancashire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BRITISH COMMERCIAL VEHICLE MUSEUM TRUST?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| LEYLAND DAF HERITAGE TRUST | 01 mar 1990 | 01 mar 1990 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BRITISH COMMERCIAL VEHICLE MUSEUM TRUST?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para BRITISH COMMERCIAL VEHICLE MUSEUM TRUST?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 02 oct 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 16 oct 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 02 oct 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BRITISH COMMERCIAL VEHICLE MUSEUM TRUST?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 02 oct 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr Bharath Ramaswamy el 25 abr 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 18 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de David Mitchell como director el 03 oct 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Keith James Ellison como director el 03 oct 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 02 oct 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de John Patterson Gilchrist como director el 18 sept 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Andrea Louise Mayo como director el 18 sept 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Bharath Ramaswamy como director el 18 sept 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 18 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de William Gerard Robinson como director el 14 mar 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Timothy John Haley como secretario el 14 mar 2024 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de William Gerard Robinson como secretario el 14 mar 2024 | 1 páginas | TM02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 02 oct 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Peter George Jukes como director el 31 may 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 18 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 02 oct 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr John Patterson Gilchrist el 03 oct 2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 18 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Robert Keith Moyes como director el 01 ago 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr John Geoffrey Southworth como director el 24 feb 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Keith James Ellison como director el 24 feb 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 02 oct 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 19 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Robert Keith Moyes como director el 22 jun 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de BRITISH COMMERCIAL VEHICLE MUSEUM TRUST?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALEY, Timothy John | Secretario | Lower Bank Road Fulwood PR2 8NT Preston 51 England | 320679020001 | |||||||
| BENNETT, David Harvey | Director | Crimble House Bryning PR4 3PP Preston Lancashire | England | British | 27267600002 | |||||
| FORREST, Derek Bradshaw, Councillor | Director | Wigan Road PR25 5SD Leyland Egremont England | England | British | 260735230002 | |||||
| HALEY, Timothy John | Director | Lower Bank Road Fulwood PR2 8NT Preston 51 England | England | British | 55978030001 | |||||
| JUKES, Peter George | Director | King Street Leyland PR25 2LE Preston Lancashire | England | British | 314095270001 | |||||
| MAYO, Andrea Louise | Director | King Street Leyland PR25 2LE Preston Lancashire | England | British | 327846910001 | |||||
| MCKEVITT, Joseph Anthony | Director | King Street Leyland PR25 2LE Preston Lancashire | England | British | 177146590001 | |||||
| MELIA, Christine Lesley | Director | Sterndale Road S7 2LB Sheffield 27 England | England | British | 219563770001 | |||||
| RAMASWAMY, Bharath | Director | King Street Leyland PR25 2LE Preston Lancashire | England | Indian | 327846770002 | |||||
| ROBERTON, Clive | Director | King Street Leyland PR25 2LE Preston Lancashire | England | British | 14452690001 | |||||
| SOUTHWORTH, John Geoffrey | Director | King Street Leyland PR25 2LE Preston Lancashire | England | British | 293112260001 | |||||
| BUCHAN, Andrew Murray | Secretario | 2 Kettering Road Ainsdale PR8 2PS Southport Merseyside | British | 41737710001 | ||||||
| MOYES, Robert Keith | Secretario | King Street Leyland PR25 2LE Preston Lancashire | 219988200001 | |||||||
| ROBINSON, William Gerard | Secretario | Rydal Avenue FY6 7DJ Poulton-Le-Fylde 29 Lancashire England | 265593480001 | |||||||
| ROBINSON, William Gerard | Secretario | 29 Rydal Avenue FY6 7DJ Poulton Le Fylde Lancashire | British | 34382530001 | ||||||
| ABEL, George Stephen | Director | Bon Accord Cuddington Court Cuddington HP18 0DT Aylesbury Bucks | United Kingdom | British | 1284410002 | |||||
| ALDRIDGE, John Michael | Director | 62 Hartley Down CR8 4EB Purley Surrey | England | British | 18998900001 | |||||
| BARON, Gordon | Director | 44 Rhoslan Park Conway Road LL29 7HR Colwyn Bay Clwyd | Wales | British | 42869120002 | |||||
| BEADNELL, William | Director | Ox Hill Farm Whinney Hill TS21 1BW Stockton On Tees Cleveland | England | British | 18998910001 | |||||
| BENSON, Dennis Melvyn | Director | 6 Balmoral Road PR7 1LQ Chorley Lancashire | England | British | 7539680001 | |||||
| BOWKER, William Henry | Director | Talbot Street Chipping PR3 2QE Preston Mill Barn England | England | British | 11851260005 | |||||
| BOWKER, William Henry | Director | Mill Barn Green Lane Chipping PR7 2TQ Preston | England | British | 11851260005 | |||||
| BUCHAN, Andrew Murray | Director | 2 Kettering Road Ainsdale PR8 2PS Southport Merseyside | England | British | 41737710001 | |||||
| BULLOCK, Stephen Frederick Richard | Director | 28 Wyresdale Drive PR25 3DR Leyland Lancashire | England | British | 126161570001 | |||||
| DAWSON, Alan James | Director | 40 Church Road Leyland PR5 2AA Preston | British | 46024050001 | ||||||
| ELLISON, Keith James | Director | King Street Leyland PR25 2LE Preston Lancashire | England | British | 69366070001 | |||||
| EVANS, William, Councillor | Director | 28 Leadale Road Leyland PR5 1QQ Preston Lancashire | British | 71166590001 | ||||||
| GILCHRIST, John Patterson | Director | 23 Seafield Road FY8 5PY Lytham St. Annes Apartment 8 Seafield House England | England | British | 15507930002 | |||||
| GILL, David Anthony | Director | 8 Thornhill Crescent N1 1BL London | British | 21453980001 | ||||||
| GORE, Howard William, Councillor | Director | 24 Stone Croft Penwortham PR1 9EX Preston Lancashire | British | 69783470002 | ||||||
| HAWORTH, Robert | Director | 67 Kingsway Penwortham PR1 0ED Preston | British | 34382520001 | ||||||
| HAYES, Martin Charles | Director | Greentop Holmesdale Road Kew TW9 3JZ Richmond Surrey | United Kingdom | British | 30110050001 | |||||
| MACKENZIE, Alec | Director | 1 Overford Drive GU6 8BJ Cranleigh Surrey | United Kingdom | British | 46297920001 | |||||
| MILLER, Christopher | Director | King Street Leyland PR25 2LE Preston Lancashire | England | British | 4066630001 | |||||
| MITCHELL, David | Director | 23 Applecross Drive Deerpark BB10 4JP Burnley Lancashire | England | British | 43392680001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para BRITISH COMMERCIAL VEHICLE MUSEUM TRUST?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 02 oct 2016 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0