BRITISH COMMERCIAL VEHICLE MUSEUM TRUST

BRITISH COMMERCIAL VEHICLE MUSEUM TRUST

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBRITISH COMMERCIAL VEHICLE MUSEUM TRUST
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited'
    Número de empresa 02475754
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BRITISH COMMERCIAL VEHICLE MUSEUM TRUST?

    • Educación cultural (85520) / Educación
    • Actividades de archivos (91012) / Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
    • Actividades de museos (91020) / Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento

    ¿Dónde se encuentra BRITISH COMMERCIAL VEHICLE MUSEUM TRUST?

    Dirección de la sede social
    King Street
    Leyland
    PR25 2LE Preston
    Lancashire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BRITISH COMMERCIAL VEHICLE MUSEUM TRUST?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    LEYLAND DAF HERITAGE TRUST01 mar 199001 mar 1990

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BRITISH COMMERCIAL VEHICLE MUSEUM TRUST?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2025
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para BRITISH COMMERCIAL VEHICLE MUSEUM TRUST?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta02 oct 2026
    Próxima declaración de confirmación vence16 oct 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta02 oct 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BRITISH COMMERCIAL VEHICLE MUSEUM TRUST?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Declaración de confirmación presentada el 02 oct 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mr Bharath Ramaswamy el 25 abr 2025

    2 páginasCH01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2024

    18 páginasAA

    Cese del nombramiento de David Mitchell como director el 03 oct 2024

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Keith James Ellison como director el 03 oct 2024

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 02 oct 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de John Patterson Gilchrist como director el 18 sept 2024

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Andrea Louise Mayo como director el 18 sept 2024

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Bharath Ramaswamy como director el 18 sept 2024

    2 páginasAP01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2023

    18 páginasAA

    Cese del nombramiento de William Gerard Robinson como director el 14 mar 2024

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Timothy John Haley como secretario el 14 mar 2024

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de William Gerard Robinson como secretario el 14 mar 2024

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 02 oct 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Peter George Jukes como director el 31 may 2022

    2 páginasAP01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2022

    18 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 02 oct 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mr John Patterson Gilchrist el 03 oct 2021

    2 páginasCH01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2021

    18 páginasAA

    Cese del nombramiento de Robert Keith Moyes como director el 01 ago 2022

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr John Geoffrey Southworth como director el 24 feb 2022

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Keith James Ellison como director el 24 feb 2022

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 02 oct 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2020

    19 páginasAA

    Nombramiento de Mr Robert Keith Moyes como director el 22 jun 2021

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de BRITISH COMMERCIAL VEHICLE MUSEUM TRUST?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HALEY, Timothy John
    Lower Bank Road
    Fulwood
    PR2 8NT Preston
    51
    England
    Secretario
    Lower Bank Road
    Fulwood
    PR2 8NT Preston
    51
    England
    320679020001
    BENNETT, David Harvey
    Crimble House
    Bryning
    PR4 3PP Preston
    Lancashire
    Director
    Crimble House
    Bryning
    PR4 3PP Preston
    Lancashire
    EnglandBritish27267600002
    FORREST, Derek Bradshaw, Councillor
    Wigan Road
    PR25 5SD Leyland
    Egremont
    England
    Director
    Wigan Road
    PR25 5SD Leyland
    Egremont
    England
    EnglandBritish260735230002
    HALEY, Timothy John
    Lower Bank Road
    Fulwood
    PR2 8NT Preston
    51
    England
    Director
    Lower Bank Road
    Fulwood
    PR2 8NT Preston
    51
    England
    EnglandBritish55978030001
    JUKES, Peter George
    King Street
    Leyland
    PR25 2LE Preston
    Lancashire
    Director
    King Street
    Leyland
    PR25 2LE Preston
    Lancashire
    EnglandBritish314095270001
    MAYO, Andrea Louise
    King Street
    Leyland
    PR25 2LE Preston
    Lancashire
    Director
    King Street
    Leyland
    PR25 2LE Preston
    Lancashire
    EnglandBritish327846910001
    MCKEVITT, Joseph Anthony
    King Street
    Leyland
    PR25 2LE Preston
    Lancashire
    Director
    King Street
    Leyland
    PR25 2LE Preston
    Lancashire
    EnglandBritish177146590001
    MELIA, Christine Lesley
    Sterndale Road
    S7 2LB Sheffield
    27
    England
    Director
    Sterndale Road
    S7 2LB Sheffield
    27
    England
    EnglandBritish219563770001
    RAMASWAMY, Bharath
    King Street
    Leyland
    PR25 2LE Preston
    Lancashire
    Director
    King Street
    Leyland
    PR25 2LE Preston
    Lancashire
    EnglandIndian327846770002
    ROBERTON, Clive
    King Street
    Leyland
    PR25 2LE Preston
    Lancashire
    Director
    King Street
    Leyland
    PR25 2LE Preston
    Lancashire
    EnglandBritish14452690001
    SOUTHWORTH, John Geoffrey
    King Street
    Leyland
    PR25 2LE Preston
    Lancashire
    Director
    King Street
    Leyland
    PR25 2LE Preston
    Lancashire
    EnglandBritish293112260001
    BUCHAN, Andrew Murray
    2 Kettering Road
    Ainsdale
    PR8 2PS Southport
    Merseyside
    Secretario
    2 Kettering Road
    Ainsdale
    PR8 2PS Southport
    Merseyside
    British41737710001
    MOYES, Robert Keith
    King Street
    Leyland
    PR25 2LE Preston
    Lancashire
    Secretario
    King Street
    Leyland
    PR25 2LE Preston
    Lancashire
    219988200001
    ROBINSON, William Gerard
    Rydal Avenue
    FY6 7DJ Poulton-Le-Fylde
    29
    Lancashire
    England
    Secretario
    Rydal Avenue
    FY6 7DJ Poulton-Le-Fylde
    29
    Lancashire
    England
    265593480001
    ROBINSON, William Gerard
    29 Rydal Avenue
    FY6 7DJ Poulton Le Fylde
    Lancashire
    Secretario
    29 Rydal Avenue
    FY6 7DJ Poulton Le Fylde
    Lancashire
    British34382530001
    ABEL, George Stephen
    Bon Accord Cuddington Court
    Cuddington
    HP18 0DT Aylesbury
    Bucks
    Director
    Bon Accord Cuddington Court
    Cuddington
    HP18 0DT Aylesbury
    Bucks
    United KingdomBritish1284410002
    ALDRIDGE, John Michael
    62 Hartley Down
    CR8 4EB Purley
    Surrey
    Director
    62 Hartley Down
    CR8 4EB Purley
    Surrey
    EnglandBritish18998900001
    BARON, Gordon
    44 Rhoslan Park
    Conway Road
    LL29 7HR Colwyn Bay
    Clwyd
    Director
    44 Rhoslan Park
    Conway Road
    LL29 7HR Colwyn Bay
    Clwyd
    WalesBritish42869120002
    BEADNELL, William
    Ox Hill Farm
    Whinney Hill
    TS21 1BW Stockton On Tees
    Cleveland
    Director
    Ox Hill Farm
    Whinney Hill
    TS21 1BW Stockton On Tees
    Cleveland
    EnglandBritish18998910001
    BENSON, Dennis Melvyn
    6 Balmoral Road
    PR7 1LQ Chorley
    Lancashire
    Director
    6 Balmoral Road
    PR7 1LQ Chorley
    Lancashire
    EnglandBritish7539680001
    BOWKER, William Henry
    Talbot Street
    Chipping
    PR3 2QE Preston
    Mill Barn
    England
    Director
    Talbot Street
    Chipping
    PR3 2QE Preston
    Mill Barn
    England
    EnglandBritish11851260005
    BOWKER, William Henry
    Mill Barn
    Green Lane Chipping
    PR7 2TQ Preston
    Director
    Mill Barn
    Green Lane Chipping
    PR7 2TQ Preston
    EnglandBritish11851260005
    BUCHAN, Andrew Murray
    2 Kettering Road
    Ainsdale
    PR8 2PS Southport
    Merseyside
    Director
    2 Kettering Road
    Ainsdale
    PR8 2PS Southport
    Merseyside
    EnglandBritish41737710001
    BULLOCK, Stephen Frederick Richard
    28 Wyresdale Drive
    PR25 3DR Leyland
    Lancashire
    Director
    28 Wyresdale Drive
    PR25 3DR Leyland
    Lancashire
    EnglandBritish126161570001
    DAWSON, Alan James
    40 Church Road
    Leyland
    PR5 2AA Preston
    Director
    40 Church Road
    Leyland
    PR5 2AA Preston
    British46024050001
    ELLISON, Keith James
    King Street
    Leyland
    PR25 2LE Preston
    Lancashire
    Director
    King Street
    Leyland
    PR25 2LE Preston
    Lancashire
    EnglandBritish69366070001
    EVANS, William, Councillor
    28 Leadale Road
    Leyland
    PR5 1QQ Preston
    Lancashire
    Director
    28 Leadale Road
    Leyland
    PR5 1QQ Preston
    Lancashire
    British71166590001
    GILCHRIST, John Patterson
    23 Seafield Road
    FY8 5PY Lytham St. Annes
    Apartment 8 Seafield House
    England
    Director
    23 Seafield Road
    FY8 5PY Lytham St. Annes
    Apartment 8 Seafield House
    England
    EnglandBritish15507930002
    GILL, David Anthony
    8 Thornhill Crescent
    N1 1BL London
    Director
    8 Thornhill Crescent
    N1 1BL London
    British21453980001
    GORE, Howard William, Councillor
    24 Stone Croft
    Penwortham
    PR1 9EX Preston
    Lancashire
    Director
    24 Stone Croft
    Penwortham
    PR1 9EX Preston
    Lancashire
    British69783470002
    HAWORTH, Robert
    67 Kingsway
    Penwortham
    PR1 0ED Preston
    Director
    67 Kingsway
    Penwortham
    PR1 0ED Preston
    British34382520001
    HAYES, Martin Charles
    Greentop Holmesdale Road
    Kew
    TW9 3JZ Richmond
    Surrey
    Director
    Greentop Holmesdale Road
    Kew
    TW9 3JZ Richmond
    Surrey
    United KingdomBritish30110050001
    MACKENZIE, Alec
    1 Overford Drive
    GU6 8BJ Cranleigh
    Surrey
    Director
    1 Overford Drive
    GU6 8BJ Cranleigh
    Surrey
    United KingdomBritish46297920001
    MILLER, Christopher
    King Street
    Leyland
    PR25 2LE Preston
    Lancashire
    Director
    King Street
    Leyland
    PR25 2LE Preston
    Lancashire
    EnglandBritish4066630001
    MITCHELL, David
    23 Applecross Drive
    Deerpark
    BB10 4JP Burnley
    Lancashire
    Director
    23 Applecross Drive
    Deerpark
    BB10 4JP Burnley
    Lancashire
    EnglandBritish43392680001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para BRITISH COMMERCIAL VEHICLE MUSEUM TRUST?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    02 oct 2016La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0