ONE STOP STORES TRUSTEE SERVICES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ONE STOP STORES TRUSTEE SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02477253 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ONE STOP STORES TRUSTEE SERVICES LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra ONE STOP STORES TRUSTEE SERVICES LIMITED?
| Dirección de la sede social | Apex Road Brownhills WS8 7HU Walsall West Midlands United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ONE STOP STORES TRUSTEE SERVICES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| T & S STORES TRUSTEE SERVICES LIMITED | 30 mar 1990 | 30 mar 1990 |
| RAPID 9840 LIMITED | 05 mar 1990 | 05 mar 1990 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ONE STOP STORES TRUSTEE SERVICES LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 28 feb 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 nov 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 22 feb 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para ONE STOP STORES TRUSTEE SERVICES LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 12 oct 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 26 oct 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 12 oct 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ONE STOP STORES TRUSTEE SERVICES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Nombramiento de Sharon Kyte como director el 01 may 2026 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 12 oct 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 22 feb 2025 | 4 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Mark Edward Everitt como director el 05 mar 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Paul Thompson como director el 06 feb 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Rachael Chard como director el 24 dic 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Stephanie Wood como director el 24 dic 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Robert John Welch como director el 17 dic 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 12 oct 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 24 feb 2024 | 4 páginas | AA | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 25 feb 2023 | 4 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 12 oct 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Robert John Welch como director el 04 nov 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Julian Lloyd Kirby como director el 04 nov 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Richard Turton como director el 04 nov 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Christopher James Cooper como director el 04 nov 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 12 oct 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 26 feb 2022 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 12 oct 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 27 feb 2021 | 3 páginas | AA | ||
Domicilio social registrado cambiado de Apex Road Brownhills Walsall West Midlands WS8 7TS a Apex Road Brownhills Walsall West Midlands WS8 7HU el 20 oct 2021 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 feb 2020 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 12 oct 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Zoe Eleanor Mathers como director el 23 dic 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 12 oct 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
¿Quiénes son los directivos de ONE STOP STORES TRUSTEE SERVICES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARD, Rachael | Director | Brownhills WS8 7HU Walsall Apex Road West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 310318620001 | |||||
| KYTE, Sharon | Director | Brownhills WS8 7HU Walsall Apex Road West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 256836140001 | |||||
| THOMPSON, Paul | Director | Brownhills WS8 7HU Walsall Apex Road West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 332267260001 | |||||
| WOOD, Stephanie | Director | Brownhills WS8 7HU Walsall Apex Road West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 254875550001 | |||||
| BROWN, David Richard | Secretario | Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Tesco House Herts | 196605830001 | |||||||
| COWELL, Martin William | Secretario | 32 Beverston Road Perton WV6 7UG Wolverhampton West Midlands | British | 1614020001 | ||||||
| DAVIES, Donna Mary | Secretario | Tyr Heol Llwydcoed CF44 0TW Aberdare Merrivale Mid Glamorgan | British | 137486150001 | ||||||
| DAVIS, Wendy Annabel | Secretario | Colchester Avenue Penylan CF23 9BP Cardiff 12 South Glamorgan | British | 131584670001 | ||||||
| DOLAN, Malcolm George | Secretario | 30 Ferndown Close Bloxwich WS3 3XH Walsall West Midlands | British | 73207060001 | ||||||
| DOLAN, Malcolm George | Secretario | 30 Ferndown Close Bloxwich WS3 3XH Walsall West Midlands | British | 73207060001 | ||||||
| HUGHES, David | Secretario | 26 Coed Glas Road Llanishen CF14 5EN Cardiff | British | 94913780002 | ||||||
| SANKAR, Nadine Amanda | Secretario | 90 Ebury Road WD17 2SB Watford | British | 72917320001 | ||||||
| AGER, Rowley Stuart | Director | Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | United Kingdom | British | 72555850002 | |||||
| BODDICE, Stephen | Director | Churchill Old Farm Churchill DY10 3LZ Kidderminster Worcestershire | United Kingdom | British | 1673770001 | |||||
| BURROWS, Patrick James | Director | Gardeners Cottage The Lordship SG10 6HN Much Hadham Hertfordshire | British | 86778310001 | ||||||
| COOPER, Christopher James | Director | Brownhills WS8 7HU Walsall Apex Road West Midlands United Kingdom | British | 100628710002 | ||||||
| COWELL, Martin William | Director | 32 Beverston Road Perton WV6 7UG Wolverhampton West Midlands | British | 1614020001 | ||||||
| CRELLIN, David | Director | 191 Worcester Road Hagley DY9 0PR Stourbridge West Midlands | British | 31677030002 | ||||||
| DOLAN, Malcolm George | Director | 30 Ferndown Close Bloxwich WS3 3XH Walsall West Midlands | United Kingdom | British | 73207060001 | |||||
| EVERITT, Mark Edward | Director | Brownhills WS8 7HU Walsall Apex Road West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 107529830027 | |||||
| HOLMES, Colin Peter | Director | 66 Tolmers Road EN6 4JY Cuffley Hertfordshire | United Kingdom | British | 86778500001 | |||||
| JACKSON, Alexander | Director | 9 Alderwood Grove Ramsbottom BL0 0HQ Bury Lancashire | British | 66683050001 | ||||||
| JACKSON, Peter | Director | 4 Ullswater Gardens DY6 8DR Kingswinford West Midlands | England | British | 16081550001 | |||||
| KIRBY, Julian Lloyd | Director | Nursling Industrial Estate S016 0P Southampton Canberra Road Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 226154180001 | |||||
| LEA, Nigel Ronald John | Director | Brownhills WS8 7TS Walsall Apex Road West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 162540280001 | |||||
| MATHERS, Zoe Eleanor | Director | Ingleby Barwick TS17 0QA Stockton On Tees Beckfields Avenue County Durham United Kingdom | United Kingdom | British | 226153460001 | |||||
| MCCAWLEY, Neil Michael Owen | Director | 11 Arlidge Crescent CV8 2NS Kenilworth Warwickshire | British | 100628660001 | ||||||
| MURRELLS, Steven Geoffrey | Director | Willow Farm Further Street CO10 5LD Assington Suffolk | British | 98194710001 | ||||||
| NEVILLE-ROLFE, Lucy Jeanne, Ms. | Director | New Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | United Kingdom | British | 148079740001 | |||||
| O'NEILL, William Patrick | Director | 2 Fledborough Road LS22 6AB Wetherby West Yorkshire | British | 81965860001 | ||||||
| REED, Anthony William | Director | Brownhills WS8 7TS Walsall Apex Road West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 160544960001 | |||||
| SCOTT, David | Director | Antigua Drive Lower Darwen BB3 0SF Blackburn 20 Lancs | England | British | 138527080001 | |||||
| SMITH, Ruston Arthur Mark | Director | Apex Road Brownhills WS8 7TS Walsall West Midlands | United Kingdom | British | 40685330007 | |||||
| SPIRES, Barry John | Director | 5 March Banks WS15 2SA Rugeley Staffordshire | British | 41587790001 | ||||||
| THRELFALL, Kevin Patrick | Director | Perton House Pattingham Road Perton WV6 7HD Wolverhampton West Midlands | England | British | 1614060001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ONE STOP STORES TRUSTEE SERVICES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Stop Stores Limited | 06 abr 2016 | Brownhills WS8 7HU Walsall Apex Road West Midlands United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0