PRC PUBLISHING LIMITED

PRC PUBLISHING LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPRC PUBLISHING LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02477813
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PRC PUBLISHING LIMITED?

    • Edición de libros (58110) / Información y comunicación

    ¿Dónde se encuentra PRC PUBLISHING LIMITED?

    Dirección de la sede social
    43 Great Ormond Street
    WC1N 3HZ London
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PRC PUBLISHING LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    THE PROMOTIONAL REPRINT COMPANY LIMITED06 mar 199006 mar 1990

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PRC PUBLISHING LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta29 feb 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PRC PUBLISHING LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 06 mar 2017 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 13

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 12

    1 páginasMR04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 feb 2016

    7 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de 1 Gower Street London WC1E 6HD a 43 Great Ormond Street London WC1N 3HZ el 24 nov 2016

    1 páginasAD01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 24 ago 2016

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Reduce share prem a/c 17/08/2016
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Déclaration annuelle établie au 06 mar 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital07 mar 2016

    Estado de capital el 07 mar 2016

    • Capital: GBP 110,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2015

    7 páginasAA

    Nombramiento de Mrs Zana Samantha Hanks como secretario el 19 may 2015

    2 páginasAP03

    Déclaration annuelle établie au 06 mar 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 abr 2015

    Estado de capital el 02 abr 2015

    • Capital: GBP 110,000
    SH01

    Cese del nombramiento de Allan Conan Sams como secretario el 26 mar 2015

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Allan Conan Sams como secretario el 26 mar 2015

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2014

    7 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de * Old Magistrates Court 10 Southcombe Street London W14 0RA* el 07 jul 2014

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 06 mar 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital17 abr 2014

    Estado de capital el 17 abr 2014

    • Capital: GBP 110,000
    SH01

    Cese del nombramiento de Robin Wood como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David Proffit como director

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2013

    7 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de PRC PUBLISHING LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HANKS, Zana Samantha
    Great Ormond Street
    WC1N 3HZ London
    43
    England
    Secretario
    Great Ormond Street
    WC1N 3HZ London
    43
    England
    197807060001
    POWELL, Polly Augusta Marchant
    Great Ormond Street
    WC1N 3HZ London
    43
    England
    Director
    Great Ormond Street
    WC1N 3HZ London
    43
    England
    EnglandBritish110229300002
    HAILSTONE, Timothy
    10 Talbot Road
    Highgate
    N6 4QR London
    Secretario
    10 Talbot Road
    Highgate
    N6 4QR London
    British13509200001
    NESS, Robert James
    247 Icknield Way
    SG6 4UE Letchworth
    Hertfordshire
    Secretario
    247 Icknield Way
    SG6 4UE Letchworth
    Hertfordshire
    British33929080001
    PHILLIPS, Kevin
    45 Lower Street
    GU27 2NY Haslemere
    Surrey
    Secretario
    45 Lower Street
    GU27 2NY Haslemere
    Surrey
    British44857580002
    POTTERELL, Clive Ronald
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    Secretario
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    British3182530002
    RANDS, Neil David George
    151 Abbotts Drive
    HA0 3SH North Wembley
    Middlesex
    Secretario
    151 Abbotts Drive
    HA0 3SH North Wembley
    Middlesex
    British21966770002
    SAMS, Allan Conan
    Gower Street
    WC1E 6HD London
    1
    England
    Secretario
    Gower Street
    WC1E 6HD London
    1
    England
    British107693020001
    WOOD, Robin Lee Knoyle
    55 Trinity Road
    SW19 8QY Wimbledon
    Secretario
    55 Trinity Road
    SW19 8QY Wimbledon
    British110229220004
    BARRY, Stephen Jeffrey
    3 Darnley Terrace
    W11 4RL London
    Director
    3 Darnley Terrace
    W11 4RL London
    British24468010001
    BROWN, Cameron Michael
    10 Hillside
    SW19 4NH London
    Director
    10 Hillside
    SW19 4NH London
    United KingdomBritish1654670001
    BUTTERFIELD, Nigel Robert Adamson
    Bullrush Farm Hillgrove
    Lurgashall
    GU28 9EP Petworth
    West Sussex
    Director
    Bullrush Farm Hillgrove
    Lurgashall
    GU28 9EP Petworth
    West Sussex
    United KingdomBritish36186210001
    COLLINS, Samuel Alexander Mark
    71 Cadogan Square
    SW1 London
    Director
    71 Cadogan Square
    SW1 London
    British63626140001
    HAILSTONE, Timothy
    Flat 6 28 Colville Road
    W11 2BS London
    Director
    Flat 6 28 Colville Road
    W11 2BS London
    British13509200002
    JAITLY, Suneel
    27 Ferndown Gardens
    KT11 2BH Cobham
    Surrey
    Director
    27 Ferndown Gardens
    KT11 2BH Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish44857620002
    LASSMAN, Peter
    Arkley Manor Rowley Lane
    Arkley
    EN5 3HS Barnet
    Hertfordshire
    Director
    Arkley Manor Rowley Lane
    Arkley
    EN5 3HS Barnet
    Hertfordshire
    EnglandBritish3374500001
    LEAVER, Marcus Edward
    39 Faroe Road
    W14 0EL London
    Director
    39 Faroe Road
    W14 0EL London
    British76685980003
    LENTON, Paul Richard
    27 Great Bushey Drive
    Totteridge
    N20 8QN London
    Director
    27 Great Bushey Drive
    Totteridge
    N20 8QN London
    EnglandBritish82173510001
    MESSHAM, Joanne
    9 Ebner Street
    Wandsworth
    SW18 1BT London
    Director
    9 Ebner Street
    Wandsworth
    SW18 1BT London
    British41015430002
    NEEDLEMAN, John Elliot
    Kerry 20 Christchurch Crescent
    WD7 8AH Radlett
    Hertfordshire
    Director
    Kerry 20 Christchurch Crescent
    WD7 8AH Radlett
    Hertfordshire
    British20117690001
    NESS, Robert James
    247 Icknield Way
    SG6 4UE Letchworth
    Hertfordshire
    Director
    247 Icknield Way
    SG6 4UE Letchworth
    Hertfordshire
    EnglandBritish33929080001
    PHILLIPS, Kevin
    45 Lower Street
    GU27 2NY Haslemere
    Surrey
    Director
    45 Lower Street
    GU27 2NY Haslemere
    Surrey
    British44857580002
    PROFFIT, David Macer, Mr.
    Old Magistrates Court
    10 Southcombe Street
    W14 0RA London
    Director
    Old Magistrates Court
    10 Southcombe Street
    W14 0RA London
    United KingdomBritish109190190002
    SANDERSON, Charles
    105 Castlehaven Road
    Camden
    NW1 8SJ London
    Director
    105 Castlehaven Road
    Camden
    NW1 8SJ London
    British88028580001
    SIMPSON, Lisa Mary
    45 Lower Street
    GU27 2NY Haslemere
    Surrey
    Director
    45 Lower Street
    GU27 2NY Haslemere
    Surrey
    British74052460002
    STRACHAN, David Alistair
    Summerhill Cottage Summerhill Road
    DA1 2LP Dartford
    Kent
    Director
    Summerhill Cottage Summerhill Road
    DA1 2LP Dartford
    Kent
    United KingdomBritish56866560001
    WOOD, Robin Lee Knoyle
    Old Magistrates Court
    10 Southcombe Street
    W14 0RA London
    Director
    Old Magistrates Court
    10 Southcombe Street
    W14 0RA London
    UkBritish110229220004

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de PRC PUBLISHING LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Mrs Polly Augusta Marchant Powell
    Great Ormond Street
    WC1N 3HZ London
    43
    England
    06 abr 2016
    Great Ormond Street
    WC1N 3HZ London
    43
    England
    No
    Nacionalidad: British
    País de residencia: England
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre las actividades de una firma que, según la ley que la rige, no es una persona jurídica; y los miembros de esa firma (en su calidad como tales) tienen el derecho de ejercer, o realmente ejercen, una influencia o control significativo sobre la empresa.

    ¿Tiene PRC PUBLISHING LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee & debenture
    Creado el 13 mar 2007
    Entregado el 16 mar 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 16 mar 2007Registro de un cargo (395)
    • 13 feb 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 23 nov 2005
    Entregado el 09 dic 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Chrysalis Group PLC
    Transacciones
    • 09 dic 2005Registro de un cargo (395)
    • 13 feb 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 09 abr 2001
    Entregado el 26 abr 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the composite guarantee and debenture
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Chrysalis Books PLC
    Transacciones
    • 26 abr 2001Registro de un cargo (395)
    • 25 nov 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 21 jun 2000
    Entregado el 24 jun 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Conance Limited
    Transacciones
    • 24 jun 2000Registro de un cargo (395)
    • 19 abr 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 01 oct 1999
    Entregado el 20 oct 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Euro Sales Finance PLC
    Transacciones
    • 20 oct 1999Registro de un cargo (395)
    • 14 oct 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture deed
    Creado el 02 sept 1998
    Entregado el 10 sept 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 10 sept 1998Registro de un cargo (395)
    • 01 jul 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Stock trust deed and charge over assets
    Creado el 22 abr 1997
    Entregado el 01 may 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    In favour of the chargee all monies due in relation to the £367,000 10% fixed rate loan stock issued by the company and secured by the charge
    Breve descripción
    By way of a fixed charge all intellectual property rights belonging to the company. By way of a floating charge the company's undertaking and all their other property assets and undertakings both present and future including any uncalled capital together with any assets and rights mortgaged or charged under the fixed charge if and so far as such mortgage or charge is ineffective as a fixed charge.
    Personas con derecho
    • Limecourt Investments Limited
    Transacciones
    • 01 may 1997Registro de un cargo (395)
    • 01 jul 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creado el 22 dic 1995
    Entregado el 05 ene 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a lease of even date
    Breve descripción
    The initial rent deposit of £8,821 plus accrued net interest.
    Personas con derecho
    • Kestrel Properties Limited
    Transacciones
    • 05 ene 1996Registro de un cargo (395)
    • 25 nov 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 05 oct 1995
    Entregado el 07 oct 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Coutts & Co.
    Transacciones
    • 07 oct 1995Registro de un cargo (395)
    • 14 ago 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit account agreement
    Creado el 28 feb 1995
    Entregado el 03 mar 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the lease of even date
    Breve descripción
    All monies standing to the credit of the rent deposit account opened pursuant to the terms of this deed.
    Personas con derecho
    • Cadogan Estates Limited
    Transacciones
    • 03 mar 1995Registro de un cargo (395)
    • 25 nov 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 26 jul 1994
    Entregado el 02 ago 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 02 ago 1994Registro de un cargo (395)
    • 18 oct 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit account agreement
    Creado el 17 nov 1992
    Entregado el 19 nov 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 14/11/92
    Breve descripción
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 17TH november 1992.
    Personas con derecho
    • Cadogan Estates Limited
    Transacciones
    • 19 nov 1992Registro de un cargo (395)
    • 25 nov 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 04 jul 1991
    Entregado el 19 jul 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Please see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 19 jul 1991Registro de una carga
    • 26 oct 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0